METALRAX LIMITED
Überblick
Unternehmensname | METALRAX LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03100571 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von METALRAX LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich METALRAX LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Rectory Court Old Rectory Lane Alvechurch B48 7SX Birmingham West Midlands England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von METALRAX LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MAKESPACE MEZZANINE FLOORS LIMITED | 11. Sept. 1995 | 11. Sept. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von METALRAX LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für METALRAX LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Andrew John Richardson am 17. Aug. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Andrew John Richardson am 14. Nov. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mrs Caroline Inez Green als Direktor am 13. Jan. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Longley als Sekretär am 28. Sept. 2012 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Longley als Geschäftsführer am 28. Sept. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Andrew John Richardson am 17. Aug. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Metalrax Group Plc, Ardath Road, Kings Norton Birmingham West Midlands B38 9PN am 30. Nov. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed makespace mezzanine floors LIMITED\certificate issued on 29/09/10 | 2 Seiten | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Nicholas Longley als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Nicholas Longley als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Stock als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Stock als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 17 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
|
Wer sind die Geschäftsführer von METALRAX LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREEN, Caroline Inez | Geschäftsführer | Old Rectory Lane Alvechurch B48 7SX Birmingham Rectory Court West Midlands England | United Kingdom | British | Finance Director | 174414810001 | ||||
RICHARDSON, Andrew John | Geschäftsführer | Old Rectory Lane Alvechurch B48 7SX Birmingham Rectory Court West Midlands England | England | British | Director | 132142760002 | ||||
FARRIMOND, Darren James | Sekretär | 5 Marsh Way Catshill B61 0JD Bromsgrove | British | 96411190001 | ||||||
LONGLEY, Nicholas | Sekretär | Ardath Road Kings Norton B38 9PN Birmingham Ardath Road England | 147393330001 | |||||||
RAYNER, Nicholas John | Sekretär | 53 Woolram Wygate PE11 1PB Spalding Lincolnshire | British | Financial Director | 23982070001 | |||||
STOCK, Michael John | Sekretär | WR9 7NH Tibberton Foredraught House Worcs | British | Director | 129726080001 | |||||
HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
ARBUTHNOT, Richard | Geschäftsführer | 101 Dorridge Road Dorridge B93 8BS Solihull West Midlands | British | Directors | 67470540001 | |||||
BROOK-CARTER, Ronald Hedley | Geschäftsführer | Longacre Rowney Green Lane Alvechurch B48 7QF Birmingham West Midlands | United Kingdom | British | Director | 12720220001 | ||||
LONGLEY, Nicholas | Geschäftsführer | Ardath Road Kings Norton B38 9PN Birmingham Ardath Road England | England | British | Group Financial Controller | 147396410001 | ||||
RAYNER, Nicholas John | Geschäftsführer | 53 Woolram Wygate PE11 1PB Spalding Lincolnshire | United Kingdom | British | Financial Director | 23982070001 | ||||
RIDLEY, Graham Peter | Geschäftsführer | 14 High Street PE11 1TW Spalding Lincolnshire | British | Managing Director | 44673650007 | |||||
STOCK, Michael John | Geschäftsführer | WR9 7NH Tibberton Foredraught House Worcs | England | British | Director | 129726080001 | ||||
HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Hat METALRAX LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 12. Okt. 2009 Geliefert am 21. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any present or future group company to the security trustee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A composite guarantee and debenture | Erstellt am 12. Okt. 2009 Geliefert am 19. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 04. Sept. 2002 Geliefert am 14. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units 1A, 1B, 2A and 2B millfield road, donington, lincolnshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 30. Jan. 1996 Geliefert am 09. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0