SUPERIOR PRODUCE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SUPERIOR PRODUCE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03107069 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SUPERIOR PRODUCE LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich SUPERIOR PRODUCE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2 The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SUPERIOR PRODUCE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| GROWERS CHOICE LIMITED | 05. Dez. 1995 | 05. Dez. 1995 |
| GREENSENSE LIMITED | 27. Sept. 1995 | 27. Sept. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SUPERIOR PRODUCE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. März 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SUPERIOR PRODUCE LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für SUPERIOR PRODUCE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. März 2014 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 11 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Food Partners House Poyle Road Colnbrook Slough SL3 0QX England* am 10. Sept. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. März 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Thomas als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2012 bis 31. März 2013 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steve Wood als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Gavin Cox am 01. Nov. 2011 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Steve Wood am 01. Nov. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Gavin Cox am 01. Nov. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Thomas am 01. Nov. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Food Partners House Poyle Road Colnbrook, Slough England SL3 0EN England* am 13. Nov. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 01. Okt. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Widerruf des Antrags auf Löschung der Gesellschaft | 2 Seiten | DS02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SUPERIOR PRODUCE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COX, Gavin | Sekretär | The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow 2 England | 165756720001 | |||||||
| COX, Gavin Eliot | Geschäftsführer | The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow 2 England | United Kingdom | British | 153840250001 | |||||
| MOMEN, Julian Akhtar Karim | Sekretär | Tanners Drive MK14 5BN Blakelands 28 Milton Keynes | British | 150501100001 | ||||||
| TAYLOR, Michael Dennis | Sekretär | Woodstock Dukes Ride SL9 7LD Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 18385410004 | ||||||
| VINCENT, Guy Wyndham | Sekretär | 50 Broadway SW1H 0BL London | British | 70893430002 | ||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Sekretär | One London Wall EC2Y 5AB London | 116685100001 | |||||||
| SECRETAIRE LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 3rd Floor 2 Luke Street EC2A 4NT London | 900011490001 | |||||||
| BROWN, Kevin Thomas | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 30 Harts Grove IG8 0BN Woodford Green Essex | England | British | 900008020001 | |||||
| CHISAMBI, Rodgers Yalamila | Geschäftsführer | Flat 7 30 Longridge Road SW5 9SJ Earls Court London | Zambian | 77986900001 | ||||||
| FEE, Paul | Geschäftsführer | 285 Yorktown Road College Town GU47 0QA Sandhurst Berkshire | British | 55281590001 | ||||||
| GUY, David Simon | Geschäftsführer | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 United Kingdom | British | 119214340001 | ||||||
| HALL, Fraser Scott | Geschäftsführer | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 United Kingdom | British | 4578740001 | ||||||
| HAZELDEAN, William James | Geschäftsführer | 6a Balmoral Court Gleneagles Village PH3 1SH Auchterarder Perthshire | Scotland | British | 83660790002 | |||||
| KINGSLEY BATES, Paul | Geschäftsführer | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 United Kingdom | United Kingdom | British | 132962170001 | |||||
| MCLELLAND, Stewart | Geschäftsführer | 36 East Craigs Rigg EH12 8JA Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 157009150001 | |||||
| MELLORS, William Peter Stewart | Geschäftsführer | 5 Limetree Court 103 Straight Road SL4 2SS Old Windsor Berkshire | British | 107055640001 | ||||||
| MOMEN, Julian Akhtar Karim | Geschäftsführer | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 United Kingdom | England | British | 51784930002 | |||||
| NELSON, Finlay Macarthur | Geschäftsführer | Stamford Road Barnack PE9 3HA Stamford Quarry House Lincolnshire | England | British | 132363820001 | |||||
| NUDDS, Anthony John | Geschäftsführer | 8 Tawny Close TW13 7LH Feltham Middlesex | British | 62512350001 | ||||||
| NUDDS, Anthony John | Geschäftsführer | 8 Tawny Close TW13 7LH Feltham Middlesex | British | 62512350001 | ||||||
| POCOCK, Patrick William | Geschäftsführer | The Steadings Woodside Of Cloghill, Kingswells AB15 8SA Aberdeen | British | 96978470001 | ||||||
| SINCLAIR, John Frederick | Geschäftsführer | 16 Old Coastguard Road Sandbanks BH13 7RL Poole Dorset | British | 46006710001 | ||||||
| SMITH, Andrew Macdonald | Geschäftsführer | Chimneys Westbury Road BR1 2QB Bromley Kent | British | 74660050001 | ||||||
| TAYLOR, Agatha | Geschäftsführer | Woodstock Dukes Ride SL9 7LD Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 58350880001 | ||||||
| TAYLOR, Michael Dennis | Geschäftsführer | Woodstock Dukes Ride SL9 7LD Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 18385410004 | ||||||
| THOMAS, Christopher | Geschäftsführer | Poyle Road Colnbrook SL3 0QX Slough Food Partners House England | England | British | 63844650001 | |||||
| TRUELOVE, Amelia Anne | Geschäftsführer | Bentley Hall Fenny Bentley DE6 1LE Ashbourne Derbyshire | British | 37845970003 | ||||||
| WEBB, Robert John | Geschäftsführer | 5 Underwood Cottages The Coombe, Streatley RG8 9RA Reading Berkshire | British | 65669490001 | ||||||
| WOOD, Steven John | Geschäftsführer | Poyle Road Colnbrook SL3 0QX Slough Food Partners House England | United Kingdom | British | 232132390001 | |||||
| WORT, Edward George | Geschäftsführer | 28 Crown Meadow Colnbrook SL3 0LT Slough Berkshire | British | 77987180001 |
Hat SUPERIOR PRODUCE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 21. Apr. 2008 Geliefert am 02. Mai 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture accession deed | Erstellt am 16. Feb. 2007 Geliefert am 05. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its right title and interest in and to the property assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 08. Jan. 2004 Geliefert am 10. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 23. März 1999 Geliefert am 01. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Dez. 1996 Geliefert am 07. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H or l/h property k/a units 187-189 and 190-192A western international market heston l/b of hounslow & all buildings & structures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 13. Dez. 1995 Geliefert am 19. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0