SHL (UK) LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSHL (UK) LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03109066
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SHL (UK) LTD?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich SHL (UK) LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SHL (UK) LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SAVILLE & HOLDSWORTH (UK) LIMITED11. Dez. 199511. Dez. 1995
    STUDIOPRICE LIMITED02. Okt. 199502. Okt. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SHL (UK) LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SHL (UK) LTD?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für SHL (UK) LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    4 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 01. Mai 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Catherine Phillips als Geschäftsführer am 31. Juli 2013

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    5 SeitenAA

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Beendigung der Bestellung von Catherine Phillips als Sekretär am 31. Juli 2013

    1 SeitenTM02

    Ernennung von David Edward Ryell als Direktor am 31. Juli 2013

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Emma Voirrey Lancaster als Geschäftsführer am 27. Nov. 2012

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Martin David Franks als Direktor am 27. Nov. 2012

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Catherine Phillips als Sekretär am 01. Juni 2012

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Suzanna Barrett als Sekretär am 01. Juni 2012

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Suzanna Barrett als Geschäftsführer am 01. Juni 2012

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Catherine Phillips als Direktor am 01. Juni 2012

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Emma Voirrey Lancaster am 10. Feb. 2012

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Suzanna Barrett am 10. Feb. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    legacy

    7 SeitenMG01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    15 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von SHL (UK) LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FRANKS, Martin David
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    EnglandBritish173954290001
    RYELL, David Edward
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    EnglandBritish180882130001
    BARRETT, Suzanna
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Sekretär
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    British106880710002
    BURNIP, Alexandra Elizabeth
    7 Oatlands Close
    KT13 9ED Weybridge
    Surrey
    Sekretär
    7 Oatlands Close
    KT13 9ED Weybridge
    Surrey
    British12239690001
    CADMAN, John William
    42 Albert Road
    South Woodford
    E18 1LE London
    Sekretär
    42 Albert Road
    South Woodford
    E18 1LE London
    British66894390001
    EVANS, Paul Anthony James
    24 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    Sekretär
    24 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    British38068300001
    PHILLIPS, Catherine
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Sekretär
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    170384570001
    PRICE, David Robert
    1 Titchfield Close
    RH15 0RX Burgess Hill
    West Sussex
    Sekretär
    1 Titchfield Close
    RH15 0RX Burgess Hill
    West Sussex
    British76272880001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AUSTIN, Roger John
    57 Howards Wood Drive
    SL9 7HS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    57 Howards Wood Drive
    SL9 7HS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British67674990001
    BARRETT, Suzanna
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    EnglandBritish106880710002
    BURGE, Alan
    Home Farm Close
    BA14 6AH Steeple Ashton
    5
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Home Farm Close
    BA14 6AH Steeple Ashton
    5
    Wiltshire
    United KingdomBritish197259620001
    BURNIP, Alexandra Elizabeth
    7 Oatlands Close
    KT13 9ED Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    7 Oatlands Close
    KT13 9ED Weybridge
    Surrey
    British12239690001
    CADMAN, John William
    42 Albert Road
    South Woodford
    E18 1LE London
    Geschäftsführer
    42 Albert Road
    South Woodford
    E18 1LE London
    British66894390001
    CRAMP, Elisabeth Lyndsay
    4 Claremont End
    KT10 9LZ Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    4 Claremont End
    KT10 9LZ Esher
    Surrey
    EnglandBritish97695420001
    GREGORY, Roger William
    26 Magnus Drive
    Hatch Warren
    RG22 4TX Basingstoke
    Hampshire
    Geschäftsführer
    26 Magnus Drive
    Hatch Warren
    RG22 4TX Basingstoke
    Hampshire
    British59500110001
    HOLDSWORTH, Roger Francis
    Parc St Roman,
    7 Avenue Saint Roman
    FOREIGN Monaco
    98000
    Monaco
    Geschäftsführer
    Parc St Roman,
    7 Avenue Saint Roman
    FOREIGN Monaco
    98000
    Monaco
    British112662000001
    HOWARD, Simon John
    107 Bridge House
    Saint George Wharf
    SW8 2LQ London
    Geschäftsführer
    107 Bridge House
    Saint George Wharf
    SW8 2LQ London
    United KingdomBritish73313240006
    LANCASTER, Emma Voirrey
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    United KingdomBritish79034410005
    MABEY, William
    Sunnyfields Meadowside
    Bookham
    KT23 3LF Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Sunnyfields Meadowside
    Bookham
    KT23 3LF Leatherhead
    Surrey
    British12239710001
    PHILLIPS, Catherine
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    United KingdomBritish170338110001
    PRICE, David Robert
    1 Titchfield Close
    RH15 0RX Burgess Hill
    West Sussex
    Geschäftsführer
    1 Titchfield Close
    RH15 0RX Burgess Hill
    West Sussex
    British76272880001
    SAVILLE, Peter Francis, Dr
    Wildacre
    21 Esher Park
    KT10 9NX Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    Wildacre
    21 Esher Park
    KT10 9NX Esher
    Surrey
    British12239700001
    STEVENSON, Hazel Helena
    70 Seymour Avenue
    Ewell
    KT17 2RR Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    70 Seymour Avenue
    Ewell
    KT17 2RR Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish51232470001
    VAN RAAY, Paul Bernard
    Velsgoed 24
    Prinsenbeek
    4841el
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Velsgoed 24
    Prinsenbeek
    4841el
    Netherlands
    Dutch90966240001
    VISSER, Gerbrand Joannes Antonius
    Watertuin 27
    3648GA De Ronde Venen
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Watertuin 27
    3648GA De Ronde Venen
    Netherlands
    Dutch51232680001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat SHL (UK) LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 10. Jan. 2011
    Geliefert am 15. Jan. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cit Capital Finance (UK) Limited
    Transaktionen
    • 15. Jan. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    A share pledge agreement
    Erstellt am 27. März 2009
    Geliefert am 06. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of the obligors to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The pledgors have pledged the 12,434 shares no.1 To 12,434 shares inclusive held by shl people solutions group holdings limited and one share no.12,435 Held by the company in shl belgium sa and any other shares in shl belgium that they may subscribe to or acquire in the future see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cit Capital Finance (UK) Limited Acting for Itself and for the Account of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 27. März 2009
    Geliefert am 06. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cit Capital Finance (UK) Limited as Trustee for Itself and the Other Persons (the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 31. Jan. 2007
    Geliefert am 07. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cit Capital Finance (UK) Limited in Its Capacity Trustee
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 19. Aug. 1997
    Geliefert am 08. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the debenture
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 16. Jan. 1997
    Geliefert am 22. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0