SHL (UK) LTD
Überblick
| Unternehmensname | SHL (UK) LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03109066 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SHL (UK) LTD?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich SHL (UK) LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SHL (UK) LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SAVILLE & HOLDSWORTH (UK) LIMITED | 11. Dez. 1995 | 11. Dez. 1995 |
| STUDIOPRICE LIMITED | 02. Okt. 1995 | 02. Okt. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SHL (UK) LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SHL (UK) LTD?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für SHL (UK) LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Catherine Phillips als Geschäftsführer am 31. Juli 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Catherine Phillips als Sekretär am 31. Juli 2013 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von David Edward Ryell als Direktor am 31. Juli 2013 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Emma Voirrey Lancaster als Geschäftsführer am 27. Nov. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Martin David Franks als Direktor am 27. Nov. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Catherine Phillips als Sekretär am 01. Juni 2012 | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Suzanna Barrett als Sekretär am 01. Juni 2012 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Suzanna Barrett als Geschäftsführer am 01. Juni 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Catherine Phillips als Direktor am 01. Juni 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Emma Voirrey Lancaster am 10. Feb. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Suzanna Barrett am 10. Feb. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SHL (UK) LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKS, Martin David | Geschäftsführer | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | England | British | 173954290001 | |||||
| RYELL, David Edward | Geschäftsführer | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | England | British | 180882130001 | |||||
| BARRETT, Suzanna | Sekretär | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | British | 106880710002 | ||||||
| BURNIP, Alexandra Elizabeth | Sekretär | 7 Oatlands Close KT13 9ED Weybridge Surrey | British | 12239690001 | ||||||
| CADMAN, John William | Sekretär | 42 Albert Road South Woodford E18 1LE London | British | 66894390001 | ||||||
| EVANS, Paul Anthony James | Sekretär | 24 Fiddicroft Avenue SM7 3AD Banstead Surrey | British | 38068300001 | ||||||
| PHILLIPS, Catherine | Sekretär | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | 170384570001 | |||||||
| PRICE, David Robert | Sekretär | 1 Titchfield Close RH15 0RX Burgess Hill West Sussex | British | 76272880001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| AUSTIN, Roger John | Geschäftsführer | 57 Howards Wood Drive SL9 7HS Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 67674990001 | ||||||
| BARRETT, Suzanna | Geschäftsführer | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | England | British | 106880710002 | |||||
| BURGE, Alan | Geschäftsführer | Home Farm Close BA14 6AH Steeple Ashton 5 Wiltshire | United Kingdom | British | 197259620001 | |||||
| BURNIP, Alexandra Elizabeth | Geschäftsführer | 7 Oatlands Close KT13 9ED Weybridge Surrey | British | 12239690001 | ||||||
| CADMAN, John William | Geschäftsführer | 42 Albert Road South Woodford E18 1LE London | British | 66894390001 | ||||||
| CRAMP, Elisabeth Lyndsay | Geschäftsführer | 4 Claremont End KT10 9LZ Esher Surrey | England | British | 97695420001 | |||||
| GREGORY, Roger William | Geschäftsführer | 26 Magnus Drive Hatch Warren RG22 4TX Basingstoke Hampshire | British | 59500110001 | ||||||
| HOLDSWORTH, Roger Francis | Geschäftsführer | Parc St Roman, 7 Avenue Saint Roman FOREIGN Monaco 98000 Monaco | British | 112662000001 | ||||||
| HOWARD, Simon John | Geschäftsführer | 107 Bridge House Saint George Wharf SW8 2LQ London | United Kingdom | British | 73313240006 | |||||
| LANCASTER, Emma Voirrey | Geschäftsführer | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | United Kingdom | British | 79034410005 | |||||
| MABEY, William | Geschäftsführer | Sunnyfields Meadowside Bookham KT23 3LF Leatherhead Surrey | British | 12239710001 | ||||||
| PHILLIPS, Catherine | Geschäftsführer | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | United Kingdom | British | 170338110001 | |||||
| PRICE, David Robert | Geschäftsführer | 1 Titchfield Close RH15 0RX Burgess Hill West Sussex | British | 76272880001 | ||||||
| SAVILLE, Peter Francis, Dr | Geschäftsführer | Wildacre 21 Esher Park KT10 9NX Esher Surrey | British | 12239700001 | ||||||
| STEVENSON, Hazel Helena | Geschäftsführer | 70 Seymour Avenue Ewell KT17 2RR Epsom Surrey | United Kingdom | British | 51232470001 | |||||
| VAN RAAY, Paul Bernard | Geschäftsführer | Velsgoed 24 Prinsenbeek 4841el Netherlands | Dutch | 90966240001 | ||||||
| VISSER, Gerbrand Joannes Antonius | Geschäftsführer | Watertuin 27 3648GA De Ronde Venen Netherlands | Dutch | 51232680001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat SHL (UK) LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 10. Jan. 2011 Geliefert am 15. Jan. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A share pledge agreement | Erstellt am 27. März 2009 Geliefert am 06. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of the obligors to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The pledgors have pledged the 12,434 shares no.1 To 12,434 shares inclusive held by shl people solutions group holdings limited and one share no.12,435 Held by the company in shl belgium sa and any other shares in shl belgium that they may subscribe to or acquire in the future see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. März 2009 Geliefert am 06. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Jan. 2007 Geliefert am 07. Feb. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 19. Aug. 1997 Geliefert am 08. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the debenture | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 16. Jan. 1997 Geliefert am 22. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0