REBUS GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | REBUS GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03109650 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von REBUS GROUP LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich REBUS GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Corporation Service Company (Uk) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor E14 5HU London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von REBUS GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| RICHTRACK PUBLIC LIMITED COMPANY | 03. Okt. 1995 | 03. Okt. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von REBUS GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für REBUS GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT1 | ||||||||||
Notification of a person with significant control statement | 2 Seiten | PSC08 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Cessation of Stephen Allen Schwarzman as a person with significant control on 06. Juli 2021 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 07. Mai 2021
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 58 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT1 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Apr. 2021 bis 31. Dez. 2020 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Stephen Allen Schwarzman as a person with significant control on 04. Nov. 2019 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Cessation of Rebus Hr Holdings Limited as a person with significant control on 04. Nov. 2019 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 4NW zum C/O Corporation Service Company (Uk) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor London E14 5HU am 04. Nov. 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Phillip Monshaw als Geschäftsführer am 21. Okt. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Malcolm Robert Bennett als Sekretär am 10. Juli 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven James Chalker als Geschäftsführer am 30. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Gillian Tiffney Gilliat Nolan als Direktor am 30. Juni 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von REBUS GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOLAN, Gillian Tiffney Gilliatt | Geschäftsführer | 5 Churchill Place, 10th Floor E14 5HU London C/O Corporation Service Company (Uk) Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 271694390001 | |||||
| BENNETT, Malcolm Robert | Sekretär | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | 208002930001 | |||||||
| FARRIMOND, Nicholas Brian | Sekretär | 51 The Avenue WD17 4NU Watford Hertfordshire | British | 75357260001 | ||||||
| LONEY, Nicholas John | Sekretär | 31 Viewfield Road Southfields SW18 5JD London | British | 8511300001 | ||||||
| MEADES, Derek Leslie | Sekretär | Alfriston House The Avenue SL5 7LY Ascot Berkshire | British | 8142960002 | ||||||
| NUNN, Carol Jayne | Sekretär | Boundary Way HP2 7HU Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 101872040001 | ||||||
| RICHARDSON, John David | Sekretär | High Street Burnham SL1 7JD Slough 27 Berks | British | 128558470001 | ||||||
| SCHENCK, Daniel William | Sekretär | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | Usa | 181204960001 | ||||||
| SCORE, Timothy | Sekretär | Chestnut Farmhouse Aylesbury Road HP27 0JT Monks Risborough Buckinghamshire | British | 103319060001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| AL-SALEH, Adel Bedry | Geschäftsführer | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | United States | American | 165900220001 | |||||
| BIDWELL, Hugh Charles Philip, Sir | Geschäftsführer | The Parsonage Goodnestone CT3 1PJ Canterbury Kent | British | 58932210001 | ||||||
| BURTON, Michael John | Geschäftsführer | 4a Langton Way SE3 7TL London | British | 63922600001 | ||||||
| CHALKER, Steven James | Geschäftsführer | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 221085650001 | |||||
| COTTAM, Harold, Managing Director | Geschäftsführer | Pentwyn Farm Dorstone HR3 6AD Hereford | United Kingdom | British | 32116700002 | |||||
| DENLEY, Gareth Phillip | Geschäftsführer | 31 Ashley Road KT12 1JB Walton On Thames Surrey | British | 38711220001 | ||||||
| GREAVES, Andrew David | Geschäftsführer | Wood End Cottage Wood Lane SL2 3YY Hedgerley Buckinghamshire | British | 50048250001 | ||||||
| HELLER, Robert Gordon Barry | Geschäftsführer | 53 Fitzroy Park N6 6JA London | British | 2883040001 | ||||||
| HODGSON, David Charles | Geschäftsführer | 755 Park Avenue New York 10021 Usa | American | 63989560001 | ||||||
| LAKING, David Albert | Geschäftsführer | 33 Station Road Nassington PE8 6QB Peterborough Cambridgeshire | United Kingdom | British | 82424930001 | |||||
| LONEY, Nicholas John | Geschäftsführer | 31 Viewfield Road Southfields SW18 5JD London | British | 8511300001 | ||||||
| MCKINLEY, Edward Joseph | Geschäftsführer | The Priory 3a Seymour Walk SW10 9NF London | American | 38853950001 | ||||||
| MEADES, Derek Leslie | Geschäftsführer | Alfriston House The Avenue SL5 7LY Ascot Berkshire | British | 8142960002 | ||||||
| MONSHAW, Andrew Phillip | Geschäftsführer | Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Herts | United States | American | 239664830001 | |||||
| PRESLAND, Peter Eric | Geschäftsführer | Rats Castle Castletons Oak Cranbrook Road TN27 8DY Biddenden Ashford Kent | England | British | 7649630002 | |||||
| ROSS, Stuart | Geschäftsführer | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 20168110001 | |||||
| SCORE, Timothy | Geschäftsführer | Chestnut Farmhouse Aylesbury Road HP27 0JT Monks Risborough Buckinghamshire | British | 103319060001 | ||||||
| SEED, John Junior | Geschäftsführer | Highfield House North Road BA2 6HW Bath Bath & North East Somerset | British | 8670120001 | ||||||
| STIER, John Robert | Geschäftsführer | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 78901530003 | |||||
| STONE, Christopher Michael Renwick | Geschäftsführer | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 66955690003 | |||||
| SUMMERS, Roger Denis | Geschäftsführer | 15 Five Acres Danbury CM3 4NB Chelmsford Essex | British | 8559710001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei REBUS GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Stephen Allen Schwarzman | 04. Nov. 2019 | Park Ave NY 10154 New York 345 United States | Ja | ||||||||||
Nationalität: American Staatsangehörigkeit: United States | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Rebus Hr Holdings Limited | 03. Okt. 2016 | Peoplebuilding Estate, Maylands Avenue Hemel Hempstead Industrial Estate HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für REBUS GROUP LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 06. Juli 2021 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat REBUS GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 20. Juni 2016 Geliefert am 23. Juni 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Nil. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A grant of security interest in trademark rights | Erstellt am 19. Apr. 2011 Geliefert am 04. Mai 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in, to and under the trademarks being- star design reg no: 2,940,278 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A grant of security interest in trademark rights | Erstellt am 19. Apr. 2011 Geliefert am 04. Mai 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in, to and under the trademarks being- star design, reg no:2,940,278 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Intellectual property security agreement | Erstellt am 19. Apr. 2011 Geliefert am 03. Mai 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Intellectual property being registered trademarks and trademark applications in rebus group limited, trademark star design, all proceeds and products of the foregoing, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of accession | Erstellt am 29. Apr. 2008 Geliefert am 12. Mai 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from that charging company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A supplemental debenture | Erstellt am 09. Juli 1999 Geliefert am 28. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined therein) | |
Kurze Angaben All freehold and leasehold property and all assets and undertakings. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 18. März 1999 Geliefert am 30. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the finance documents defined therein | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. März 1996 Geliefert am 27. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0