PARK ROW GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePARK ROW GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03109700
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PARK ROW GROUP LIMITED?

    • Tätigkeit von Holdinggesellschaften für Finanzdienstleistungen (64205) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich PARK ROW GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Central Square 8th Floor
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PARK ROW GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PARK ROW GROUP PLC07. Mai 200207. Mai 2002
    BIRCHIN INTERNATIONAL PLC19. Sept. 199719. Sept. 1997
    RUSHMERE WYNNE GROUP PLC28. Nov. 199528. Nov. 1995
    MARKETCOIN PUBLIC LIMITED COMPANY03. Okt. 199503. Okt. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PARK ROW GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für PARK ROW GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    17 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 24. Apr. 2017

    20 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Benson House 33 Wellington Street Leeds LS1 4JP zum Central Square 8th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL am 14. Okt. 2016

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 24. Apr. 2016

    17 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 24. Apr. 2015

    11 Seiten4.68

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    4 SeitenMR04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O C/O Ambant Limited Marlow House Fifth Floor 1a Lloyds Avenue London EC3N 3AA United Kingdom* am 27. Mai 2014

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Okt. 2013

    Kapitalaufstellung am 10. Okt. 2013

    • Kapital: GBP 70,728,395
    SH01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Ambant Limited Lloyds Avenue House 6 Lloyds Avenue London EC3N 3AX geändert

    1 SeitenAD02

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    27 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O 6Th Floor 14 South Parade Leeds West Yorkshire LS1 5QS United Kingdom* am 04. Dez. 2012

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    28 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Royal Liver Building Liverpool Merseyside L3 1HT* am 19. Apr. 2011

    1 SeitenAD01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    2 SeitenAD02

    Wer sind die Geschäftsführer von PARK ROW GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COPPELL, Helen
    Chalky Bank Road
    Rainham
    ME8 7NP Gillingham
    27
    Kent
    Sekretär
    Chalky Bank Road
    Rainham
    ME8 7NP Gillingham
    27
    Kent
    British159189030001
    CRABB, Steven Lee
    The Byeway
    WD31 1JW Rickmansworth
    2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Byeway
    WD31 1JW Rickmansworth
    2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish93134850002
    GRANT, Philip James
    Albury Road
    Furneux Pelham
    SG9 0LP Buntingford
    Clay Chimneys House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Albury Road
    Furneux Pelham
    SG9 0LP Buntingford
    Clay Chimneys House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish34492660002
    ADAMS, Derek Stanley
    Lane End
    Birch Green
    CO2 0NH Colchester
    Essex
    Sekretär
    Lane End
    Birch Green
    CO2 0NH Colchester
    Essex
    British45970110001
    CHAUDHRI, Farzana
    Oaklands
    Oudle Lane
    SG10 6DQ Much Hadham
    Hertfordshire
    Sekretär
    Oaklands
    Oudle Lane
    SG10 6DQ Much Hadham
    Hertfordshire
    British55239490003
    CONNOLLY, William Stephen
    3 Dodleston Close
    CH43 9QZ Birkenhead
    Merseyside
    Sekretär
    3 Dodleston Close
    CH43 9QZ Birkenhead
    Merseyside
    British86840740001
    LITTLE, David Anthony
    100 Kyrle Road
    SW11 6BA London
    Sekretär
    100 Kyrle Road
    SW11 6BA London
    British77215960002
    MARKS, David Jeffrey
    Virginia Lodge
    Royston Grove
    HA5 4HE Pinner
    Middlesex
    Sekretär
    Virginia Lodge
    Royston Grove
    HA5 4HE Pinner
    Middlesex
    British78129600001
    STEVENSON, Sandra Maureen
    197 Cotefield Drive
    LU7 8DW Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Sekretär
    197 Cotefield Drive
    LU7 8DW Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British48454410001
    EMCEE NOMINEES LIMITED
    First Floor 31 Southampton Row
    WC1B 5HT London
    Sekretär
    First Floor 31 Southampton Row
    WC1B 5HT London
    38708590001
    EPS SECRETARIES LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Sekretär
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    67339580001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ABBOTT, Richard David
    The Old Parsonage
    Church Street, Ropley
    SO24 0DS Hampshire
    Geschäftsführer
    The Old Parsonage
    Church Street, Ropley
    SO24 0DS Hampshire
    EnglandBritish78205110001
    ADAMS, Derek Stanley
    Lane End
    Birch Green
    CO2 0NH Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    Lane End
    Birch Green
    CO2 0NH Colchester
    Essex
    British45970110001
    ALBERGE, Maurice Ernest
    27 Glenloch Road
    NW3 4DJ London
    Geschäftsführer
    27 Glenloch Road
    NW3 4DJ London
    British49539510001
    ALLSUP, Mark William
    34 Dewhurst Road
    W14 0ES London
    Geschäftsführer
    34 Dewhurst Road
    W14 0ES London
    British42154290002
    BAILEY, Martin
    Daisybank Drive
    CW11 4JR Sandbach
    Heathside
    Cheshire
    England
    Geschäftsführer
    Daisybank Drive
    CW11 4JR Sandbach
    Heathside
    Cheshire
    England
    EnglandBritish95450450003
    BURNETT, Steven Robert
    The Belfry Northop Country Park
    Northop
    CH7 6WD Mold
    Flintshire
    Geschäftsführer
    The Belfry Northop Country Park
    Northop
    CH7 6WD Mold
    Flintshire
    United KingdomBritish56044450001
    BURR, Reginald Ivor
    21 St James Close
    Prince Albert Road St Johns Wood
    NW8 7LG London
    Geschäftsführer
    21 St James Close
    Prince Albert Road St Johns Wood
    NW8 7LG London
    British70371780001
    BURR, Rosemary Karen
    8 Hamilton House
    NW8 9PN London
    Geschäftsführer
    8 Hamilton House
    NW8 9PN London
    British15659480001
    DAVIES, Elzbieta Krystyna
    Gravee Du Sud
    The Grange
    GY1 1RP St Peter Port
    Guernsey
    Geschäftsführer
    Gravee Du Sud
    The Grange
    GY1 1RP St Peter Port
    Guernsey
    British115958830001
    DAVIES, John Hamilton
    Denbies
    Bardfield Saling
    CM7 5EG Braintree
    Essex
    Geschäftsführer
    Denbies
    Bardfield Saling
    CM7 5EG Braintree
    Essex
    EnglandBritish62682160001
    DENHEEN, Peter Gerard
    3 Pitcullen Terrace
    PH2 7EQ Perth
    Perthshire
    Geschäftsführer
    3 Pitcullen Terrace
    PH2 7EQ Perth
    Perthshire
    British112863220001
    DOBSON, Kevin James, Dr
    9 Harris Close
    Spital
    CH63 9YX Wirral
    Merseyside
    Geschäftsführer
    9 Harris Close
    Spital
    CH63 9YX Wirral
    Merseyside
    EnglandBritish69819530006
    DRURY, Anthony Charles
    39 Redwood Glade
    LU7 3JT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    39 Redwood Glade
    LU7 3JT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    EnglandBritish78025460001
    FITZSIMMONS, Edward
    91 Glenferness Avenue
    Talbot Woods
    BH3 7ES Bournemouth
    Dorset
    Geschäftsführer
    91 Glenferness Avenue
    Talbot Woods
    BH3 7ES Bournemouth
    Dorset
    EnglandBritish35037160002
    GARDENER, Edward Patrick Montgomery, Professor
    The Gables
    Gannock Park, Deganwy
    LL31 9PZ Conwy
    Gwynedd
    Geschäftsführer
    The Gables
    Gannock Park, Deganwy
    LL31 9PZ Conwy
    Gwynedd
    WalesBritish66368000001
    GARDNER, Colyn, Doctor
    5 Oakley Street
    SW3 5NN London
    Geschäftsführer
    5 Oakley Street
    SW3 5NN London
    British114586870001
    HARDY, Carol Margaret
    6 Bawson Court
    Gomersal
    BD19 4SA Cleckheaton
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    6 Bawson Court
    Gomersal
    BD19 4SA Cleckheaton
    West Yorkshire
    EnglandBritish89078690001
    LASSEN, Richard Guy
    The Coach House
    27 Southern Road
    SO41 9HR Lymington
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The Coach House
    27 Southern Road
    SO41 9HR Lymington
    Hampshire
    EnglandBritish111572370001
    MAPES, Pamela
    75 Greenside Road
    W12 9JQ London
    Geschäftsführer
    75 Greenside Road
    W12 9JQ London
    British60465150001
    MARKS, David Jeffrey
    Virginia Lodge
    Royston Grove
    HA5 4HE Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Virginia Lodge
    Royston Grove
    HA5 4HE Pinner
    Middlesex
    EnglandBritish78129600001
    MCGREGOR, George
    7 Westmoreland Road
    PR8 6NX Southport
    Merseyside
    Geschäftsführer
    7 Westmoreland Road
    PR8 6NX Southport
    Merseyside
    United KingdomBritish88000730002
    MCGREGOR, George
    94 Forest Road
    PR8 6HY Southport
    Merseyside
    Geschäftsführer
    94 Forest Road
    PR8 6HY Southport
    Merseyside
    British88000730001
    MINNS, Anthony Stirling
    Stoney Ridge House
    Headley Road Grayshott
    GU26 6DP Hindhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Stoney Ridge House
    Headley Road Grayshott
    GU26 6DP Hindhead
    Surrey
    United KingdomBritish1852650004

    Hat PARK ROW GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security over shares agreement
    Erstellt am 29. März 2011
    Geliefert am 04. Apr. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from ambant limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    40,849,000 ordinary shares of £1 of park row associates limited and the related assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Liver (Ifa Holdings) PLC
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 15. Apr. 2008
    Geliefert am 29. Apr. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £5875.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    £5875.00.
    Berechtigte Personen
    • Bw Sipp Trustees Limited
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities
    Erstellt am 11. Nov. 2002
    Geliefert am 18. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All stocks shares bonds debentures or other securities deposited with the bank and any bonus or other new securities and all rights,moneys or property accruing. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Nov. 2002
    Geliefert am 18. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as blue bridge house (essex); t/no EX431528.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 11. Nov. 2002
    Geliefert am 18. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due or to become due from the company (the "chargor") and by any other company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Aug. 2002
    Geliefert am 07. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Bluebridge house colchester road halstead braintree district essex t/no EX431528. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland International Limited
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 06. Aug. 2002
    Geliefert am 09. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland International Limited
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Nov. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Mai 1998
    Geliefert am 03. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a plot 155 princes riverside t/n 384711 the goodwill and connection of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 03. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 01. Apr. 1998
    Geliefert am 03. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £20,775 to be held by the landlord on deposit of a separate designated interest bearing account in england bearing interest at a competitive rate available in the market for such long term deposits at the bank of scotland in the name of the landlord
    Kurze Angaben
    The rent interest or any other moneys payable to the landlord pursuant to a lease dated 1/4/98 (as defined) over premises on the 6TH floor of 1/6 lombard st,london EC3 may be withdrawn from the deposit account if the tenant does not pay after the 21 days time limit. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Scottish Provident Institution
    Transaktionen
    • 03. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 25. Sept. 1997
    Geliefert am 01. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 01. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 13. Nov. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat PARK ROW GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    15. Sept. 2018Aufgelöst am
    25. Apr. 2014Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Ian C. Oakley-Smith
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0