PARK ROW GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PARK ROW GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03109700 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PARK ROW GROUP LIMITED?
- Tätigkeit von Holdinggesellschaften für Finanzdienstleistungen (64205) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich PARK ROW GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Central Square 8th Floor 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PARK ROW GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PARK ROW GROUP PLC | 07. Mai 2002 | 07. Mai 2002 |
| BIRCHIN INTERNATIONAL PLC | 19. Sept. 1997 | 19. Sept. 1997 |
| RUSHMERE WYNNE GROUP PLC | 28. Nov. 1995 | 28. Nov. 1995 |
| MARKETCOIN PUBLIC LIMITED COMPANY | 03. Okt. 1995 | 03. Okt. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PARK ROW GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PARK ROW GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 17 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 24. Apr. 2017 | 20 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Benson House 33 Wellington Street Leeds LS1 4JP zum Central Square 8th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL am 14. Okt. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 24. Apr. 2016 | 17 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 24. Apr. 2015 | 11 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O C/O Ambant Limited Marlow House Fifth Floor 1a Lloyds Avenue London EC3N 3AA United Kingdom* am 27. Mai 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 5 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Ambant Limited Lloyds Avenue House 6 Lloyds Avenue London EC3N 3AX geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 27 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O 6Th Floor 14 South Parade Leeds West Yorkshire LS1 5QS United Kingdom* am 04. Dez. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 28 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Royal Liver Building Liverpool Merseyside L3 1HT* am 19. Apr. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PARK ROW GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPPELL, Helen | Sekretär | Chalky Bank Road Rainham ME8 7NP Gillingham 27 Kent | British | 159189030001 | ||||||
| CRABB, Steven Lee | Geschäftsführer | The Byeway WD31 1JW Rickmansworth 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 93134850002 | |||||
| GRANT, Philip James | Geschäftsführer | Albury Road Furneux Pelham SG9 0LP Buntingford Clay Chimneys House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 34492660002 | |||||
| ADAMS, Derek Stanley | Sekretär | Lane End Birch Green CO2 0NH Colchester Essex | British | 45970110001 | ||||||
| CHAUDHRI, Farzana | Sekretär | Oaklands Oudle Lane SG10 6DQ Much Hadham Hertfordshire | British | 55239490003 | ||||||
| CONNOLLY, William Stephen | Sekretär | 3 Dodleston Close CH43 9QZ Birkenhead Merseyside | British | 86840740001 | ||||||
| LITTLE, David Anthony | Sekretär | 100 Kyrle Road SW11 6BA London | British | 77215960002 | ||||||
| MARKS, David Jeffrey | Sekretär | Virginia Lodge Royston Grove HA5 4HE Pinner Middlesex | British | 78129600001 | ||||||
| STEVENSON, Sandra Maureen | Sekretär | 197 Cotefield Drive LU7 8DW Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 48454410001 | ||||||
| EMCEE NOMINEES LIMITED | Sekretär | First Floor 31 Southampton Row WC1B 5HT London | 38708590001 | |||||||
| EPS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | 67339580001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ABBOTT, Richard David | Geschäftsführer | The Old Parsonage Church Street, Ropley SO24 0DS Hampshire | England | British | 78205110001 | |||||
| ADAMS, Derek Stanley | Geschäftsführer | Lane End Birch Green CO2 0NH Colchester Essex | British | 45970110001 | ||||||
| ALBERGE, Maurice Ernest | Geschäftsführer | 27 Glenloch Road NW3 4DJ London | British | 49539510001 | ||||||
| ALLSUP, Mark William | Geschäftsführer | 34 Dewhurst Road W14 0ES London | British | 42154290002 | ||||||
| BAILEY, Martin | Geschäftsführer | Daisybank Drive CW11 4JR Sandbach Heathside Cheshire England | England | British | 95450450003 | |||||
| BURNETT, Steven Robert | Geschäftsführer | The Belfry Northop Country Park Northop CH7 6WD Mold Flintshire | United Kingdom | British | 56044450001 | |||||
| BURR, Reginald Ivor | Geschäftsführer | 21 St James Close Prince Albert Road St Johns Wood NW8 7LG London | British | 70371780001 | ||||||
| BURR, Rosemary Karen | Geschäftsführer | 8 Hamilton House NW8 9PN London | British | 15659480001 | ||||||
| DAVIES, Elzbieta Krystyna | Geschäftsführer | Gravee Du Sud The Grange GY1 1RP St Peter Port Guernsey | British | 115958830001 | ||||||
| DAVIES, John Hamilton | Geschäftsführer | Denbies Bardfield Saling CM7 5EG Braintree Essex | England | British | 62682160001 | |||||
| DENHEEN, Peter Gerard | Geschäftsführer | 3 Pitcullen Terrace PH2 7EQ Perth Perthshire | British | 112863220001 | ||||||
| DOBSON, Kevin James, Dr | Geschäftsführer | 9 Harris Close Spital CH63 9YX Wirral Merseyside | England | British | 69819530006 | |||||
| DRURY, Anthony Charles | Geschäftsführer | 39 Redwood Glade LU7 3JT Leighton Buzzard Bedfordshire | England | British | 78025460001 | |||||
| FITZSIMMONS, Edward | Geschäftsführer | 91 Glenferness Avenue Talbot Woods BH3 7ES Bournemouth Dorset | England | British | 35037160002 | |||||
| GARDENER, Edward Patrick Montgomery, Professor | Geschäftsführer | The Gables Gannock Park, Deganwy LL31 9PZ Conwy Gwynedd | Wales | British | 66368000001 | |||||
| GARDNER, Colyn, Doctor | Geschäftsführer | 5 Oakley Street SW3 5NN London | British | 114586870001 | ||||||
| HARDY, Carol Margaret | Geschäftsführer | 6 Bawson Court Gomersal BD19 4SA Cleckheaton West Yorkshire | England | British | 89078690001 | |||||
| LASSEN, Richard Guy | Geschäftsführer | The Coach House 27 Southern Road SO41 9HR Lymington Hampshire | England | British | 111572370001 | |||||
| MAPES, Pamela | Geschäftsführer | 75 Greenside Road W12 9JQ London | British | 60465150001 | ||||||
| MARKS, David Jeffrey | Geschäftsführer | Virginia Lodge Royston Grove HA5 4HE Pinner Middlesex | England | British | 78129600001 | |||||
| MCGREGOR, George | Geschäftsführer | 7 Westmoreland Road PR8 6NX Southport Merseyside | United Kingdom | British | 88000730002 | |||||
| MCGREGOR, George | Geschäftsführer | 94 Forest Road PR8 6HY Southport Merseyside | British | 88000730001 | ||||||
| MINNS, Anthony Stirling | Geschäftsführer | Stoney Ridge House Headley Road Grayshott GU26 6DP Hindhead Surrey | United Kingdom | British | 1852650004 |
Hat PARK ROW GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security over shares agreement | Erstellt am 29. März 2011 Geliefert am 04. Apr. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from ambant limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 40,849,000 ordinary shares of £1 of park row associates limited and the related assets see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 15. Apr. 2008 Geliefert am 29. Apr. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £5875.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben £5875.00. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities | Erstellt am 11. Nov. 2002 Geliefert am 18. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All stocks shares bonds debentures or other securities deposited with the bank and any bonus or other new securities and all rights,moneys or property accruing. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Nov. 2002 Geliefert am 18. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property known as blue bridge house (essex); t/no EX431528. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 11. Nov. 2002 Geliefert am 18. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or to become due from the company (the "chargor") and by any other company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Aug. 2002 Geliefert am 07. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Bluebridge house colchester road halstead braintree district essex t/no EX431528. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Aug. 2002 Geliefert am 09. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 22. Mai 1998 Geliefert am 03. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a plot 155 princes riverside t/n 384711 the goodwill and connection of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 01. Apr. 1998 Geliefert am 03. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £20,775 to be held by the landlord on deposit of a separate designated interest bearing account in england bearing interest at a competitive rate available in the market for such long term deposits at the bank of scotland in the name of the landlord | |
Kurze Angaben The rent interest or any other moneys payable to the landlord pursuant to a lease dated 1/4/98 (as defined) over premises on the 6TH floor of 1/6 lombard st,london EC3 may be withdrawn from the deposit account if the tenant does not pay after the 21 days time limit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 25. Sept. 1997 Geliefert am 01. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat PARK ROW GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0