MASTERFONE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMASTERFONE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03110370
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MASTERFONE LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich MASTERFONE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    First Floor, Finchale House
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    Durham
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MASTERFONE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für MASTERFONE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    SeitenGAZ2(A)

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2019

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2018

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Okt. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2017

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Okt. 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Change of details for Mr Robert William Jefferson as a person with significant control on 31. Mai 2017

    2 SeitenPSC04

    Change of details for Mr John Corbitt Barnsley as a person with significant control on 31. Mai 2017

    2 SeitenPSC04

    Änderung der Details des Direktors für Mr Spencer Trerise Glanville am 05. Okt. 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Helen Louise Austin am 31. Mai 2017

    1 SeitenCH03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom First Floor Earl Grey House 75-85 Grey Street Newcastle upon Tyne NE1 6EF zum First Floor, Finchale House Belmont Business Park Durham Durham DH1 1TW am 31. Mai 2017

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2016

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Okt. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Richard Mark Wright als Geschäftsführer am 31. Aug. 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Spencer Trerise Glanville als Direktor am 04. Juli 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Thomas Michael Scott Wooldridge als Geschäftsführer am 04. Juli 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Helen Louise Austin als Sekretär am 24. März 2016

    2 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Robert William Jefferson als Direktor am 24. März 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr John Corbitt Barnsley als Direktor am 24. März 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Thomas Michael Scott Wooldridge als Sekretär am 24. März 2016

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Christopher John Dalzell als Geschäftsführer am 15. Dez. 2015

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von MASTERFONE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    AUSTIN, Helen Louise
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    Sekretär
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    206671010001
    BARNSLEY, John Corbitt
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    Geschäftsführer
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    EnglandBritish79608860004
    GLANVILLE, Spencer Trerise
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    Geschäftsführer
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    EnglandBritish210542980002
    JEFFERSON, Robert William
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    Geschäftsführer
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    EnglandBritish8394160003
    DYKE, Karin Patricia
    117 Moorside North
    NE4 9DY Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Sekretär
    117 Moorside North
    NE4 9DY Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British111712790001
    MCLACHLAN, Elsie
    Burn Brae
    Gilsland
    CA8 7BE Brampton
    Cumbria
    Sekretär
    Burn Brae
    Gilsland
    CA8 7BE Brampton
    Cumbria
    British33660580003
    SWEETBAUM, Peter Mark
    Flat 1
    7 Ranulf Road
    NW2 2BT London
    Sekretär
    Flat 1
    7 Ranulf Road
    NW2 2BT London
    American69912090001
    WOOLDRIDGE, Thomas Michael Scott
    Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    First Floor
    Sekretär
    Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    First Floor
    146628670001
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Sekretär
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer04363143
    94529700001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    DALZELL, Christopher John
    Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    First Floor
    Geschäftsführer
    Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    First Floor
    EnglandBritish9520500003
    HENDERSON, Anne Patricia
    38 Jesmond Dene Road
    Jesmond
    NE2 3LQ Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    38 Jesmond Dene Road
    Jesmond
    NE2 3LQ Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish45099880001
    WILLIAMS, Nicholas Arthur Ross
    32 Fitzwilliam Road
    SW14 0DN London
    Geschäftsführer
    32 Fitzwilliam Road
    SW14 0DN London
    British55342890002
    WOOLDRIDGE, Thomas Michael Scott
    Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    First Floor
    Geschäftsführer
    Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    First Floor
    United KingdomBritish99757110003
    WRIGHT, Richard Mark
    Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    First Floor
    Geschäftsführer
    Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    First Floor
    United KingdomBritish126811670002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MASTERFONE LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Robert William Jefferson
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    06. Apr. 2016
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Mr John Corbitt Barnsley
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    06. Apr. 2016
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat MASTERFONE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Standard security dated 4, 9, 11, 27 and 29 september 2009 and 13 october 2009
    Erstellt am 13. Okt. 2009
    Geliefert am 05. Nov. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole subjects k/a and forming part eurocentral mcneil drive, holytown t/no's LAN136498 and LAN136562.
    Berechtigte Personen
    • Ionic Limited
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Rental assignation
    Erstellt am 07. Nov. 2007
    Geliefert am 21. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Lease between the members of the 2000/2001 europoint syndicate and amey infastructure services limited dated 9 july and. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Rental assignation
    Erstellt am 14. Aug. 2007
    Geliefert am 30. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The whole entitlement to receive all rents and other sums.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Rental assignation
    Erstellt am 14. Aug. 2007
    Geliefert am 30. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The whole entitlement to receive all rents and other sums.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 15/12/05 and
    Erstellt am 30. Nov. 2005
    Geliefert am 23. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects at netherhall road, excelsior park, wishaw t/no LAN115430 and LAN115136.
    Berechtigte Personen
    • Justus Corporation Limited
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 28 april 2004 and
    Erstellt am 01. Apr. 2004
    Geliefert am 18. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects at woodhall, mossend, registered in the land register of scotland under t/n 115607.
    Berechtigte Personen
    • Liverpool Victoria Friendly Society Limited
    Transaktionen
    • 18. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 21 january 2004 and
    Erstellt am 15. Jan. 2004
    Geliefert am 28. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Woodhall mossend lanarkshire t/n LAN111466.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Holburn Life Limited
    Transaktionen
    • 28. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment dated 5 april 2001 made between the members of the 2001 europoint syndicate (as defined)
    Erstellt am 05. Apr. 2001
    Geliefert am 20. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    With full title guarantee assigns by way of security to bos the payment and discharge of the secured liabilities all right, title, benefit and interest of the assignor to: the rent guarantee charge (as defined): the construction cost charge (as defined).. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 9 april 2001 and
    Erstellt am 04. Apr. 2001
    Geliefert am 21. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The area of ground extending to 1.789 acres lying in the county of lanark to the north of mcneil drive,eurocentral,holytown,lanarkshire; lan 136498.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Sale/purchase agreement assignation
    Erstellt am 04. Apr. 2001
    Geliefert am 13. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    In consideration of facilities made available by the governor and company of the bank of scotland to the company including all sums of money including principal interest and charges due and that may become due to the mortgagee in any manner of way by the company solely or jointly with any other person or persons or corporation and whether as principal or surety
    Kurze Angaben
    The companys whole right and interest in a sale and purchase agreement between the members of the 2000/2001 europoint syndicate and brs developments limited of even date the companys whole right and interest in and to paragraph 3 of a letter of undertaking by the members of the 1998/1999 eurocentral syndicate in favour of brs developments limited of even date.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Rental assignation
    Erstellt am 04. Apr. 2001
    Geliefert am 13. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the terms of a personal bond of even date
    Kurze Angaben
    Rent and other sums payable under a lease between the members of the 2000/2001 europoint syndicate and brs developments limited of 1.789 acres at mcneil.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 5TH september 2000 and
    Erstellt am 30. Juni 2000
    Geliefert am 13. Sept. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future sums of money whatsoever due or to become due in terms of the personal bond granted by the members of the 1998/99 eurocentral syndicate (as defined in part 4 of the schedule) in favour of the governor and company of the bank of scotland dated 1 april 1999 as varied,amended or supplemented from time to time
    Kurze Angaben
    The plot or area of ground lying within the district of motherwell,county of lanark extending to 2.65 hectares or thereby known as plot 4,mcneil drive,holytown,eurocentral business park,lanarkshire; t/nos LAN112513 and LAN94501; all parts,privileges and pertinents and all right,title and interest thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Charge and assignment of film rights and revenues between voyager 19 partnership ("voyager") (1), factor 8 films limited ("factor 8") (2) (together the "chargors") and the chargee (3)
    Erstellt am 21. März 2000
    Geliefert am 30. März 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The obligations and liabilities of the chargors to the chargee under or pursuant to clauses 4.2 and 4.3 of the chargee, together with the obligations of factor 8 and the rights of the chargee under clause 11 of the first acquisition agreement dated 21 march 2000 and voyager under clause 4.13 of the charge. The rights of recourse of the chargee under the charge against the partners (as defined) in voyager shall be limited to the proceeds of realisation of the security assets (as defined)
    Kurze Angaben
    The master negative and the film rights and allrights title and interest in and to all monies payable to it under the first acquisition agreement, the second acquisition agreement and the sale agreement.
    Berechtigte Personen
    • Beautiful Films Limited
    Transaktionen
    • 30. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 16TH april 1999 and
    Erstellt am 10. Apr. 1999
    Geliefert am 29. Apr. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future sums of money (howsoever arising) due and that may become due to the chargee in terms of the personal bond granted by masterfone limited as one of the members of the 1998/99 eurocentral syndicate
    Kurze Angaben
    Plot 2 (0.55 hectares) and 3 (1.50 hectares) at mcneil drive, holytown, lanarkshire title number lan 136562.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 14TH april 1999 and
    Erstellt am 01. Apr. 1999
    Geliefert am 29. Apr. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future sums of money (howsoever arising) due and that may becomde due to the chargee in terms of the personal bond granted by masterfone limited as one of the members of the 1998/99 eurocentral syndicate
    Kurze Angaben
    Plot 1 (4.65 hectares) at mcneil drive, holytown, lanarkshire title number LAN136498.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Nov. 1997
    Geliefert am 14. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a site 2 royal quays coble dene north shields tyne and wear t/n TY335252 together with all buildings and fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Girobank PLC
    Transaktionen
    • 14. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation in security
    Erstellt am 03. Mai 1996
    Geliefert am 18. Mai 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations monies and liabilities due or to become due owing or incurred by the borrowers (as defined in the charge) to the chargee in terms of a facility letter dated 29TH march 1996 (as defined) with the acceptance endorsed thereon (the facility letter) and any letter deed document or other confirming varying or amending or supplemental to the facility letter
    Kurze Angaben
    All right title and benefit in and to the account numbered 00223888 held in the name of the 1995/1996 scottish power ez syndicate and maintained with bank of scotland edinburgh together with all balances standing to the credit of the account, any agreements or instruments and all rights.
    Berechtigte Personen
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transaktionen
    • 18. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 5TH april 1996
    Erstellt am 01. Apr. 1996
    Geliefert am 24. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by the borrowers (as defined) in favour of the united bank of kuwait PLC in terms of the facility letter and the facility agreement (as defined)
    Kurze Angaben
    The lands and estate of woodhall lying in the county of lanark t/no lna 86593. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transaktionen
    • 24. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland
    Erstellt am 29. März 1996
    Geliefert am 12. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers (as defined therein) to the chargee under the terms of the facility letter and the facility agreement (both as defined therein)
    Kurze Angaben
    All and whole those two plots or areas of ground lying in the former burgh of motherwell and wishaw and county of lanark extending in total to 4.597 hectares t/no. LAN115430.
    Berechtigte Personen
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation in security
    Erstellt am 15. März 1996
    Geliefert am 25. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a facility letter dated 12TH march 1996,any letter deed,document or other confirming varying amending or supplemental thereto
    Kurze Angaben
    The company's wholr right title and interest in the account details of which are set out on the paper apart to form 395 see form for details.
    Berechtigte Personen
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation in security
    Erstellt am 23. Feb. 1996
    Geliefert am 26. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations monies and liabilities due from the borrowers as defined to the chargee in terms of a facility letter dated 21ST december 1995 and acceptance of the facility letter by the borrowers dated 21ST december 1995 and any letter deed document or other confirming or verifying amending or supplemental to the facility letter
    Kurze Angaben
    The company's whole right title and interest in the account please see form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transaktionen
    • 26. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security presented for registration in scotland
    Erstellt am 29. Dez. 1995
    Geliefert am 12. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee in terms of the facility letter and the facility agreement (both as defined)
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects forming part of the land and estate of woodhall liying in the county of lanark extending to 4.267 hectares or thereacouts (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Dez. 1995
    Geliefert am 10. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms iof the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0