MASTERFONE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MASTERFONE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03110370 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MASTERFONE LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich MASTERFONE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | First Floor, Finchale House Belmont Business Park DH1 1TW Durham Durham England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MASTERFONE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MASTERFONE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | Seiten | GAZ2(A) | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2019 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2018 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Okt. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2017 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Mr Robert William Jefferson as a person with significant control on 31. Mai 2017 | 2 Seiten | PSC04 | ||
Change of details for Mr John Corbitt Barnsley as a person with significant control on 31. Mai 2017 | 2 Seiten | PSC04 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Spencer Trerise Glanville am 05. Okt. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Helen Louise Austin am 31. Mai 2017 | 1 Seiten | CH03 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom First Floor Earl Grey House 75-85 Grey Street Newcastle upon Tyne NE1 6EF zum First Floor, Finchale House Belmont Business Park Durham Durham DH1 1TW am 31. Mai 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2016 | 7 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Richard Mark Wright als Geschäftsführer am 31. Aug. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Spencer Trerise Glanville als Direktor am 04. Juli 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Thomas Michael Scott Wooldridge als Geschäftsführer am 04. Juli 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Helen Louise Austin als Sekretär am 24. März 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||
Ernennung von Mr Robert William Jefferson als Direktor am 24. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr John Corbitt Barnsley als Direktor am 24. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Thomas Michael Scott Wooldridge als Sekretär am 24. März 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||
Beendigung der Bestellung von Christopher John Dalzell als Geschäftsführer am 15. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von MASTERFONE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTIN, Helen Louise | Sekretär | Belmont Business Park DH1 1TW Durham First Floor, Finchale House Durham England | 206671010001 | |||||||||||
| BARNSLEY, John Corbitt | Geschäftsführer | Belmont Business Park DH1 1TW Durham First Floor, Finchale House Durham England | England | British | 79608860004 | |||||||||
| GLANVILLE, Spencer Trerise | Geschäftsführer | Belmont Business Park DH1 1TW Durham First Floor, Finchale House Durham England | England | British | 210542980002 | |||||||||
| JEFFERSON, Robert William | Geschäftsführer | Belmont Business Park DH1 1TW Durham First Floor, Finchale House Durham England | England | British | 8394160003 | |||||||||
| DYKE, Karin Patricia | Sekretär | 117 Moorside North NE4 9DY Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 111712790001 | ||||||||||
| MCLACHLAN, Elsie | Sekretär | Burn Brae Gilsland CA8 7BE Brampton Cumbria | British | 33660580003 | ||||||||||
| SWEETBAUM, Peter Mark | Sekretär | Flat 1 7 Ranulf Road NW2 2BT London | American | 69912090001 | ||||||||||
| WOOLDRIDGE, Thomas Michael Scott | Sekretär | Earl Grey House 75-85 Grey Street NE1 6EF Newcastle Upon Tyne First Floor | 146628670001 | |||||||||||
| PRIMA SECRETARY LIMITED | Sekretär | 112 Quayside NE99 1SB Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf United Kingdom |
| 94529700001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| DALZELL, Christopher John | Geschäftsführer | Earl Grey House 75-85 Grey Street NE1 6EF Newcastle Upon Tyne First Floor | England | British | 9520500003 | |||||||||
| HENDERSON, Anne Patricia | Geschäftsführer | 38 Jesmond Dene Road Jesmond NE2 3LQ Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 45099880001 | |||||||||
| WILLIAMS, Nicholas Arthur Ross | Geschäftsführer | 32 Fitzwilliam Road SW14 0DN London | British | 55342890002 | ||||||||||
| WOOLDRIDGE, Thomas Michael Scott | Geschäftsführer | Earl Grey House 75-85 Grey Street NE1 6EF Newcastle Upon Tyne First Floor | United Kingdom | British | 99757110003 | |||||||||
| WRIGHT, Richard Mark | Geschäftsführer | Earl Grey House 75-85 Grey Street NE1 6EF Newcastle Upon Tyne First Floor | United Kingdom | British | 126811670002 | |||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MASTERFONE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Robert William Jefferson | 06. Apr. 2016 | Belmont Business Park DH1 1TW Durham First Floor, Finchale House Durham England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr John Corbitt Barnsley | 06. Apr. 2016 | Belmont Business Park DH1 1TW Durham First Floor, Finchale House Durham England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat MASTERFONE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security dated 4, 9, 11, 27 and 29 september 2009 and 13 october 2009 | Erstellt am 13. Okt. 2009 Geliefert am 05. Nov. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole subjects k/a and forming part eurocentral mcneil drive, holytown t/no's LAN136498 and LAN136562. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rental assignation | Erstellt am 07. Nov. 2007 Geliefert am 21. Nov. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Lease between the members of the 2000/2001 europoint syndicate and amey infastructure services limited dated 9 july and. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rental assignation | Erstellt am 14. Aug. 2007 Geliefert am 30. Aug. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The whole entitlement to receive all rents and other sums. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rental assignation | Erstellt am 14. Aug. 2007 Geliefert am 30. Aug. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The whole entitlement to receive all rents and other sums. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 15/12/05 and | Erstellt am 30. Nov. 2005 Geliefert am 23. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects at netherhall road, excelsior park, wishaw t/no LAN115430 and LAN115136. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 28 april 2004 and | Erstellt am 01. Apr. 2004 Geliefert am 18. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects at woodhall, mossend, registered in the land register of scotland under t/n 115607. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 21 january 2004 and | Erstellt am 15. Jan. 2004 Geliefert am 28. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Woodhall mossend lanarkshire t/n LAN111466. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment dated 5 april 2001 made between the members of the 2001 europoint syndicate (as defined) | Erstellt am 05. Apr. 2001 Geliefert am 20. Apr. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben With full title guarantee assigns by way of security to bos the payment and discharge of the secured liabilities all right, title, benefit and interest of the assignor to: the rent guarantee charge (as defined): the construction cost charge (as defined).. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 9 april 2001 and | Erstellt am 04. Apr. 2001 Geliefert am 21. Apr. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The area of ground extending to 1.789 acres lying in the county of lanark to the north of mcneil drive,eurocentral,holytown,lanarkshire; lan 136498. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Sale/purchase agreement assignation | Erstellt am 04. Apr. 2001 Geliefert am 13. Apr. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag In consideration of facilities made available by the governor and company of the bank of scotland to the company including all sums of money including principal interest and charges due and that may become due to the mortgagee in any manner of way by the company solely or jointly with any other person or persons or corporation and whether as principal or surety | |
Kurze Angaben The companys whole right and interest in a sale and purchase agreement between the members of the 2000/2001 europoint syndicate and brs developments limited of even date the companys whole right and interest in and to paragraph 3 of a letter of undertaking by the members of the 1998/1999 eurocentral syndicate in favour of brs developments limited of even date. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rental assignation | Erstellt am 04. Apr. 2001 Geliefert am 13. Apr. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in the terms of a personal bond of even date | |
Kurze Angaben Rent and other sums payable under a lease between the members of the 2000/2001 europoint syndicate and brs developments limited of 1.789 acres at mcneil. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 5TH september 2000 and | Erstellt am 30. Juni 2000 Geliefert am 13. Sept. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All present and future sums of money whatsoever due or to become due in terms of the personal bond granted by the members of the 1998/99 eurocentral syndicate (as defined in part 4 of the schedule) in favour of the governor and company of the bank of scotland dated 1 april 1999 as varied,amended or supplemented from time to time | |
Kurze Angaben The plot or area of ground lying within the district of motherwell,county of lanark extending to 2.65 hectares or thereby known as plot 4,mcneil drive,holytown,eurocentral business park,lanarkshire; t/nos LAN112513 and LAN94501; all parts,privileges and pertinents and all right,title and interest thereunder. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge and assignment of film rights and revenues between voyager 19 partnership ("voyager") (1), factor 8 films limited ("factor 8") (2) (together the "chargors") and the chargee (3) | Erstellt am 21. März 2000 Geliefert am 30. März 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The obligations and liabilities of the chargors to the chargee under or pursuant to clauses 4.2 and 4.3 of the chargee, together with the obligations of factor 8 and the rights of the chargee under clause 11 of the first acquisition agreement dated 21 march 2000 and voyager under clause 4.13 of the charge. The rights of recourse of the chargee under the charge against the partners (as defined) in voyager shall be limited to the proceeds of realisation of the security assets (as defined) | |
Kurze Angaben The master negative and the film rights and allrights title and interest in and to all monies payable to it under the first acquisition agreement, the second acquisition agreement and the sale agreement. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on the 16TH april 1999 and | Erstellt am 10. Apr. 1999 Geliefert am 29. Apr. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All present and future sums of money (howsoever arising) due and that may become due to the chargee in terms of the personal bond granted by masterfone limited as one of the members of the 1998/99 eurocentral syndicate | |
Kurze Angaben Plot 2 (0.55 hectares) and 3 (1.50 hectares) at mcneil drive, holytown, lanarkshire title number lan 136562. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on the 14TH april 1999 and | Erstellt am 01. Apr. 1999 Geliefert am 29. Apr. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All present and future sums of money (howsoever arising) due and that may becomde due to the chargee in terms of the personal bond granted by masterfone limited as one of the members of the 1998/99 eurocentral syndicate | |
Kurze Angaben Plot 1 (4.65 hectares) at mcneil drive, holytown, lanarkshire title number LAN136498. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Nov. 1997 Geliefert am 14. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a site 2 royal quays coble dene north shields tyne and wear t/n TY335252 together with all buildings and fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation in security | Erstellt am 03. Mai 1996 Geliefert am 18. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations monies and liabilities due or to become due owing or incurred by the borrowers (as defined in the charge) to the chargee in terms of a facility letter dated 29TH march 1996 (as defined) with the acceptance endorsed thereon (the facility letter) and any letter deed document or other confirming varying or amending or supplemental to the facility letter | |
Kurze Angaben All right title and benefit in and to the account numbered 00223888 held in the name of the 1995/1996 scottish power ez syndicate and maintained with bank of scotland edinburgh together with all balances standing to the credit of the account, any agreements or instruments and all rights. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 5TH april 1996 | Erstellt am 01. Apr. 1996 Geliefert am 24. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by the borrowers (as defined) in favour of the united bank of kuwait PLC in terms of the facility letter and the facility agreement (as defined) | |
Kurze Angaben The lands and estate of woodhall lying in the county of lanark t/no lna 86593. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland | Erstellt am 29. März 1996 Geliefert am 12. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrowers (as defined therein) to the chargee under the terms of the facility letter and the facility agreement (both as defined therein) | |
Kurze Angaben All and whole those two plots or areas of ground lying in the former burgh of motherwell and wishaw and county of lanark extending in total to 4.597 hectares t/no. LAN115430. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation in security | Erstellt am 15. März 1996 Geliefert am 25. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a facility letter dated 12TH march 1996,any letter deed,document or other confirming varying amending or supplemental thereto | |
Kurze Angaben The company's wholr right title and interest in the account details of which are set out on the paper apart to form 395 see form for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation in security | Erstellt am 23. Feb. 1996 Geliefert am 26. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations monies and liabilities due from the borrowers as defined to the chargee in terms of a facility letter dated 21ST december 1995 and acceptance of the facility letter by the borrowers dated 21ST december 1995 and any letter deed document or other confirming or verifying amending or supplemental to the facility letter | |
Kurze Angaben The company's whole right title and interest in the account please see form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security presented for registration in scotland | Erstellt am 29. Dez. 1995 Geliefert am 12. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee in terms of the facility letter and the facility agreement (both as defined) | |
Kurze Angaben All and whole the subjects forming part of the land and estate of woodhall liying in the county of lanark extending to 4.267 hectares or thereacouts (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Dez. 1995 Geliefert am 10. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms iof the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0