ROYAL BANK ASSET FINANCE LIMITED

ROYAL BANK ASSET FINANCE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameROYAL BANK ASSET FINANCE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03117146
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ROYAL BANK ASSET FINANCE LIMITED?

    • Finanzleasing (64910) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich ROYAL BANK ASSET FINANCE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Quadrangle
    The Promenade
    GL50 1PX Cheltenham
    Gloucestershire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ROYAL BANK ASSET FINANCE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    R.B. PROMENADE LIMITED23. Okt. 199523. Okt. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROYAL BANK ASSET FINANCE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für ROYAL BANK ASSET FINANCE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. Nov. 2015

    Kapitalaufstellung am 30. Nov. 2015

    • Kapital: GBP 2
    • Kapital: USD 201
    SH01

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    20 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    7 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    7 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Nov. 2014

    Kapitalaufstellung am 21. Nov. 2014

    • Kapital: GBP 2
    • Kapital: USD 201
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    23 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Lambros Varnavides als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Paul Sullivan als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Dez. 2013

    Kapitalaufstellung am 11. Dez. 2013

    • Kapital: GBP 2
    • Kapital: USD 201
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Sharon Jill Caterer am 23. Juni 2013

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    27 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von ROYAL BANK ASSET FINANCE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24-25
    Scotland
    Sekretär
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24-25
    Scotland
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerSC269847
    169073830001
    CATERER, Sharon Jill
    The Promonade
    GL50 1PX Cheltenham
    The Quadrangle
    Gloucestershire
    England
    Geschäftsführer
    The Promonade
    GL50 1PX Cheltenham
    The Quadrangle
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritish15490360001
    CHEESMAN, Philip Antony
    Great Tower Street
    EC3P 3HX London
    5-10
    Geschäftsführer
    Great Tower Street
    EC3P 3HX London
    5-10
    EnglandBritish157812490001
    CUNNINGHAM, Angela Mary
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    Sekretär
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    British62801910001
    DOWN, Carolyn Jean
    280 Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    4th Floor
    England
    Sekretär
    280 Bishopsgate
    EC2M 4RB London
    4th Floor
    England
    Other67499700004
    LEA, John Albert
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    Sekretär
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    British1369400003
    THOMAS, Marina Louise
    Richmond Lodge
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    Sekretär
    Richmond Lodge
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    British80901390001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BROWN, Martin Graham
    Blueboys Barn
    Cirencester Road
    GL6 9EQ Minchinhampton
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Blueboys Barn
    Cirencester Road
    GL6 9EQ Minchinhampton
    Gloucestershire
    British36168760001
    CARR, Thomas
    4 Admirals Court
    Eastbury Avenue
    HA6 3JP Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    4 Admirals Court
    Eastbury Avenue
    HA6 3JP Northwood
    Middlesex
    British656980011
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Geschäftsführer
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    British98778780002
    CLEMETT, Graham Colin
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    United KingdomBritish123744930001
    DEVINE, Alan Sinclair
    42 Mirfield Road
    B91 1JD Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    42 Mirfield Road
    B91 1JD Solihull
    West Midlands
    British96634670001
    ELDER, Davies Burns
    Flat 9 Cathedral Lodge
    110-115 Aldersgate Street
    EC1A 4JE London
    Geschäftsführer
    Flat 9 Cathedral Lodge
    110-115 Aldersgate Street
    EC1A 4JE London
    British70027580001
    FARNELL, Adrian Colin
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish43015720002
    FLINT, Eion Arthur Mcmorran
    The Rhododendrons Warren Lane
    Finchampstead
    RG40 4HS Wokingham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Rhododendrons Warren Lane
    Finchampstead
    RG40 4HS Wokingham
    Berkshire
    British56760630002
    GEORGIOU, Andreas
    Little Hallingbury
    Bishops Stortford
    CM22 7RJ Herts
    The Lodge, Goose Lane
    England
    Geschäftsführer
    Little Hallingbury
    Bishops Stortford
    CM22 7RJ Herts
    The Lodge, Goose Lane
    England
    British88113470002
    LATTER, William Vaughan
    Mernian
    Bushley
    GL20 6HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Mernian
    Bushley
    GL20 6HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    British52914600004
    LOCKER, Graham Richard
    Stratfirld Drive
    EN10 7NU Broxbourne
    19
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Stratfirld Drive
    EN10 7NU Broxbourne
    19
    Hertfordshire
    British132992690001
    PEARCE, Nigel
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    United KingdomBritish63084840002
    SLATTERY, Domhnal
    16 Ailesbury Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Ireland
    Geschäftsführer
    16 Ailesbury Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Ireland
    Republic Of IrelandIrish154385180001
    SULLIVAN, Paul Denzil John
    Berberry Drive
    MK45 5ER Flitton
    10
    Bedfordshire
    England
    Geschäftsführer
    Berberry Drive
    MK45 5ER Flitton
    10
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish111421900001
    SWEETMAN, Jonathan Michael
    Knole House
    Shaw Green Lane Prestbury
    GL52 3BP Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Knole House
    Shaw Green Lane Prestbury
    GL52 3BP Cheltenham
    Gloucestershire
    British33029380001
    TUBB, Philip Anthony
    15 Mardleybury Road
    SG3 6SG Datchworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    15 Mardleybury Road
    SG3 6SG Datchworth
    Hertfordshire
    British98115740001
    VARNAVIDES, Lambros
    Cedars
    24 Uphill Road Mill Hill
    NW7 4RB London
    Geschäftsführer
    Cedars
    24 Uphill Road Mill Hill
    NW7 4RB London
    EnglandBritish33245340001

    Hat ROYAL BANK ASSET FINANCE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage relating to a 37,000 dwt product/chemical tanker at hyundai mipo dockyard co. Limited. With hull no. 0106 (the "vessel")
    Erstellt am 27. Juni 2002
    Geliefert am 09. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor by way of security, (I) (subject to any prior ranking security interest created by a person other than the chargor), mortgagees to the chargor the vessel by way of first priority mortgage and (ii) assigns to the chargee, all the assigned proceeds in each case upon the terms of the mortgage.
    Berechtigte Personen
    • Bp Shipping Limited
    Transaktionen
    • 09. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage relating to a 37,000 dwt product/chemical tanker at hyundai mipo dockyard co. Limited. With hull no. 0105 (the "vessel")
    Erstellt am 27. Juni 2002
    Geliefert am 09. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor by way of security, (I) (subject to any prior ranking security interest created by a person other than the chargor), mortgagees to the chargor the vessel by way of first priority mortgage and (ii) assigns to the chargee, all the assigned proceeds in each case upon the terms of the mortgage.
    Berechtigte Personen
    • Bp Shipping Limited
    Transaktionen
    • 09. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage relating to a 37,000 dwt product/chemical tanker at hyundai mipo dockyard co. Limited. With hull no. 0026 (the "vessel")
    Erstellt am 27. Juni 2002
    Geliefert am 09. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor by way of security, (I) (subject to any prior ranking security interest created by a person other than the chargor), mortgagees to the chargor the vessel by way of first priority mortgage and (ii) assigns to the chargee, all the assigned proceeds in each case upon the terms of the mortgage.
    Berechtigte Personen
    • Bp Shipping Limited
    Transaktionen
    • 09. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage relating to a 37,000 dwt product/chemical tanker at hyundai mipo dockyard co. Limited. With hull no. 0025 (the "vessel")
    Erstellt am 27. Juni 2002
    Geliefert am 09. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor by way of security, (I) (subject to any prior ranking security interest created by a person other than the chargor), mortgagees to the chargor the vessel by way of first priority mortgage and (ii) assigns to the chargee, all the assigned proceeds in each case upon the terms of the mortgage.
    Berechtigte Personen
    • Bp Shipping Limited
    Transaktionen
    • 09. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage relating to a 105,900 single screw motor crude oil tanker at tsuneishi shipbuilding co. Limited. With hull no. 1257 (the "vessel")
    Erstellt am 27. Juni 2002
    Geliefert am 09. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor by way of security, (I) (subject to any prior ranking security interest created by a person other than the chargor), mortgagees to the chargor the vessel by way of first priority mortgage and (ii) assigns to the chargee, all the assigned proceeds in each case upon the terms of the mortgage.
    Berechtigte Personen
    • Bp Shipping Limited
    Transaktionen
    • 09. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage relating to a 105,900 single screw motor crude oil tanker at tsuneishi shipbuilding co. Limited. With hull no. 1256 (the "vessel")
    Erstellt am 27. Juni 2002
    Geliefert am 09. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor by way of security, (I) (subject to any prior ranking security interest created by a person other than the chargor), mortgagees to the chargor the vessel by way of first priority mortgage and (ii) assigns to the chargee, all the assigned proceeds in each case upon the terms of the mortgage.
    Berechtigte Personen
    • Bp Shipping Limited
    Transaktionen
    • 09. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage relating to a 105,900 single screw motor crude oil tanker at tsuneishi shipbuilding co. Limited. With hull no. 1255 (the "vessel")
    Erstellt am 27. Juni 2002
    Geliefert am 09. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor by way of security, (I) (subject to any prior ranking security interest created by a person other than the chargor), mortgagees to the chargor the vessel by way of first priority mortgage and (ii) assigns to the chargee, all the assigned proceeds in each case upon the terms of the mortgage.
    Berechtigte Personen
    • Bp Shipping Limited
    Transaktionen
    • 09. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage relating to a 105,900 single screw motor crude oil tanker at tsuneishi shipbuilding co. Limited. With hull no. 1254 (the "vessel")
    Erstellt am 27. Juni 2002
    Geliefert am 09. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor by way of security, (I) (subject to any prior ranking security interest created by a person other than the chargor), mortgagees to the chargor the vessel by way of first priority mortgage and (ii) assigns to the chargee, all the assigned proceeds in each case upon the terms of the mortgage.
    Berechtigte Personen
    • Bp Shipping Limited
    Transaktionen
    • 09. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 08. Nov. 2001
    Geliefert am 21. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under and in accordance with a charterparty (the "charter") by way of demise dated 14TH september 2001 in respect of the vessel
    Kurze Angaben
    115,000 dwt aframax crude oil tanker currently under construction at samsung heavy industries co. Limited with hull no. 1433 and to be registered under british flag at the port of douglas, as security for the secured obligations, the chargor mortgages to the chargee the vessel by way of first priority mortgage and assigns to the chargee the assigned proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bp Shipping Limited
    Transaktionen
    • 21. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 08. Nov. 2001
    Geliefert am 21. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under and in accordance with a charterparty (the "charter") by way of demise dated 14TH september 2001 in respect of the vessel
    Kurze Angaben
    115,000 dwt aframax crude oil tanker currently under construction at samsung heavy industries co. Limited with hull no. 1432 and to be registered under british flag at the port of douglas, as security for the secured obligations, the chargor mortgages to the chargee the vessel by way of first priority mortgage and assigns to the chargee the assigned proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bp Shipping Limited
    Transaktionen
    • 21. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 08. Nov. 2001
    Geliefert am 21. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under and in accordance with a charterparty (the "charter") by way of demise dated 14TH september 2001 in respect of the vessel
    Kurze Angaben
    115,000 dwt aframax crude oil tanker currently under construction at samsung heavy industries co. Limited with hull no. 1431 and to be registered under british flag at the port of douglas, as security for the secured obligations, the chargor mortgages to the chargee the vessel by way of first priority mortgage and assigns to the chargee the assigned proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bp Shipping Limited
    Transaktionen
    • 21. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 08. Nov. 2001
    Geliefert am 21. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under and in accordance with a charterparty (the "charter") by way of demise dated 14TH september 2001 in respect of the vessel
    Kurze Angaben
    115,000 dwt aframax crude oil tanker currently under construction at samsung heavy industries co. Limited with hull no. 1430 and to be registered under british flag at the port of douglas, as security for the secured obligations, the chargor mortgages to the chargee the vessel by way of first priority mortgage and assigns to the chargee the assigned proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bp Shipping Limited
    Transaktionen
    • 21. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0