BLEASE MEDICAL HOLDINGS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BLEASE MEDICAL HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03121234 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BLEASE MEDICAL HOLDINGS LIMITED?
- (3162) /
Wo befindet sich BLEASE MEDICAL HOLDINGS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 110 Cannon Street EC4N 6AR London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BLEASE MEDICAL HOLDINGS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CATSEC 409 LIMITED | 02. Nov. 1995 | 02. Nov. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BLEASE MEDICAL HOLDINGS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BLEASE MEDICAL HOLDINGS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Leslie Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 13 Seiten | AA | ||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008 | 12 Seiten | AA | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2007 | 13 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2006 | 13 Seiten | AA | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2005 | 14 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 287 |
Wer sind die Geschäftsführer von BLEASE MEDICAL HOLDINGS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASSILA, Karita | Sekretär | Nihtisillankuja FI02630 Espoo 5 Finland | Finnish | Associate General Counsel | 116326140002 | |||||
HARPER, Ian John | Geschäftsführer | Shaftesbury Drive Stotfold SG5 4FS Hitchin 28 Hertfordshire United Kingdom | British | Managing Director | 135948940001 | |||||
LINES, Robert | Geschäftsführer | 16 Lattimore Road AL1 3XW St Albans Hertfordshire | England | British | Accountant | 115043640001 | ||||
CALLAGHAN, Kathleen | Sekretär | 12730 N.E 28th Street Bellevue Washington 98005 Usa | U.S. | Lawyer | 115043690001 | |||||
FERGUSON, Elizabeth Mary | Sekretär | Mundys Hill Shere Road GU6 7PQ Ewhurst Surrey | British | 32163680002 | ||||||
CATSEC LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Fulwood House Fulwood Place WC1V 6HR London | 900011380001 | |||||||
COMPANY LAW CONSULTANTS LIMITED | Sekretär | Seven Gables House 30 Letchmore Road WD7 8HT Radlett Hertfordshire | 80946110001 | |||||||
GRAVITAS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 110 Cannon Street EC4N 6AR London | 48725320001 | |||||||
ANDREW, Jeryl Christine | Geschäftsführer | Honeywood Hayles Field Frieth RG9 6PP Henley On Thames Oxfordshire | British | Investment Manager | 33065050002 | |||||
CADMAN, Michael Edward | Geschäftsführer | 8 Graces Maltings HP23 6PL Tring Hertfordshire | British | Sales Director | 46502120001 | |||||
EVERITT, James Edmund | Geschäftsführer | Mayflower Lodge Roundstone Lane BN16 4AY Angmering West Sussex | United Kingdom | British | Company Director | 37177220002 | ||||
FERGUSON, Andrew John Duncan | Geschäftsführer | Mundys Hill Shere Road GU6 7PQ Emhurst Surrey | British | Director | 20114450002 | |||||
KRAUSS, Philip David | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 42 Chiltern Road Bray SL6 1XA Maidenhead Berkshire | British | 900011370001 | ||||||
MEHTA, Nikhil Atul | Geschäftsführer | 1133 Via Zumaya Palos Verdes Estates California 90274 Usa | American | Company Vice President | 103834880001 | |||||
MORRISON, David John | Geschäftsführer | Albert Bridge Road SW11 4PX London 21 | British | Investment Manager | 29500910001 | |||||
ONG, Chee-Cheong Nicholas | Geschäftsführer | 22524 Se 46th Place 98075 Sammamish King, Washington Usa | Singaporean | Businessman | 116583490001 | |||||
PRESCOTT, Graham Mark | Geschäftsführer | 2 Akerly Drive CB23 6DB Lower Cambourne Cambridge | British | Businessman | 122311300001 | |||||
QUYSNER, David William | Geschäftsführer | 82 Burbage Road SE24 9HE London | British | Investment Manager | 13966350001 | |||||
SMITH, Leslie | Geschäftsführer | Sherborne Barn Church Road GL7 5NR Bibury Gloucestershire | England | British | Businessman | 158242090001 | ||||
SZE, Victor | Geschäftsführer | 12525 Chadron Avenue Hawthorne California Usa | American | Lawyer | 96197410001 |
Hat BLEASE MEDICAL HOLDINGS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Erstellt am 23. Nov. 2004 Geliefert am 01. Dez. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Feb. 2004 Geliefert am 09. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 07. Feb. 2000 Geliefert am 16. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 15. Feb. 1996 Geliefert am 27. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0