ST. JAMES CAPITAL PROPERTIES LIMITED

ST. JAMES CAPITAL PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameST. JAMES CAPITAL PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03121454
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ST. JAMES CAPITAL PROPERTIES LIMITED?

    • (7011) /
    • (7499) /

    Wo befindet sich ST. JAMES CAPITAL PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    10 Gloucester Place
    W1U 8EZ London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ST. JAMES CAPITAL PROPERTIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ST. JAMES CAPITAL CONSTRUCTION LIMITED26. Jan. 199926. Jan. 1999
    FLINTHAVEN LTD02. Nov. 199502. Nov. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ST. JAMES CAPITAL PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für ST. JAMES CAPITAL PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Robert Coffer am 23. Juni 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Mai 2011

    Kapitalaufstellung am 05. Mai 2011

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Anthony Lyons als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2010

    5 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Simon Alexander Malcolm Conway am 01. Nov. 2010

    2 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Alexander Malcolm Conway am 01. Nov. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2009

    5 SeitenAA

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2008

    8 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2007

    6 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von ST. JAMES CAPITAL PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CONWAY, Simon Alexander Malcolm
    Gloucester Place
    Portman Square
    W1U 8EZ London
    10
    United Kingdom
    Sekretär
    Gloucester Place
    Portman Square
    W1U 8EZ London
    10
    United Kingdom
    British88608520001
    COFFER, David Robert
    Cavendish Mews South
    W1W 6LB London
    6
    England
    Geschäftsführer
    Cavendish Mews South
    W1W 6LB London
    6
    England
    EnglandBritishCompany Director67222950003
    CONWAY, Simon Alexander Malcolm
    Gloucester Place
    Portman Square
    W1U 8EZ London
    10
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gloucester Place
    Portman Square
    W1U 8EZ London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director88608520001
    CONWAY, Susan Kathryn Rosemary
    10 Dyke Close
    BN3 6DB Hove
    East Sussex
    Sekretär
    10 Dyke Close
    BN3 6DB Hove
    East Sussex
    British43462190001
    SECRETAIRE LIMITED
    3rd Floor 4 Luke Street
    EC2A 4NT London
    Sekretär
    3rd Floor 4 Luke Street
    EC2A 4NT London
    41315550002
    TEMPLES (NOMINEES) LIMITED
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    Bevollmächtigter Sekretär
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    900004500001
    CONWAY, Rhona
    7 Wadham Gardens
    Hampstead
    NW3 3DN London
    Geschäftsführer
    7 Wadham Gardens
    Hampstead
    NW3 3DN London
    BritishDirector61220530001
    CONWAY, Simon Alexander Malcolm
    10 Dyke Close
    BN3 6DB Hove
    East Sussex
    Geschäftsführer
    10 Dyke Close
    BN3 6DB Hove
    East Sussex
    BritishCompany Director38531640001
    LYONS, Anthony
    Lyndhurst Road
    Hampstead
    NW3 5NX London
    22
    Geschäftsführer
    Lyndhurst Road
    Hampstead
    NW3 5NX London
    22
    EnglandBritishCompany Director117463490003
    TEMPLES (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    900004490001

    Hat ST. JAMES CAPITAL PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Mai 2006
    Geliefert am 12. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The manners arms london road grantham t/no LL89477. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Private Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 12. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 02. Mai 2006
    Geliefert am 12. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Private Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 12. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Cash deposit deed
    Erstellt am 24. Juni 2005
    Geliefert am 05. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit balance and the amounts required to make good any loss or damage. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Catalyst Sixth Concorde (General Partner) Limited and Catalyst Sixth Concorde (Nominee) Limited
    Transaktionen
    • 05. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 10. März 2004
    Geliefert am 24. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee (and/or to the hedging counterparty and/or any associated company) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the additional property by way of first fixed charge the additional assets.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The Lender)
    Transaktionen
    • 24. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 21. Nov. 2003
    Geliefert am 04. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The additional property, the additional property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 28. März 2003
    Geliefert am 04. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee (and/or the hedging counterparty and/or any associated company) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the additional property being l/h property f/h property 5 queen street, wolverhampton t/n WM521305; f/h property hippodrome house, 11 guildhall walk, portsmouth t/n HP142085; f/h property 7, 9, 11 bull plain, hertford t/n H9329881. By way of first fixed charge the additional assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 25. März 2003
    Geliefert am 04. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee (and/or the hedging counterparty and/or any associated company) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the additional property, being f/h property at the onslow arms and land to the rear of anlaby, the street, west clandon, near guildford, surrey, t/ns SY599960 and SY570069 and land subject to a transfer dated 13/09/02 being land to the north of title number SY599960 (part of t/n SY430009). By way of first fixed charge the additional assets,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 25. März 2003
    Geliefert am 04. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee (and/or the hedging counterparty and/or any associated company) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the additional property being l/h property 74 and 74A park street, bristol t/n BL65668. By way of first fixed charge the additional assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 15. Jan. 2003
    Geliefert am 28. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property and the additional assets (the f/h land k/a 1A clarendon avenue leamington spa warwickshire CV32 5QU title absolute t/n WK288829. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 28. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 20. Dez. 2002
    Geliefert am 23. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee (and/or to the hedging counterparty and/or any associated company) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the additional property being ground floor and upper ground commercial premises royal hospital site west street sheffield part of t/n SYK121408. By way of fixed charge the additional assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 06. Dez. 2002
    Geliefert am 18. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the lender (and/or to the hedging counterparty and/or any associated company) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    1. by way of first legal mortgage the additional property, 2. by way of first fixed charge the additional assets.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 22. Nov. 2002
    Geliefert am 04. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the lender (and/or to the hedging counterparty and/or any associated company) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    1. by way of first legal mortgage the additional property, 2. by way of first fixed charge the additional assets.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC, the Lender
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 17. Sept. 2002
    Geliefert am 24. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (and/or to the hedging counterparty, if any) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the additional property, by way of first fixed charge the additional assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 05. Sept. 2002
    Geliefert am 24. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (and/or to the hedging counterparty, if any) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the additional property, by way of first fixed charge the additional assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 26. Juli 2002
    Geliefert am 31. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the lender (and/or to the hedging counterparty and/or any associated company) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 ordinary share in the new guarantor together with all related stocks shares and other securities offered by way of redemption bonus preference or option or otherwise and any related income offer right or benefit and to the extent not otherwise charged by the finance documents any income offer right or benefit in respect of any such investment (the shares).
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 31. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 26. Juni 2002
    Geliefert am 10. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee (and/or to the hedging counterparty and/or any associated company) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The leasehold property known as the granary, welshback, bristol t/no: AV237201 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 10. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Mai 2002
    Geliefert am 07. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the lender (and/or to the hedging counterparty and/or any associated company) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold land known as 136 shaftesbury avenue london WC2 t/n NGL520830, the north pole hotel north pole road kensington W10 6QH t/n NGL477712 and 136 upper richmond road SW15 2SP t/n SGL305087. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of set off
    Erstellt am 27. Juli 2001
    Geliefert am 02. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies from time to time held to the credit of the company in or earnes by the company on a designated account (the deposit) maintained by the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juli 2001
    Geliefert am 02. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juli 2001
    Geliefert am 02. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that freehold land known as land and buildings on the east side of west sunniside sunderland tyne & wear title number TY365379 including all fixtures fittings plant and machinery thereon (other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1978).
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Apr. 2001
    Geliefert am 30. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as 136 upper richmond road putney london title number SGL305087. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 21. Dez. 2000
    Geliefert am 04. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever (under or pursuant to the society's commercial mortgage clauses 1991)
    Kurze Angaben
    All that f/h land k/a the north pole hotel north pole road kensington t/n NGL477712, together with all buildings erections fixtures fittings and fixed plant machinery and materials. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Newcastle Building Society
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of rents
    Erstellt am 21. Dez. 2000
    Geliefert am 04. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever (under or pursuant to the society's commercial mortgage clauses 1991)
    Kurze Angaben
    The benefit of all rents, licence or tenancy fee of the property k/a 111 high street huntingdonshire cambridgeshire t/n CB195802. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Newcastle Building Society
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of rents
    Erstellt am 16. Juni 2000
    Geliefert am 01. Juli 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Assignment of the benefit of all rents licence or tenancy fees payable by any lessee licensee or tenant of any part of the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Newcastle Building Society
    Transaktionen
    • 01. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Juni 2000
    Geliefert am 01. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h land and buildings at ground floor and basement 104 the broadway wimbledon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Newcastle Building Society
    Transaktionen
    • 01. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0