CHELSEA STORES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CHELSEA STORES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03123019 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHELSEA STORES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich CHELSEA STORES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O MAZARS LLP 45 Church Street B3 2RT Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CHELSEA STORES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DAISY & TOM LIMITED | 15. Apr. 1996 | 15. Apr. 1996 |
| GEOPLITE LIMITED | 07. Nov. 1995 | 07. Nov. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHELSEA STORES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHELSEA STORES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 4 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Cherry Tree Road Watford Hertfordshire WD24 6SH am 17. Apr. 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 11 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Simon Harrington als Geschäftsführer am 20. Juli 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Harminder Singh Atwal als Direktor am 20. Juli 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 5 Seiten | MA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 19 Seiten | MG01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Helen Mary Bramall als Sekretär am 22. Feb. 2012 | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Ernennung von Lynne Samatha Medini als Sekretär am 22. Feb. 2012 | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 26. März 2011 | 11 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joanna Boydell als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Neil Harrington als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Joanna Boydell am 01. Nov. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Helen Mary Bramall am 01. Nov. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Timothy John Ashby als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CHELSEA STORES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDINI, Lynne Samatha | Sekretär | Church Street B3 2RT Birmingham 45 | British | 167184950001 | ||||||
| ASHBY, Timothy John | Geschäftsführer | Church Street B3 2RT Birmingham 45 | Great Britain | British | 162876770001 | |||||
| ATWAL, Harminder Singh | Geschäftsführer | Church Street B3 2RT Birmingham 45 | United Kingdom | British | 167976490001 | |||||
| BRAMALL, Helen Mary | Sekretär | Cherry Tree Road WD24 6SH Watford Hertfordshire | British | 59695650001 | ||||||
| DWYER, Daniel John | Bevollmächtigter Sekretär | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
| EMERSON, Matthew Charles | Sekretär | 12 Niton Road TW9 4LH Richmond Surrey | British | 61777750001 | ||||||
| JONES, Gavin Stewart | Sekretär | 25 The Drive Henleaze BS9 4LD Bristol Avon | British | 116097830001 | ||||||
| MUGRIDGE, Nicholas John | Sekretär | 88 Durham Road East Finchley N2 9DS London | British | 72460430004 | ||||||
| RAYNOR, Pamela Rose | Sekretär | 26 Stormont Road N6 4NP London | British | 51267950001 | ||||||
| SELBER, Kimberley Lynn | Sekretär | 1 Bellevue Road Barnes SW13 0BJ London | Us | 97940820001 | ||||||
| THOMPSON, Nicholas Raymond | Sekretär | Eynella Road East Dulwich SE10 8HR London 4 United Kingdom | British | 134102250001 | ||||||
| ALDWYCH SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 6th Floor 81 Aldwych WC2B 4RP London | 4238520001 | |||||||
| BOYDELL, Joanna | Geschäftsführer | Cherry Tree Road WD24 6SH Watford Hertfordshire | England | British | 118883430001 | |||||
| BROLLY, Brian Thomas | Geschäftsführer | Kitts Quarry Upton Bye Burford OX18 4LU Burford Oxfordshire | British | 54192370002 | ||||||
| DOYLE, Betty June | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 8 The Bartons Elstree Hill North WD6 3EN Elstree Herts | British | 900003960001 | ||||||
| DWYER, Daniel John | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
| GIFFIN, Michael William | Geschäftsführer | 73c Chesilton Road Fulham SW6 5AA London | British | 73418870001 | ||||||
| HARRINGTON, Neil Simon | Geschäftsführer | Cherry Tree Road WD24 6SH Watford Hertfordshire | England | British | 157815820001 | |||||
| HOLMES, Andrew Peter Geoffrey | Geschäftsführer | 51 Doneraile Street SW6 6EW London | England | British | 21151650001 | |||||
| HOWELL, Peter Graham | Geschäftsführer | 76 Kings Road SW19 8QW London | Uk | British | 62634010001 | |||||
| JONES, Gavin Stewart | Geschäftsführer | 25 The Drive Henleaze BS9 4LD Bristol Avon | England | British | 116097830001 | |||||
| LANDERS, Brian James | Geschäftsführer | Briarbank House 12a Childs Hill Road KT23 3QG Bookham Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | 90246320001 | |||||
| NEWMAN, Ian Kevin | Geschäftsführer | 6 Greenhill Road GU9 8JN Farnham Surrey | British | 145115790001 | ||||||
| RAINER, Michael James | Geschäftsführer | 98 Castellain Mansions Castellain Road W9 1HB London | United Kingdom | British | 14442650003 | |||||
| RAWNSLEY, Janet Lynn | Geschäftsführer | Heywood Cottage 6 Clifton Street SK9 7NW Alderley Edge Cheshire | British | 101826160001 | ||||||
| RAYNOR, Pamela Rose | Geschäftsführer | 26 Stormont Road N6 4NP London | United Kingdom | British | 51267950001 | |||||
| REVETT, Clive Edward | Geschäftsführer | 53 Riversdell Close KT16 9JW Chertsey Surrey | United Kingdom | British | 16023450001 | |||||
| ROBERTSON, Nigel Mark Inches | Geschäftsführer | Ashworth House Westonbirt GL8 8QJ Tetbury Gloucestershire | British | 97170790001 | ||||||
| SELBER, Kimberley Lynn | Geschäftsführer | 1 Bellevue Road Barnes SW13 0BJ London | Us | 97940820001 | ||||||
| STEPHENSON, Elizabeth Jane | Geschäftsführer | 92 Potter Street HA5 3XE Pinner Middlesex | British | 79527850001 | ||||||
| THOMAS, Sian Elizabeth | Geschäftsführer | 1 Olive Hill Cottages Wick Rissington GL54 2PW Cheltenham Gloucestershire | British | 65979870001 | ||||||
| THOMPSON, Nicholas Raymond | Geschäftsführer | Eynella Road East Dulwich SE10 8HR London 4 United Kingdom | England | British | 134102250001 | |||||
| THOMSON, Christopher Harold William | Geschäftsführer | 27 Ashchurch Park Villas W12 9SP London | British | 50470780001 | ||||||
| TOMBLIN, Denise Lynne | Geschäftsführer | 20 Bell Crescent Longwick HP27 9SE Princes Risborough Buckinghamshire | United Kingdom | British | 63502600001 | |||||
| WALSH, Wilfred Thomas | Geschäftsführer | Acorn Lodge Saint Huberts Lane SL9 7BP Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 63955050003 |
Hat CHELSEA STORES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 11. Apr. 2012 Geliefert am 26. Apr. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 11. Aug. 2006 Geliefert am 30. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 181/183 kings road chelsea t/no BGL20895 118/124 deansgate and 44/56 king street west manchester t/no GM750858 and l/h 17/19 watergate row chester (for detailsof further properties charged please ref. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 15. Dez. 2004 Geliefert am 17. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £262,500.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The indebtedness and the deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 02. Apr. 2004 Geliefert am 15. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the security trustee and the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 181/183 kings road chelsea t/n BGL20895, 118/124 deansgate and 44/56 kkings street west manchester t/n GL750858, l/h land and buildings known as 17/19 watergate row chester, for details of further properties charged, please refer to form 39. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Juli 2003 Geliefert am 31. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Mai 2003 Geliefert am 23. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Dez. 2002 Geliefert am 20. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Sept. 2002 Geliefert am 08. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 02. Aug. 2002 Geliefert am 10. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All monies held in a rent deposit account under a rent deposit deed dated 02/08/02 in respect of 17-19 watergate row chester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 29. Juli 2002 Geliefert am 03. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All interest in the deposit,as defined (in respect of the premises known as units WVL18 and WV02 weest mall bluewater kent). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Jan. 2002 Geliefert am 11. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A rent deposit deed | Erstellt am 26. Nov. 2001 Geliefert am 28. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly k/a daisy & tom limited to the chargee under the lease | |
Kurze Angaben The deposit and each and every debt represented by it. An initial deposit of £262,500. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Juli 2000 Geliefert am 08. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in accordance with the loan stock instrument | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A rent deposit deed | Erstellt am 17. Nov. 1999 Geliefert am 26. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease | |
Kurze Angaben The deposit or sums standing to the credit of the account including an initial deposit of £262,500 in an interest bearing designated account to be opened by the landlord with midland bank PLC, 1 sydney place, onslow square, south kensington, london SW7 3NW. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rental deposit deed | Erstellt am 08. Apr. 1999 Geliefert am 17. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date | |
Kurze Angaben Rent deposit of £49,790. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of rental deposit | Erstellt am 25. Juni 1998 Geliefert am 13. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in the event of default | |
Kurze Angaben The company's interest in the deposit account as defined in the deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 11. März 1998 Geliefert am 20. März 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a 181 & 183 kings road chelsea london t/n BGL20895. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 27. Jan. 1998 Geliefert am 04. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 118-124 (even) deansgate and 44-56 (even) king street west manchester t/n GM750858. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 27. Nov. 1997 Geliefert am 05. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 14. Apr. 1997 Geliefert am 26. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property at 181-183 kings road, london SW3 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits contracts, deeds, undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights in any management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease, licence or other interest created in respect of the property; and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 18. März 1997 Geliefert am 05. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 18TH march 1997 | |
Kurze Angaben £24,357 rent and service charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 12. März 1997 Geliefert am 22. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 24. Feb. 1997 Geliefert am 01. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £360,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The rent deposit of £360,000. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Agreement for lease | Erstellt am 13. Nov. 1996 Geliefert am 27. Nov. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £360,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of clause 5 of the agreement | |
Kurze Angaben The "performance deposit" being the sum of £360,000. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CHELSEA STORES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0