KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED

KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKRUPACO FINANCE (UK) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03123030
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED?

    • Sonstige Kreditvergabe n.n.a. (64929) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o TAYLOR WESSING LLP
    5 New Street Square
    EC4A 3TW London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LOGANPARK LIMITED07. Nov. 199507. Nov. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    7 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 31. Dez. 2014

    LRESSP

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Nov. 2014

    Kapitalaufstellung am 07. Nov. 2014

    • Kapital: USD 10,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    16 SeitenAA

    Ernennung von Mr. David Angel als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Arthur Custance als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 06. Nov. 2013

    • Kapital: USD 10,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    16 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 27. Dez. 2012

    • Kapital: USD 10,000
    4 SeitenSH19

    legacy

    3 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Sean Clancy als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Janet Shulist als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    17 SeitenAA

    legacy

    2 SeitenSH20

    Wer sind die Geschäftsführer von KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SHULIST, Janet
    Bedford Road
    H3S 1G5 Montreal
    3285
    Quebec
    Canada
    Sekretär
    Bedford Road
    H3S 1G5 Montreal
    3285
    Quebec
    Canada
    164777480001
    ANGEL, David, Mr.
    c/o Kruger Inc.
    Bedford Road
    H3S 1G5 Montreal
    3285
    Quebec
    Canada
    Geschäftsführer
    c/o Kruger Inc.
    Bedford Road
    H3S 1G5 Montreal
    3285
    Quebec
    Canada
    CanadaCanadian188887190001
    BUNZE, George John
    238 St Raphael
    Ile Bizard Montreal
    FOREIGN Quebec
    H9e 1sz
    Geschäftsführer
    238 St Raphael
    Ile Bizard Montreal
    FOREIGN Quebec
    H9e 1sz
    CanadaCanadian34173550002
    GELBER, David
    6 Clorane Gardens
    NW3 7IR London
    Geschäftsführer
    6 Clorane Gardens
    NW3 7IR London
    United KingdomCanadian9565460001
    KRUGER II, Joseph
    c/o Taylor Wessing Llp
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Taylor Wessing Llp
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    CanadaCanadian32125150003
    CLANCY, Sean Aidan
    c/o Taylor Wessing Llp
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Sekretär
    c/o Taylor Wessing Llp
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    British36561400004
    SCOTT, Andrew Munro
    106 Aylmer Road
    W12 9LQ London
    Sekretär
    106 Aylmer Road
    W12 9LQ London
    British67475550002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    CUSTANCE, Arthur Brian
    c/o Taylor Wessing Llp
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Taylor Wessing Llp
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    CanadaCanadian48513480007
    GRAHAM, Kenneth
    30 Mill Lane
    Linton
    CB1 6JY Cambridge
    Geschäftsführer
    30 Mill Lane
    Linton
    CB1 6JY Cambridge
    British48815960003
    HUEY EVANS, Gay
    9 Eaton Mansions
    Cliveden Place
    SW1W 8HE London
    Geschäftsführer
    9 Eaton Mansions
    Cliveden Place
    SW1W 8HE London
    United KingdomAmerican81476710001
    JANSSEN, Claude
    7 Avenue Emile Acollas
    75007 Paris
    France
    Geschäftsführer
    7 Avenue Emile Acollas
    75007 Paris
    France
    French48837570001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    STURGEON, Colin Lindsay
    44 Thames Quay
    Chelsea Harbour
    SW10 0UY Chelsea
    London
    Geschäftsführer
    44 Thames Quay
    Chelsea Harbour
    SW10 0UY Chelsea
    London
    British81928860002

    Hat KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Subordinated security agreement
    Erstellt am 08. Nov. 2004
    Geliefert am 11. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the subordinated beneficiaries and each of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the accounts and the collateral and the custodian agreements,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Computershare Trust Company of Canada (Subordinated Collateral Agent)
    Transaktionen
    • 11. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security agreement
    Erstellt am 03. Aug. 2004
    Geliefert am 09. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from krupaco UK to the credit agreement beneficiaries and each of them, to the other creditor beneficiaries and each of them, to the other hedging creditor beneficiaries and each of them. Under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of it rights title and interest in and to the accounts and the collateral to the senior collateral agent. All of its rights title and interest in and to the custodian agreements to the senior collateral agent. By way of first floating charge for the benefit of the beneficiaries and each of them all its assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bny Trust Corporation (The Senior Collateral Agent)
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Subordinated security agreement between the company and montreal trust company
    Erstellt am 06. Aug. 1998
    Geliefert am 21. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All liabilities and obligations of the company to the subordinated beneficiaries, and each of them, under the subordinated guarantee, under the senior and the subordinated debt intercreditor agreement and the subordinated debt intercreditor agreement, and under each agreement or instrument to which the company is a party
    Kurze Angaben
    The cash assets the custodian agreements and all property from time to time including the loan receivables and all other securities all dividends interest and other income therefrom and all claims in respect of those amounts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Montreal Trust Company (Subordinated Collateral Agent)
    Transaktionen
    • 21. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Subordinated security agreement between the company and montreal trust company
    Erstellt am 06. Aug. 1998
    Geliefert am 21. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All liabilities and obligations of the company to the subordinated beneficiaries, and each of them, under the subordinated guarantee, under the senior and the subordinated debt intercreditor agreement and the subordinated debt intercreditor agreement, and under each agreement or instrument to which the company is a party
    Kurze Angaben
    All right title benefit and interest in and under the guernsey custodian agreement and the cash assets all property including the loan receivables and all other securities dividends interest other income and rights from or incidental to the foregoing. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Montreal Trust Company (The Subordinated Collateral Agent)
    Transaktionen
    • 21. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security agreement
    Erstellt am 05. Aug. 1998
    Geliefert am 21. Aug. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee, each other loan document and/or the other creditor hedging contracts
    Kurze Angaben
    By way of assignment by way of security the collateral.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Trust Company of Bank of Montreal(The "Senior Collateral Agent")
    Transaktionen
    • 21. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 05. Aug. 1998
    Geliefert am 21. Aug. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee, each other loan document and/or the other creditor hedging contracts
    Kurze Angaben
    By way of assignment all of its rights title and interest in and to the accounts and the collateral to the senior collateral agent; all of its rights title and interest in and to the custodian agreements to the senior collateral agent; by way of first floating charge all its assets not otherwise effectively mortgaged or charged by way of fixed mortgage charge or security interest.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Trust Company of Bank of Montreal(The "Senior Collateral Agent")
    Transaktionen
    • 21. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)

    Hat KRUPACO FINANCE (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    31. Dez. 2014Beginn der Liquidation
    24. Dez. 2015Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Praktiker
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0