BARWOOD LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BARWOOD LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03123814 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BARWOOD LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich BARWOOD LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 4 Waterside Way NN4 7XD Northampton England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BARWOOD LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
BARWOOD DEVELOPMENTS LIMITED | 07. Feb. 1996 | 07. Feb. 1996 |
INGLEBY (862) LIMITED | 08. Nov. 1995 | 08. Nov. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BARWOOD LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Aug. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BARWOOD LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Nov. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 31. Aug. 2020 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen John Chambers als Sekretär am 19. Mai 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 31. Aug. 2019 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Nov. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Aug. 2018 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Nov. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Grange Park Court Roman Way Northampton Northamptonshire NN4 5EA zum 4 Waterside Way Northampton NN4 7XD am 03. Mai 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Aug. 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Notification of Richard William Bowen as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Withdrawal of a person with significant control statement on 05. Feb. 2018 | 2 Seiten | PSC09 | ||||||||||
Notification of Terence Philip Amos as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Notification of Alan James Rudge as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 01. Feb. 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Nov. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Nov. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 28. Feb. 2016 bis 31. Aug. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BARWOOD LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMW SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Seebeck House One Seebeck Place, Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Buckinghamshire | 93910510003 | |||||||
AMOS, Terence Philip | Geschäftsführer | Waterside Way NN4 7XD Northampton 4 England | United Kingdom | British | Company Director | 71757170002 | ||||
BOWEN, Richard William | Geschäftsführer | Waterside Way NN4 7XD Northampton 4 England | United Kingdom | British | Company Director | 151921790001 | ||||
RUDGE, Alan James | Geschäftsführer | Waterside Way NN4 7XD Northampton 4 England | United Kingdom | British | Company Director | 9647250002 | ||||
AMOS, Terence Philip | Sekretär | The Brambles Bates Lane, Souldern OX27 7JU Bicester Oxfordshire | British | 71757170001 | ||||||
CHAMBERS, Stephen John | Sekretär | Waterside Way NN4 7XD Northampton 4 England | British | 64382980002 | ||||||
CHAMBERS, Stephen John | Sekretär | Knapwell Farm Vicarage Lane Podington NN29 7HR Wellingborough Northamptonshire | British | 64382980002 | ||||||
INGLEBY NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007860001 | |||||||
BLACK, Ian Craig | Geschäftsführer | Church View 25 Sywell Road Overstone NN6 0AQ Northampton Northamptonshire | British | Chartered Accountant | 4579780001 | |||||
CHAMBERS, Stephen John | Geschäftsführer | Knapwell Farm Vicarage Lane Podington NN29 7HR Wellingborough Northamptonshire | United Kingdom | British | Company Director | 64382980002 | ||||
LAWTHER, Samuel David | Geschäftsführer | Dean House Upper Dean PE18 0ND Huntingdon Cambridgeshire | British | Chartered Accountant | 41835460001 | |||||
MATTHEWS, Christian Peter | Geschäftsführer | Stanmore Lodge Nottingham Road South WD3 5DN Heronsgate Hertfordshire | United Kingdom | British | Property Developer | 83756390001 | ||||
INGLEBY HOLDINGS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007850001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BARWOOD LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
---|---|---|---|
Terence Philip Amos | 06. Apr. 2016 | Waterside Way NN4 7XD Northampton 4 England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Richard William Bowen | 06. Apr. 2016 | Waterside Way NN4 7XD Northampton 4 England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Mr Alan James Rudge | 06. Apr. 2016 | Waterside Way NN4 7XD Northampton 4 England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
|
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für BARWOOD LIMITED?
Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
---|---|---|
08. Nov. 2016 | 29. Jan. 2018 | Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen. |
Hat BARWOOD LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Erstellt am 18. Feb. 2003 Geliefert am 21. Feb. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Land adjoining unit a telford point telford way milton keynes. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of benefit of agreement | Erstellt am 18. Feb. 2003 Geliefert am 21. Feb. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All rights benefits and interests of the company under a contract dated 14 july 2002 (the agreement) including any guarantees or security which the company may have all other rights and remedies accorded to it all debts and claims present and future in connection with the agreement and all rights of enforcing the agreement. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of the benefit of an agreement | Erstellt am 03. Sept. 2002 Geliefert am 13. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All rights benefits and interests both present and future under the agreement. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 09. Aug. 2002 Geliefert am 10. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 09. Juli 2002 Geliefert am 20. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of the benefit of an agreement | Erstellt am 11. Dez. 2000 Geliefert am 22. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All rights benefits and interest of the company present and future under the agreement realting to the sale of f/h property situated on the south east side of edmund street birmingham dated 28.09.2000. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security deposit deed | Erstellt am 16. Juni 2000 Geliefert am 27. Juni 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or of a finance agreement dated 30 march 1999 | |
Kurze Angaben A separate designated deposit account with barwood development limited's bankers being an account into which the deposit is to be paid in accordance with the terms of the security deposit deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 10. Apr. 2000 Geliefert am 28. Apr. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The obligations of the company to the chargee contained in a funding agreement dated 3RD march 2000 | |
Kurze Angaben Plot 2 warwick technology park warwick by way of first fixed equitable charge over any beneficial interest that the company may have from time to time in the property .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 23. Dez. 1999 Geliefert am 08. März 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H orchard house rockingham drive linford wood milton keynes t/n BM102951. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 16. Apr. 1996 Geliefert am 23. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0