OYEZSTRAKER OFFICE ENVIRONMENTS LIMITED

OYEZSTRAKER OFFICE ENVIRONMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameOYEZSTRAKER OFFICE ENVIRONMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03124170
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von OYEZSTRAKER OFFICE ENVIRONMENTS LIMITED?

    • (7487) /

    Wo befindet sich OYEZSTRAKER OFFICE ENVIRONMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Unit 4 500 Purley Way
    Croydon
    CR0 4NZ Surrey
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von OYEZSTRAKER OFFICE ENVIRONMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    OYEZ STRAKER OFFICE ENVIRONMENTS LIMITED01. Jan. 199801. Jan. 1998
    STRAKER OFFICE ENVIRONMENTS LIMITED12. März 199612. März 1996
    RAYSTAR SERVICES LTD09. Nov. 199509. Nov. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OYEZSTRAKER OFFICE ENVIRONMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für OYEZSTRAKER OFFICE ENVIRONMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 18. Dez. 2009

    • Kapital: GBP 0.50
    4 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    7 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    13 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    15 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten190

    Wer sind die Geschäftsführer von OYEZSTRAKER OFFICE ENVIRONMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MAYNARD, Philippa Anne
    7 Gilhams Avenue
    SM7 1QL Banstead
    Surrey
    Sekretär
    7 Gilhams Avenue
    SM7 1QL Banstead
    Surrey
    BritishCompany Secretary44140850002
    EWART SMITH, Michael
    The Long Cottage
    High Street, Old Bursledon
    SO31 8DL Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The Long Cottage
    High Street, Old Bursledon
    SO31 8DL Southampton
    Hampshire
    EnglandBritishDirector73942450001
    WHITEWAY, Jeffrey Michael
    69 Ashley Road
    KT18 5BN Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    69 Ashley Road
    KT18 5BN Epsom
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director14385570002
    TEMPLES (NOMINEES) LIMITED
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    Bevollmächtigter Sekretär
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    900004500001
    COX, David
    Marloes
    Comp Lane St Marys Platt
    TN15 8NR Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Marloes
    Comp Lane St Marys Platt
    TN15 8NR Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director70818680001
    EADES, Lisa Anne
    4 Moorland Road
    Maidenbower
    RH10 7JB Crawley
    West Sussex
    Geschäftsführer
    4 Moorland Road
    Maidenbower
    RH10 7JB Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritishAccountant40576530004
    GOODRIDGE, David Alan
    91 College Road
    ME15 6TF Maidstone
    Kent
    Geschäftsführer
    91 College Road
    ME15 6TF Maidstone
    Kent
    BritishSales Dir25206720001
    HODGES, Nicholas Robin
    Ramsau 1 Ware Leys Close
    Marsh Gibbon
    OX6 0EN Bicester
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Ramsau 1 Ware Leys Close
    Marsh Gibbon
    OX6 0EN Bicester
    Oxfordshire
    BritishCompany Director48585350002
    LENNARD, Andrew Dacre
    Pheasant Hill House
    Kemble
    GL7 6AW Cirencester
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Pheasant Hill House
    Kemble
    GL7 6AW Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritishAccountant68152930001
    MCCALLUM, Alexander James
    28 Ouseley Road
    SW12 8EF London
    Geschäftsführer
    28 Ouseley Road
    SW12 8EF London
    United KingdomBritishAccountant93679470001
    PITT, Derek Neil
    52 Albany Drive
    CT6 8PX Herne Bay
    Kent
    Geschäftsführer
    52 Albany Drive
    CT6 8PX Herne Bay
    Kent
    BritishDirector14385530005
    RIDLEY, Henry Thomas
    86 Keston Avenue
    CR5 1HN Coulsdon
    Surrey
    Geschäftsführer
    86 Keston Avenue
    CR5 1HN Coulsdon
    Surrey
    EnglishCommercial Manager18257270001
    SEAR, Hugh Edward
    1 Lynwood Avenue
    KT17 4LQ Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 Lynwood Avenue
    KT17 4LQ Epsom
    Surrey
    EnglandEnglishCompany Director47246600001
    SPEAR, David John
    8 Blunden Drive
    RH17 5HU Cuckfield
    Sussex
    Geschäftsführer
    8 Blunden Drive
    RH17 5HU Cuckfield
    Sussex
    EnglandBritishDirector147074890001
    STRAKER, Jonathan
    9 Campden Road
    CR2 7EQ South Croydon
    Surrey
    Geschäftsführer
    9 Campden Road
    CR2 7EQ South Croydon
    Surrey
    BritishMarketing Director10770260001
    TEMPLES (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    900004490001

    Hat OYEZSTRAKER OFFICE ENVIRONMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 03. Apr. 2003
    Geliefert am 10. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC acting in its capacity as security agent for itself and those other lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 03. Apr. 2003
    Geliefert am 10. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee and debenture of even date made between oyezstraker group limited and certain of its subsidiaries (as charging companies) (as defined)
    Erstellt am 30. Apr. 2001
    Geliefert am 15. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities at the time by the security agent due , owing or incurred to each beneficiary by (a) the charging company under or pursuant to the senior finance documents; or (b) by each other company (except for sums owed by such company in its capacity as a guarantor for the charging company) under or pursuant to the senior finance documents (all terms defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 01. Sept. 1997
    Geliefert am 11. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or by any other group company as defined therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and Bank of Scotland Treasury Services PLC
    Transaktionen
    • 11. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0