OFFICE PROPERTIES PL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | OFFICE PROPERTIES PL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Liquidation |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03125437 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Uhy Hacker Young Llp Quadrant House 4 Thomas More Square E1W 1YW London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MWB PROPERTY LIMITED | 01. Juli 2008 | 01. Juli 2008 |
| MARYLEBONE WARWICK BALFOUR GROUP PLC | 01. Juli 1997 | 01. Juli 1997 |
| EX-LANDS PROPERTIES PLC | 08. Nov. 1995 | 08. Nov. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2018 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2019 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 31. Okt. 2019 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 14. Nov. 2019 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 31. Okt. 2018 |
| Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernennung von Ms Joanne Constance Bushell als Direktor am 17. Okt. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Wayne David Berger als Geschäftsführer am 03. Okt. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Juni 2025 | 17 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Juni 2024 | 17 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Ernennung von Mr. Wayne David Berger als Direktor am 31. Mai 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr. Gavin Steven Phillips als Direktor am 31. Mai 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Morris als Geschäftsführer am 31. Mai 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Juni 2023 | 17 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Juni 2022 | 17 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Juni 2021 | 20 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Sept. 2020 | 18 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter David Edward Gibson als Geschäftsführer am 28. Okt. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 6 Snow Hill London EC1A 2AY zum Uhy Hacker Young Llp Quadrant House 4 Thomas More Square London E1W 1YW am 07. Okt. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Rücktritt eines Liquidators | 3 Seiten | LIQ06 | ||||||||||
Rücktritt eines Liquidators | 3 Seiten | LIQ06 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 4 Seiten | 600 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Burwood Place London W2 2UT England zum 6 Snow Hill London EC1A 2AY am 22. Juli 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht | 10 Seiten | LIQ02 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2018 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSHELL, Joanne Constance | Geschäftsführer | Quadrant House 4 Thomas More Square E1W 1YW London Uhy Hacker Young Llp | South Africa | British | 341942760001 | |||||||||
| PHILLIPS, Gavin Steven, Mr. | Geschäftsführer | Quadrant House 4 Thomas More Square E1W 1YW London Uhy Hacker Young Llp | England | British | 324092780001 | |||||||||
| CAVE, Ian Bruce | Sekretär | 392 Woodstock Road OX2 8AF Oxford Oxfordshire | British | 102741680001 | ||||||||||
| CROSSLEY, James Daniel | Sekretär | 34 Bellevue Road CM12 9HB Billericay Essex | British | 29059900001 | ||||||||||
| CITY GROUP PLC | Sekretär | City Road EC1Y 2AG London 30 England |
| 35794270004 | ||||||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||||||
| PITSEC LIMITED | Sekretär | Castle Street RG1 7SR Reading 47 England |
| 38734010001 | ||||||||||
| BALFOUR-LYNN, Richard Gary | Geschäftsführer | Connaught Square W2 2HG London 6 | United Kingdom | British | 34251500001 | |||||||||
| BERGER, Wayne David, Mr. | Geschäftsführer | Quadrant House 4 Thomas More Square E1W 1YW London Uhy Hacker Young Llp | England | Canadian | 323759890001 | |||||||||
| BIBRING, Michael Albert | Geschäftsführer | Conifers Hive Road WD23 1JG Bushey Heath Hertfordshire | England | British | 9320160002 | |||||||||
| BLURTON, Andrew Francis | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5LS London 179 | England | British | 53724380001 | |||||||||
| BOURNE, Graham Alexander | Geschäftsführer | Le Roccabella 24 Avenue Princess Grace Monte Carlo 98000 Monaco | United Kingdom | British | 76871220004 | |||||||||
| BOURNE, Robert Anthony | Geschäftsführer | 100 Cheyne Walk SW10 0DQ London | British | 70526160001 | ||||||||||
| BOUVIER, Alain Charles Patrice | Geschäftsführer | 32 Earls Court Square SW5 9DQ London | England | British | 24106110001 | |||||||||
| BURROW, Robert Philip | Geschäftsführer | 67 Brook Street W1K 4NJ London | England | British | 97252420005 | |||||||||
| CHENERY, Richard James | Geschäftsführer | Lower Slaughter GL54 2HP Cheltenham The Manor Cottage Gloucestershire United Kingdom | England | British | 146075610001 | |||||||||
| GIBSON, Peter David Edward | Geschäftsführer | Cromac Square BT2 8LA Belfast Forsyth House Northern Ireland | Northern Ireland | British | 139640170001 | |||||||||
| GIBSON, Peter David Edward | Geschäftsführer | Cromac Square BT2 8LA Belfast Forsyth House Northern Ireland | England | British | 235422380001 | |||||||||
| HARRISON, John William | Geschäftsführer | 97 Clifton Hill NW8 0JR London | United Kingdom | British | 69263980002 | |||||||||
| MARSHALL, David Courtnall | Geschäftsführer | Savannah House 32 Sherwood Road 4051 Durban North South Africa | South Africa | British | 132056360001 | |||||||||
| MORRIS, Richard | Geschäftsführer | Burwood Place W2 2UT London 1 England | England | British | 190653350001 | |||||||||
| MYERSON, Brian Alan | Geschäftsführer | 52 Winnington Road N2 0TY London | British | 63023520001 | ||||||||||
| PARKER, Christopher John | Geschäftsführer | Hill Place Station Road CM8 3JN Wickham Bishops Essex | British | 8218630001 | ||||||||||
| ROBOTHAM, John Michael | Geschäftsführer | Brickwall Farmhouse Kiln Lane Clophill MK45 4DA Bedford | England | British | 3914540001 | |||||||||
| ROBOTHAM, John Michael | Geschäftsführer | Brickwall Farmhouse Kiln Lane Clophill MK45 4DA Bedford | England | British | 3914540001 | |||||||||
| SANDERSON, Eric Fenton | Geschäftsführer | 10 Harelaw Road EH13 0DR Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 126848980001 | |||||||||
| SHASHOU, Joseph Saleem | Geschäftsführer | 28 Elm Tree Road NW8 9JT London | United Kingdom | Brazilian | 51723030002 | |||||||||
| SINGH, Jagtar | Geschäftsführer | West Garden Place Kendal Street W2 2AQ London 1 | United Kingdom | British | 121710890001 | |||||||||
| STARN, William Robert | Geschäftsführer | City Road EC1Y 2AG London 30 | England | American | 154007330001 | |||||||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 | |||||||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 38524190001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marley Acquisitions Limited | 11. Juli 2017 | Burwood Place W2 2UT London 1 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mwb Serviced Office Holdings Limited (In Liquidation) | 06. Apr. 2016 | Little New Street EC4A 3TR London Hill House England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat OFFICE PROPERTIES PL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over shares | Erstellt am 01. Aug. 2008 Geliefert am 13. Aug. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Entire right, title and interest in and to the 46,951,379 ordinary shares with a nominal value of £0.01 in the capital of mwb business exchange PLC together with all other shares in the capital of mwb business exchange PLC see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. März 2005 Geliefert am 14. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 03. Juni 2003 Geliefert am 16. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor or, any of them to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all inter-company debts. All the chargor's right, title and interest, present and future, in and to all inter-company debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 07. Aug. 2002 Geliefert am 14. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All shares and all related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Subordination agreement | Erstellt am 30. Mai 2002 Geliefert am 10. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any amounts held on trust for the agent towards the payment of all the senior liabilities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Subordination deed between 140 park lane limited flatford limited and flatford (no.2) limited as the obligors the company and nwb (park lane) limited as original junior creditors and the bank | Erstellt am 08. Jan. 2002 Geliefert am 18. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A security interest over the "junior liabilities". See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge | Erstellt am 28. Aug. 1997 Geliefert am 12. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from mwb (warwick road) limited to the chargee in connection with the loan agreement or any security document | |
Kurze Angaben By way of fixed charge the investments and all dividends interest and other money payable to the chargor in respect of the investments.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Feb. 1996 Geliefert am 09. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat OFFICE PROPERTIES PL LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0