DM&F LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDM&F LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03135040
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DM&F LIMITED?

    • (7487) /

    Wo befindet sich DM&F LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Willingale Road
    Braintree
    CM7 9FA Essex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von DM&F LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    VERTIS DIRECT RESPONSE LIMITED28. Dez. 200028. Dez. 2000
    COLORGRAPHIC DIRECT RESPONSE LIMITED26. März 199626. März 1996
    GOLDEN TENDER LIMITED06. Dez. 199506. Dez. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DM&F LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2003

    Welche sind die letzten Einreichungen für DM&F LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Ernennung von Dm&F Investments Limited als Direktor

    2 SeitenAP02

    Beendigung der Bestellung von Peter Martindale als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Umregistrierung

    RES02

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    legacy

    1 Seiten652a

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(353)

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten244

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von DM&F LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FOOKES, Richard Charles
    1 Willingale Road
    CM7 9FA Braintree
    Essex
    Sekretär
    1 Willingale Road
    CM7 9FA Braintree
    Essex
    BritishDirector81522540002
    FOOKES, Richard Charles
    1 Willingale Road
    CM7 9FA Braintree
    Essex
    Geschäftsführer
    1 Willingale Road
    CM7 9FA Braintree
    Essex
    United KingdomBritishDirector81522540002
    DM&F INVESTMENTS LIMITED
    Willingale Road
    CM7 9FA Braintree
    1
    Essex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Willingale Road
    CM7 9FA Braintree
    1
    Essex
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer03435268
    162247020001
    DEAN, Peter Mcavoy
    29 Garfield Park
    LE8 9JY Great Glen
    Leicestershire
    Sekretär
    29 Garfield Park
    LE8 9JY Great Glen
    Leicestershire
    British105407190001
    FISHER, Angus William Murray
    Coledown House
    Vicarage Lane, Curdridge
    S032 2DP Southampton
    Hants
    Sekretär
    Coledown House
    Vicarage Lane, Curdridge
    S032 2DP Southampton
    Hants
    BritishChartered Accountant122903010001
    LATHAM, Gregg John
    37 Pavilion Way
    HD9 5QN Meltham
    West Yorkshire
    Sekretär
    37 Pavilion Way
    HD9 5QN Meltham
    West Yorkshire
    British79794200003
    STEEL, Angus Kennedy
    Brewery Cottage
    Brockhampton
    GL54 5XQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Sekretär
    Brewery Cottage
    Brockhampton
    GL54 5XQ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector62259790003
    TAYLOR, Richard Scott
    The Stables Church Lane
    Dingley
    LE16 8PG Market Harborough
    Leicestershire
    Sekretär
    The Stables Church Lane
    Dingley
    LE16 8PG Market Harborough
    Leicestershire
    BritishChartered Accountant35333200002
    TAYLOR, Richard Scott
    The Stables Church Lane
    Dingley
    LE16 8PG Market Harborough
    Leicestershire
    Sekretär
    The Stables Church Lane
    Dingley
    LE16 8PG Market Harborough
    Leicestershire
    BritishChartered Accountant35333200002
    RUTLAND SECRETARIES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Bevollmächtigter Sekretär
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005290001
    ANGELSON, Mark Alan
    876 Park Avenue
    Penthouse North
    10021 New York
    Usa
    Geschäftsführer
    876 Park Avenue
    Penthouse North
    10021 New York
    Usa
    UsaSolicitor54679960003
    DEAN, Peter Mcavoy
    29 Garfield Park
    LE8 9JY Great Glen
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    29 Garfield Park
    LE8 9JY Great Glen
    Leicestershire
    EnglandBritishAccountant105407190001
    DIXON, Nicolas William
    Wix Farm
    Epsom Road West Horsley
    KT24 6DX Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Wix Farm
    Epsom Road West Horsley
    KT24 6DX Leatherhead
    Surrey
    BritishSales And Marketing Director24161370006
    DURBIN, Dean
    19001 Windsor Forest Road
    Mount Airy
    Maryland 21771
    Usa
    Geschäftsführer
    19001 Windsor Forest Road
    Mount Airy
    Maryland 21771
    Usa
    AmericanCfo81110710001
    FISHER, Angus William Murray
    Coledown House
    Vicarage Lane, Curdridge
    S032 2DP Southampton
    Hants
    Geschäftsführer
    Coledown House
    Vicarage Lane, Curdridge
    S032 2DP Southampton
    Hants
    United KingdomBritishChartered Accountant122903010001
    HUNTER, Michael Carney Gray
    23 Broadlands Road
    N6 4AE London
    Geschäftsführer
    23 Broadlands Road
    N6 4AE London
    EnglandBritishMaster Printer63760120001
    INGHAM, Clive William
    The Cottage Pheasants Hill
    RG9 6RT Hambleden
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Cottage Pheasants Hill
    RG9 6RT Hambleden
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector53964980001
    MARTINDALE, Peter
    1st Floor 30-31 Peter Street
    W1A 6FX London
    Geschäftsführer
    1st Floor 30-31 Peter Street
    W1A 6FX London
    BritishDirector108323790001
    PARKER, Robert Michael
    13 Lyndale Park
    Orton Wistow
    PE1 5YS Peterborough
    Geschäftsführer
    13 Lyndale Park
    Orton Wistow
    PE1 5YS Peterborough
    BritishDirector47036500001
    REILLY, Edward Thomas
    6 Stony Point Road
    Westport Connecticut
    FOREIGN Usa 06880
    Geschäftsführer
    6 Stony Point Road
    Westport Connecticut
    FOREIGN Usa 06880
    Us CitizenCompany President62118550001
    REYNOLDS, Kevin Paul
    19 York Street
    Harborne
    B17 0HG Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    19 York Street
    Harborne
    B17 0HG Birmingham
    West Midlands
    BritishVenture Capitalist101625190001
    ROLAND, Donald Edward
    4 Norwood Road
    Annapolis
    Maryland 21401
    Usa
    Geschäftsführer
    4 Norwood Road
    Annapolis
    Maryland 21401
    Usa
    AmericanCeo71621920001
    ROOSEN, Adriaan Henri Dominique Marie
    Stationsweg 26
    Oosterbeek
    6861 Eh
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Stationsweg 26
    Oosterbeek
    6861 Eh
    Netherlands
    DutchCompany Director74228750001
    SHERWIN, Theodore Daniel
    338 The Great Road
    Princeton
    FOREIGN Usa Nj 08540
    Geschäftsführer
    338 The Great Road
    Princeton
    FOREIGN Usa Nj 08540
    UsaPresident Ceo62915610001
    STEEL, Angus Kennedy
    Brewery Cottage
    Brockhampton
    GL54 5XQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Brewery Cottage
    Brockhampton
    GL54 5XQ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector62259790003
    TAYLOR, Richard Scott
    The Stables Church Lane
    Dingley
    LE16 8PG Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    The Stables Church Lane
    Dingley
    LE16 8PG Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritishChartered Accountant35333200002
    RUTLAND DIRECTORS LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005280001

    Hat DM&F LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 22. Dez. 2004
    Geliefert am 11. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other credit party to the chargee or any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of its right, title and interest in and to each of the following assets; th properties and all related rights; the debts; the equipment; the intellectual property; all present and future goodwill and all rights in relation to the uncalled capital of the company; the investments; floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • General Electric Capital Corporation (For Itself and as Agent for the Lenders) (the Agent)
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over shares
    Erstellt am 22. Dez. 2004
    Geliefert am 11. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other credit party to the chargee or any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of its right, title and interest from time to time in and to; the original shares; all dividends; all further shares; and all derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • General Electric Capital Corporation (For Itself and as Agent for the Lenders) (the Agent)
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Jan. 2000
    Geliefert am 18. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys and liabilities due or to become due from any chargor to the chargees under or in connection with a). The credit agreement b). Any other credit document to which the chargor is party from time to time and c). The debenture
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Chase Manhattan Bank (The "Collateral Agent")
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over shares and inter company promissory notes
    Erstellt am 04. Jan. 1999
    Geliefert am 22. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from the company to the bank creditors (as defined) arising out of or in connection with any credit document (as defined) all obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee and the other creditors (as defined) under or arising out of or in connection with any interest rate protection (as defined) or other hedging agreement (as defined) or under the guarantee and any and all sums advanced by the collateral agent in order to preserve the secured property and/or its security interest herein and all amounts paid by any indemnitee to which such indemnitee has the right to reimbursement under clause 5.3 of the deed
    Kurze Angaben
    All the shares and all the notes and any proceeds of any or all of the foregoing (collectively the "secured property"). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bankers Trust Company (The "Collateral Agent") for the Benefit of the Secured Creditors
    Transaktionen
    • 22. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of deposit of stocks and shares
    Erstellt am 01. März 1996
    Geliefert am 18. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from colorgraphic (leicester) limited and/or the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All stocks shares bonds debentures or other securities of any description which have already been or may after the date of the charge be handed or assigned and/or transferred to the bank or into the name of the bank's nominees or lodged or deposited with the bank ......... see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. März 1996
    Geliefert am 18. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0