ATKINS & CRIPPS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameATKINS & CRIPPS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03140130
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ATKINS & CRIPPS LIMITED?

    • (9999) /

    Wo befindet sich ATKINS & CRIPPS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    UHY HACKER YOUNG LLP
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    EW1 YW London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ATKINS & CRIPPS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    YANKEE LIMITED15. Dez. 199515. Dez. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ATKINS & CRIPPS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für ATKINS & CRIPPS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Mai 2011

    7 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Kemp House Cumnor Hill Oxford Oxfordshire OX2 9PH am 14. Dez. 2010

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 24. Nov. 2010

    LRESSP

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Jan. 2010

    Kapitalaufstellung am 11. Jan. 2010

    • Kapital: GBP 3,200,001
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009

    3 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    17 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    19 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Wahlresolution

    ELRES

    legacy

    3 Seiten363a

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Gewährung finanzieller Unterstützung für den Erwerb von Aktien

    RES07

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    1 Seiten225

    Wer sind die Geschäftsführer von ATKINS & CRIPPS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DOBSON, John William
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    Sekretär
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    English15662110002
    DOBSON, John William
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    EnglandEnglish15662110002
    FINEMAN, Simon
    1 Farndon Road
    OX2 6RS Oxford
    Geschäftsführer
    1 Farndon Road
    OX2 6RS Oxford
    EnglandBritish61133550002
    DAVIES, Gareth
    Adams Gate
    Mallows Green Road, Manuden
    CM23 1DG Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Sekretär
    Adams Gate
    Mallows Green Road, Manuden
    CM23 1DG Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British71865070001
    MARRIOTT, Duncan Peter
    Grange Farm 85 The Row
    Sutton
    CB6 2PB Ely
    Cambridgeshire
    Sekretär
    Grange Farm 85 The Row
    Sutton
    CB6 2PB Ely
    Cambridgeshire
    British50701840001
    PHILLIPS, Lawrence Stephen
    42 Cowper Road
    AL5 5NG Harpenden
    Hertfordshire
    Sekretär
    42 Cowper Road
    AL5 5NG Harpenden
    Hertfordshire
    British11800250003
    RM REGISTRARS LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900000760001
    BARRINGER, Paul Brandon
    11 Longstreet Road
    27890 Weldon
    Nc
    United States Of America
    Geschäftsführer
    11 Longstreet Road
    27890 Weldon
    Nc
    United States Of America
    American34440990001
    BARRINGER, Victor
    PO BOX 829
    Green Street Extension
    Weldon
    North Carolina 27890
    Geschäftsführer
    PO BOX 829
    Green Street Extension
    Weldon
    North Carolina 27890
    American50712820003
    BOSTON, Neil Moir, Mr.
    12 North Quay
    OX14 5RY Abingdon
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    12 North Quay
    OX14 5RY Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish113486000001
    CAMPOLL, Henry William
    105 Joelene Court
    Rocky Mount
    North Carolina 27803
    Usa
    Geschäftsführer
    105 Joelene Court
    Rocky Mount
    North Carolina 27803
    Usa
    American54149770001
    CONGER, Stephen Halsey
    Box 829
    NC 27890 Weldon
    North Carolina
    Geschäftsführer
    Box 829
    NC 27890 Weldon
    North Carolina
    American47437230001
    DOBSON, John William
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    EnglandEnglish15662110002
    GORMAN, James John Stuart
    2 Lime Meadows
    Sewards End
    CB10 2LQ Saffron Walden
    Essex
    Geschäftsführer
    2 Lime Meadows
    Sewards End
    CB10 2LQ Saffron Walden
    Essex
    British47435900001
    HAYWOOD, David James
    Blackberry Cottage
    Turnpike Hill Withersfield
    CB9 7RY Haverhill
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Blackberry Cottage
    Turnpike Hill Withersfield
    CB9 7RY Haverhill
    Suffolk
    United KingdomBritish47436450002
    HIPKIN, Ian Robert
    1 Van Gogh Place
    St Ives
    PE27 3HE Huntingdon
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    1 Van Gogh Place
    St Ives
    PE27 3HE Huntingdon
    Cambridgeshire
    British78621800001
    MARRIOTT, Duncan Peter
    Grange Farm 85 The Row
    Sutton
    CB6 2PB Ely
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Grange Farm 85 The Row
    Sutton
    CB6 2PB Ely
    Cambridgeshire
    EnglandBritish50701840001
    MCGAGIN, Timothy A
    201 Candlewood Road
    Rocky Mount
    North Carolina
    27804
    United States Of America
    Geschäftsführer
    201 Candlewood Road
    Rocky Mount
    North Carolina
    27804
    United States Of America
    Usa40432680002
    SEAY, Ronald Frederick
    21 Pumpkin Lane
    NC 27850 Littleton
    North Carolina
    America
    Geschäftsführer
    21 Pumpkin Lane
    NC 27850 Littleton
    North Carolina
    America
    American47437050001
    THEWLIS, Clive Roger
    8 Harolds Close
    Leafield
    OX29 9PU Witney
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    8 Harolds Close
    Leafield
    OX29 9PU Witney
    Oxfordshire
    EnglandBritish125543430001
    RM NOMINEES LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900009140001

    Hat ATKINS & CRIPPS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 29. Sept. 2006
    Geliefert am 07. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Jan. 2005
    Geliefert am 01. Feb. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Units 50-54, lancaster way, ely, cambridgeshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 27. Feb. 2004
    Geliefert am 04. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 07. Sept. 2000
    Geliefert am 13. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. Sept. 2000
    Geliefert am 13. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property k/a 95 london road bishops stortford t/n HD316227. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 07. Feb. 2000
    Geliefert am 10. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and the lease of even date defined therein
    Kurze Angaben
    All the company's right title benefit and interest in and to the deposit of £6,500 held in an interest bearing deposit account in accordance with the deed.
    Berechtigte Personen
    • Southend Property Management Limited
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 07. Feb. 2000
    Geliefert am 10. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £6,500 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Units 1 & 2 tamar view industrial estate saltash.
    Berechtigte Personen
    • Southend Property Management Limited
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 03. Apr. 1997
    Geliefert am 04. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £13,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the deed
    Kurze Angaben
    By way of legal charge the sum of £13,000 or such other monies held from time to time pursuant to the deed.
    Berechtigte Personen
    • Southend Property Management Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Jan. 1996
    Geliefert am 09. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this debenture
    Kurze Angaben
    L/H-property k/a sheffield park sawmills uckfield east sussex. F/h-unit 5 bilston industrial estate bilston west midlands t/n-WM421694. F/h-95 london road bishop's stortford t/n-HD316227. F/h-9 burrington way plymouth t/n-DN241029. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Coastal Lumber Company
    Transaktionen
    • 09. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Okt. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture created by the company formerly known as yankee limited
    Erstellt am 22. Jan. 1996
    Geliefert am 26. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The First National Bank of Boston
    Transaktionen
    • 26. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ATKINS & CRIPPS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    24. Nov. 2010Beginn der Liquidation
    01. Okt. 2011Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Michael Kiely
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Praktiker
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Peter Kubik
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Praktiker
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0