CSG HEALTHCARE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCSG HEALTHCARE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03140174
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CSG HEALTHCARE LIMITED?

    • (8514) /

    Wo befindet sich CSG HEALTHCARE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    Bedfordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CSG HEALTHCARE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BLUE ARROW CARE LIMITED09. Sept. 200309. Sept. 2003
    WELBECK CARE LIMITED15. Dez. 199515. Dez. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CSG HEALTHCARE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für CSG HEALTHCARE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Widerruf des Antrags auf Löschung der Gesellschaft

    2 SeitenDS02

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    15 SeitenMG01

    legacy

    15 SeitenMG01

    Kapitalaufstellung am 29. Juni 2012

    • Kapital: GBP 1.00
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Dez. 2011

    12 SeitenAA

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 1st Floor Pellipar House 9 Cloak Lane London EC4R 2RU United Kingdom geändert

    1 SeitenAD02

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    13 SeitenAA

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 201 Bishopsgate London EC2M 3AF United Kingdom geändert

    1 SeitenAD02

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    12 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    12 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Andrew Burchall am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Rebecca Jane Watson am 01. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Rebecca Jane Watson am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von CSG HEALTHCARE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    British70686070002
    BURCHALL, Andrew Jeremy
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish69904570002
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish70686070002
    ABRAHAMSON, John David
    2 New End Square
    NW3 1LN London
    Sekretär
    2 New End Square
    NW3 1LN London
    British26433460001
    BOUVIER, Graham John
    Apartment 405
    118 Southwark Bridge Road
    SE1 0BQ London
    Sekretär
    Apartment 405
    118 Southwark Bridge Road
    SE1 0BQ London
    British117533510001
    MARTIN, Christopher Paul
    15 Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    Sekretär
    15 Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    British64640450003
    MCS SECRETARIES LIMITED
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Bevollmächtigter Sekretär
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    900006380001
    ABRAHAMSON, John David
    2 New End Square
    NW3 1LN London
    Geschäftsführer
    2 New End Square
    NW3 1LN London
    British26433460001
    BOUVIER, Graham John
    Apartment 405
    118 Southwark Bridge Road
    SE1 0BQ London
    Geschäftsführer
    Apartment 405
    118 Southwark Bridge Road
    SE1 0BQ London
    British117533510001
    BRAILEY, Geoffrey Ian
    Oakfields Theobalds Road
    RH15 0SS Burgess Hill
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Oakfields Theobalds Road
    RH15 0SS Burgess Hill
    East Sussex
    British10317690002
    CORNISH, Diana Frederica
    Green Acres Lower Luton Road
    AL5 5EG Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Green Acres Lower Luton Road
    AL5 5EG Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish6048720001
    DOYLE, Desmond Mark Christopher
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    EnglandBritish266121440001
    EDEN, Roger Charles
    Peters Court Plymouth Drive
    Barnt Green
    B45 8JB Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Peters Court Plymouth Drive
    Barnt Green
    B45 8JB Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritish41649520001
    LAKE, David Anthony
    66 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    Geschäftsführer
    66 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    EnglandBritish59820940001
    MARTIN, Christopher Paul
    15 Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    Geschäftsführer
    15 Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    United KingdomBritish64640450003
    MCHUGH, Gerard Johnathon
    42 Cameford Court
    New Park Road
    SW2 4LJ London
    Geschäftsführer
    42 Cameford Court
    New Park Road
    SW2 4LJ London
    United KingdomIrish42016500001
    PALMER, Christopher Frank
    Hillcrest
    52 Longdon Wood
    BR2 6EW Keston Park
    Kent
    Geschäftsführer
    Hillcrest
    52 Longdon Wood
    BR2 6EW Keston Park
    Kent
    British44804390001
    ROWLEY, John
    Hickling Lodge
    Melton Road
    LE14 3QG Hickling Pastures
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Hickling Lodge
    Melton Road
    LE14 3QG Hickling Pastures
    Leicestershire
    EnglandBritish11900790002
    SARSON, Michael Robert
    12 Pine Grove
    Brookmans Park
    AL9 7BS Hatfield
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    12 Pine Grove
    Brookmans Park
    AL9 7BS Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritish27419330001
    MCS NOMINEES LIMITED
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    900006370001

    Hat CSG HEALTHCARE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee and fixed and floating charge
    Erstellt am 23. Aug. 2012
    Geliefert am 28. Aug. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Aug. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Guarantee and fixed and floating charge
    Erstellt am 08. Aug. 2012
    Geliefert am 14. Aug. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 06. Mai 2008
    Geliefert am 17. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from impellam group PLC, the original security obligors and any person which grants a security interest to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 27. Apr. 2007
    Geliefert am 12. Mai 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (jointly and severally with each security obligor) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 29. Apr. 2004
    Geliefert am 12. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee (whether for its own account or as agent or trustee for the finance parties) or to any of the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor charges all the mortgaged property all real property the mortgaged property being the freehold property 39 ardwick green north manchester t/n GM654955, l/h property brierley hill shaw house wychbury court two woods lane dudley & l/h property being newcastle suite 2 gunner house by way of fixed charge its insurances its intellectual property rights any beneficial interest claim or entitlement it may have in any pension fund its uncalled capital by way of floating charge all present and future assets property business undertaking and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 12. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Mai 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 31. Aug. 2000
    Geliefert am 20. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities owing by any obligor to the chargee under any of the finance documents whether a). Present or future b). Actual or contingent or c). Owed solely, jointly or severally
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Credit Llc the ("Security Trustee" and "Security Bene Ficiary") and Gmac Commercial Credit Development Limited ("Gmac UK") ("Security Beneficiary")
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2000Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 18. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 13. Mai 1999
    Geliefert am 20. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 10. Jan. 1996
    Geliefert am 19. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kellock Limited
    Transaktionen
    • 19. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0