CSG HEALTHCARE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CSG HEALTHCARE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03140174 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CSG HEALTHCARE LIMITED?
- (8514) /
Wo befindet sich CSG HEALTHCARE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 800 The Boulevard Capability Green LU1 3BA Luton Bedfordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CSG HEALTHCARE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BLUE ARROW CARE LIMITED | 09. Sept. 2003 | 09. Sept. 2003 |
| WELBECK CARE LIMITED | 15. Dez. 1995 | 15. Dez. 1995 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CSG HEALTHCARE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CSG HEALTHCARE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Widerruf des Antrags auf Löschung der Gesellschaft | 2 Seiten | DS02 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 15 Seiten | MG01 | ||||||||||
legacy | 15 Seiten | MG01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 29. Juni 2012
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Dez. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 1st Floor Pellipar House 9 Cloak Lane London EC4R 2RU United Kingdom geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 201 Bishopsgate London EC2M 3AF United Kingdom geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Andrew Burchall am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Rebecca Jane Watson am 01. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Rebecca Jane Watson am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CSG HEALTHCARE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATSON, Rebecca Jane | Sekretär | 800 The Boulevard Capability Green LU1 3BA Luton C/O Impellam Group Plc Bedfordshire United Kingdom | British | 70686070002 | ||||||
| BURCHALL, Andrew Jeremy | Geschäftsführer | 800 The Boulevard Capability Green LU1 3BA Luton C/O Impellam Group Plc Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 69904570002 | |||||
| WATSON, Rebecca Jane | Geschäftsführer | 800 The Boulevard Capability Green LU1 3BA Luton C/O Impellam Group Plc Bedfordshire United Kingdom | England | British | 70686070002 | |||||
| ABRAHAMSON, John David | Sekretär | 2 New End Square NW3 1LN London | British | 26433460001 | ||||||
| BOUVIER, Graham John | Sekretär | Apartment 405 118 Southwark Bridge Road SE1 0BQ London | British | 117533510001 | ||||||
| MARTIN, Christopher Paul | Sekretär | 15 Roxburghe Mansions 32 Kensington Court W8 5BQ London | British | 64640450003 | ||||||
| MCS SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 82 St John Street EC1M 4JN London | 900006380001 | |||||||
| ABRAHAMSON, John David | Geschäftsführer | 2 New End Square NW3 1LN London | British | 26433460001 | ||||||
| BOUVIER, Graham John | Geschäftsführer | Apartment 405 118 Southwark Bridge Road SE1 0BQ London | British | 117533510001 | ||||||
| BRAILEY, Geoffrey Ian | Geschäftsführer | Oakfields Theobalds Road RH15 0SS Burgess Hill East Sussex | British | 10317690002 | ||||||
| CORNISH, Diana Frederica | Geschäftsführer | Green Acres Lower Luton Road AL5 5EG Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | 6048720001 | |||||
| DOYLE, Desmond Mark Christopher | Geschäftsführer | Bagwell Lane RG29 1JG Odiham Green Hill Hampshire | England | British | 266121440001 | |||||
| EDEN, Roger Charles | Geschäftsführer | Peters Court Plymouth Drive Barnt Green B45 8JB Birmingham West Midlands | United Kingdom | British | 41649520001 | |||||
| LAKE, David Anthony | Geschäftsführer | 66 Elm Park Road SW3 6AU London | England | British | 59820940001 | |||||
| MARTIN, Christopher Paul | Geschäftsführer | 15 Roxburghe Mansions 32 Kensington Court W8 5BQ London | United Kingdom | British | 64640450003 | |||||
| MCHUGH, Gerard Johnathon | Geschäftsführer | 42 Cameford Court New Park Road SW2 4LJ London | United Kingdom | Irish | 42016500001 | |||||
| PALMER, Christopher Frank | Geschäftsführer | Hillcrest 52 Longdon Wood BR2 6EW Keston Park Kent | British | 44804390001 | ||||||
| ROWLEY, John | Geschäftsführer | Hickling Lodge Melton Road LE14 3QG Hickling Pastures Leicestershire | England | British | 11900790002 | |||||
| SARSON, Michael Robert | Geschäftsführer | 12 Pine Grove Brookmans Park AL9 7BS Hatfield Hertfordshire | England | British | 27419330001 | |||||
| MCS NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 82 St John Street EC1M 4JN London | 900006370001 |
Hat CSG HEALTHCARE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and fixed and floating charge | Erstellt am 23. Aug. 2012 Geliefert am 28. Aug. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and fixed and floating charge | Erstellt am 08. Aug. 2012 Geliefert am 14. Aug. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 06. Mai 2008 Geliefert am 17. Mai 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from impellam group PLC, the original security obligors and any person which grants a security interest to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 27. Apr. 2007 Geliefert am 12. Mai 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (jointly and severally with each security obligor) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Apr. 2004 Geliefert am 12. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee (whether for its own account or as agent or trustee for the finance parties) or to any of the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The chargor charges all the mortgaged property all real property the mortgaged property being the freehold property 39 ardwick green north manchester t/n GM654955, l/h property brierley hill shaw house wychbury court two woods lane dudley & l/h property being newcastle suite 2 gunner house by way of fixed charge its insurances its intellectual property rights any beneficial interest claim or entitlement it may have in any pension fund its uncalled capital by way of floating charge all present and future assets property business undertaking and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Aug. 2000 Geliefert am 20. Sept. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities owing by any obligor to the chargee under any of the finance documents whether a). Present or future b). Actual or contingent or c). Owed solely, jointly or severally | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 13. Mai 1999 Geliefert am 20. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 10. Jan. 1996 Geliefert am 19. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0