CP PROPCO 1 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCP PROPCO 1 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03141227
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CP PROPCO 1 LIMITED?

    • Pflegeheime (86102) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich CP PROPCO 1 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CP PROPCO 1 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CARE PRINCIPLES LIMITED16. Mai 199716. Mai 1997
    M&R 636 LIMITED22. Dez. 199522. Dez. 1995

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CP PROPCO 1 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für CP PROPCO 1 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    12 SeitenLIQ13

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 1 Churchill Place London E14 5HP verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 1 Churchill Place London E14 5HP geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Churchill Place London E14 5HP zum 1 More London Place London SE1 2AF am 10. Juli 2019

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 12. Juni 2019

    LRESSP

    Erfüllung der Belastung 30 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 24 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 23 vollständig

    1 SeitenMR04

    legacy

    2 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 17. Mai 2019

    • Kapital: GBP 2.00
    3 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Reduction of share premium account and capital redemption reserve 15/05/2019
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    23 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    22 SeitenAA

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 22

    1 SeitenMR05

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 28

    1 SeitenMR05

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 20

    2 SeitenMR05

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 18

    2 SeitenMR05

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 19

    2 SeitenMR05

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 29

    2 SeitenMR05

    Wer sind die Geschäftsführer von CP PROPCO 1 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BARCOSEC LIMITED
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Sekretär
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    49004930002
    GLOGOFF, Marc J
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Geschäftsführer
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United StatesAmerican168638450001
    LINDOW, Simon Edwin Guy
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Geschäftsführer
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish204635960001
    LOGUE, David Andrew
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Geschäftsführer
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish188848400001
    SILVERMAN, Robert
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Geschäftsführer
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United StatesAmerican204665260001
    MARSHALL, Brian
    112 Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    Sekretär
    112 Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    British76205930002
    ROTH, David John
    10 Lime Close
    CB5 0JR Burwell
    Cambridgeshire
    Sekretär
    10 Lime Close
    CB5 0JR Burwell
    Cambridgeshire
    German154094310001
    RYAN, Paul Michael Shaune
    10 Silver Street
    CB7 4JF Ely
    Cambridgeshire
    Sekretär
    10 Silver Street
    CB7 4JF Ely
    Cambridgeshire
    British36038480001
    SMITH, Nigel Grant
    2 Meadow Drive
    Horringer
    IP29 5SB Bury St Edmunds
    Suffolk
    Sekretär
    2 Meadow Drive
    Horringer
    IP29 5SB Bury St Edmunds
    Suffolk
    British54325850001
    STANFIELD, Glynne
    Eversheds Llp
    Kett House Station Road
    CB1 2JY Cambridge
    Sekretär
    Eversheds Llp
    Kett House Station Road
    CB1 2JY Cambridge
    British113309310001
    BEARD, James Ian
    The Walnuts High Street
    Wendy
    SG8 0HG Royston
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Walnuts High Street
    Wendy
    SG8 0HG Royston
    Hertfordshire
    British36202130001
    BEZIAN, Haig George
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Geschäftsführer
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandFrench188848390002
    CALVELEY, Peter, Dr
    Alderley Road
    SK9 1NX Wilmslow
    Emerson Court
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Alderley Road
    SK9 1NX Wilmslow
    Emerson Court
    Cheshire
    United KingdomBritish131468590001
    CONWAY, Jonathan Paul
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Geschäftsführer
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish160362360002
    ETHERINGTON, Andreas
    8 Garrod Approach
    IP12 1TD Melton
    Suffolk
    Geschäftsführer
    8 Garrod Approach
    IP12 1TD Melton
    Suffolk
    United KingdomBritish168050580001
    LYNAM, Robert Iain
    Beech House
    9 Pendennis Road
    TN13 3JS Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Beech House
    9 Pendennis Road
    TN13 3JS Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish1374130001
    MAHADEVAN, Joshua Rabindranath
    19 Manston Drive
    CM23 5EJ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    19 Manston Drive
    CM23 5EJ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British52916580001
    MARSHALL, Brian
    112 Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    Geschäftsführer
    112 Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    United KingdomBritish76205930002
    MCKENNA, Christopher
    3 Midhurst Close
    IP32 7NH Bury St. Edmunds
    Suffolk
    Geschäftsführer
    3 Midhurst Close
    IP32 7NH Bury St. Edmunds
    Suffolk
    British57816210002
    MCLEAN, Anthony
    Woodlands
    Cage End, Hatfield Broad Oak
    CM22 7HP Bishops Stortford
    Geschäftsführer
    Woodlands
    Cage End, Hatfield Broad Oak
    CM22 7HP Bishops Stortford
    United KingdomBritish67231420002
    MORRIS, George Eryl
    Broad Oak
    Devonshire Avenue
    HP6 5JE Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Broad Oak
    Devonshire Avenue
    HP6 5JE Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish10280180001
    ROTH, David John
    10 Lime Close
    CB5 0JR Burwell
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    10 Lime Close
    CB5 0JR Burwell
    Cambridgeshire
    EnglandGerman154094310001
    SKULL, Amanda Sarah Osborne
    Steggles Barn
    Whiting Street
    IP33 1NR Bury St Edmunds
    Geschäftsführer
    Steggles Barn
    Whiting Street
    IP33 1NR Bury St Edmunds
    EnglandBritish86782960002
    SMITH, Nigel Grant
    Rede Hall
    Chedburgh
    IP29 4UG Bury St Edmunds
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Rede Hall
    Chedburgh
    IP29 4UG Bury St Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritish54325850002
    STOCK, Linda
    Craven Court
    Willie Snaith Road
    CB8 7FA Newmarket
    Tulip House
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Craven Court
    Willie Snaith Road
    CB8 7FA Newmarket
    Tulip House
    Suffolk
    United KingdomBritish104973300001
    SULLIVAN, Sean Patrick
    Rustat Avenue
    CB1 3PF Cambridge
    29
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Rustat Avenue
    CB1 3PF Cambridge
    29
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish137653030001
    WELLS, David Habershon
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Geschäftsführer
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish140997350001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CP PROPCO 1 LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    06. Apr. 2016
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland & Wales
    RechtsgrundlageEngland And Wales
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer5387989
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat CP PROPCO 1 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 11. Juli 2011
    Geliefert am 27. Juli 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Juli 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 18. Juni 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A legal charge
    Erstellt am 11. Juli 2011
    Geliefert am 26. Juli 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land at beech house and land to the west of beech house fordham road newmarket suffolk t/no:SK172341 and SK181860.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juli 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 22. Juni 2017Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Juli 2011
    Geliefert am 26. Juli 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Rowan house buxton norfolk t/no:NK95806 NK255524 and NK270165.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juli 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 22. Juni 2017Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Juli 2011
    Geliefert am 26. Juli 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Linden house market weighton york t/no:HS254465.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juli 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 22. Juni 2017Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Juli 2011
    Geliefert am 26. Juli 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Cedar house dover road barham canterbury t/no:K599759 and K274979.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juli 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 22. Juni 2017Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Juli 2011
    Geliefert am 26. Juli 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Ashley house ashley market drayton staffordshire t/no:SF400269.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juli 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 22. Juni 2017Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    Debenture with floating charge
    Erstellt am 14. Dez. 2009
    Geliefert am 23. Dez. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 18. Juni 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 09. Okt. 2007
    Geliefert am 23. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juni 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Okt. 2007
    Geliefert am 23. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land at brigstock corby t/no NN216162. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juli 2017Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Okt. 2007
    Geliefert am 23. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land at rowan house buxton norfolk t/nos NK95806 NK255524 and NK270165. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2017Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Okt. 2007
    Geliefert am 23. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land at ashley house ashley market drayton staffordshire t/no SF400269. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2017Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Okt. 2007
    Geliefert am 23. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land at beech house and land to the west of beech house fordham road newmarket suffolk t/nos SK172341 and SK181860. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2017Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Okt. 2007
    Geliefert am 23. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Cedar house dover road barham canterbury t/nos K593759 and K274979. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2017Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Okt. 2007
    Geliefert am 23. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Linden house market weighton york t/no HS254465. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2017Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Okt. 2007
    Geliefert am 23. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land being former sedgefield community hospital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2017Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Aug. 2007
    Geliefert am 04. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land being former sedgefield community hospital t/no DU222779.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for Each of the Secured Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 04. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Aug. 2007
    Geliefert am 04. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for Each of the Secured Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 04. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A deed of charge and assignment
    Erstellt am 30. März 2005
    Geliefert am 08. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge all book debts and other debts all balances standing to the credit of any current deposit or other account of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Sept. 2003
    Geliefert am 25. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from the company to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including (I) f/hold land and buildings on the north west side of fordham road (known as beech house),exning,newmarket,suffolk CB8 7LF; SK172341 and SK181860; (ii) cedar house,barham,canterbury kent CT4 6EX (f/hold); K274979 and K593759; (iii) f/hold known as linden house,market weighton york YO43 4LA; HS254465; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Dez. 2000
    Geliefert am 15. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The former red house school buxton norwich norfolk.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Okt. 1999
    Geliefert am 22. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property - st william's community home,market weighton east yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Okt. 1999
    Geliefert am 13. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property k/a former spinning wheel hotel dover rroad barham canterbury kent.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Aug. 1998
    Geliefert am 07. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Former ashley special school church road ashley staffordshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 28. Aug. 1998
    Geliefert am 03. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a ashley special school church road ashley staffordshire with all buildings and fixtures fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 03. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 11. Mai 1998
    Geliefert am 28. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property containing an area of 7.84 acres or thereabouts situate off church road ashley staffs together with all buildings and fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 28. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CP PROPCO 1 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    12. Juni 2019Beginn der Liquidation
    13. Aug. 2020Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0