BUCKINGHAM HUYTON LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BUCKINGHAM HUYTON LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03142566 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BUCKINGHAM HUYTON LIMITED?
- Glücksspiel- und Wettbetriebe (92000) / Kunst, Unterhaltung und Erholung
Wo befindet sich BUCKINGHAM HUYTON LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Haberfield Old Moor Road Wennington LA2 8PD Lancaster |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BUCKINGHAM HUYTON LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CAMBOS HUYTON LIMITED | 12. Apr. 1996 | 12. Apr. 1996 |
COUNTYRANGE LIMITED | 02. Jan. 1996 | 02. Jan. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BUCKINGHAM HUYTON LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BUCKINGHAM HUYTON LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2019 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Jan. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2018 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2017 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2016 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 17. Nov. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2015 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2014 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Verschiedenes Sec 519 | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2013 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Apr. 2012 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BUCKINGHAM HUYTON LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIMMER, David Norman | Geschäftsführer | Newport Road ST21 6BE Eccleshall Ridgefield 23 Staffordshire England | United Kingdom | British | Director | 71617270002 | ||||
WALKER, Jonathan James | Geschäftsführer | Old Moor Road Wennington LA2 8PD Lancaster Haberfield England | England | British | Accountant | 39444010001 | ||||
ALLY, Bibi Rahima | Sekretär | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | British | 38963210003 | ||||||
O'CALLAGHAN, Joseph | Sekretär | 9 Mallard Walk DE3 0TF Derby Derbyshire | British | 110216340001 | ||||||
PEARSON, Andrew Guy | Sekretär | Ladyhill View Worsley M28 7LH Manchester 42 | British | Director | 134403640001 | |||||
RICHMOND, Chantal Zenobia Renee | Sekretär | 3 Brookside Cuddington CW8 2QA Northwich Cheshire | British | Administrative Manager | 17429610002 | |||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
ANDERSON, John Frederick | Geschäftsführer | 69 Culcheth Hall Drive Culcheth WA3 4PX Warrington | United Kingdom | British | Director | 4569620002 | ||||
CUNNINGHAM, William Andrew | Geschäftsführer | 4 Goodwood Rise CW10 9FJ Middlewich Cheshire | England | British | Chief Executive | 113656620001 | ||||
DOBSON, Stephen | Geschäftsführer | 24 Parklands Drive Weston CW2 5FH Crewe | United Kingdom | British | Director | 127852340001 | ||||
KOSSOWSKI, Mark Sylvester | Geschäftsführer | St Jude Stoney Lane SK9 6LG Wilmslow Cheshire | British | Manager | 110423140001 | |||||
O'CALLAGHAN, Joseph | Geschäftsführer | 9 Mallard Walk DE3 0TF Derby Derbyshire | England | British | Director | 110216340001 | ||||
PANAYI, Panico | Geschäftsführer | Kato Drys Victoria Road Heaton BL1 5AW Bolton Lancashire | British | Director | 9075400001 | |||||
PEARSON, Andrew Guy | Geschäftsführer | Ladyhill View Worsley M28 7LH Manchester 42 | England | British | Director | 134403640001 | ||||
RICHMOND, Chantal Zenobia Renee | Geschäftsführer | 3 Brookside Cuddington CW8 2QA Northwich Cheshire | British | Administrative Manager | 17429610002 | |||||
TAYLOR, Graham Jack | Geschäftsführer | 36 Ullswater Drive Killingworth NE12 8GX Newcastle | British | Manager | 110423300001 | |||||
WALSH, Neil | Geschäftsführer | The Paddock Beardwood BB2 7QY Blackburn 2 Lancashire | United Kingdom | British | Director | 134469650001 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BUCKINGHAM HUYTON LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buckingham Bingo Limited | 06. Apr. 2016 | Old Moor Road Wennington LA2 8PD Lancaster Haberfield Lancashire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat BUCKINGHAM HUYTON LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 19. Dez. 2005 Geliefert am 29. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 249 stanley road bootle t/n MS235764 bingo club poplar bank huyton knowsley merseyside t/n MS365314 601 chester road old trafford t/n GM817722 for furter details of the properties charged please refer to form 395 the real property any goodwill the shares all dividends interest and other monies the proceeds of insurance floating charge the companys undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 19. Dez. 2005 Geliefert am 29. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land to the east of archway road huyton t/n MS387811. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 19. Dez. 2005 Geliefert am 29. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Bingo club popular bank huyton knowsley merseyside t/n MS365314. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 19. Mai 1997 Geliefert am 28. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or allied domecq PLC and/or any subsidiary or associated company of carlsberg -tetley brewing limited and/or allied domecq PLC | |
Kurze Angaben All that f/h land adjoining buckingham bingo hall huyton merseyside. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 15. Apr. 1997 Geliefert am 28. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land on the south west side of poplar bank huyton and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 14. März 1997 Geliefert am 26. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge | |
Kurze Angaben F/H property being buckingham bingo hall poplar bank huyton liverpool merseyside t/no MS365314 the equipment fittings & chattels assigns of goodwill & the justices licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 20. Aug. 1996 Geliefert am 29. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 20. Aug. 1996 Geliefert am 29. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land and buildings at poplar bank huyton merseyside t/no: MS365314 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0