MPG ASSOCIATES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMPG ASSOCIATES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03145255
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MPG ASSOCIATES LIMITED?

    • (7487) /

    Wo befindet sich MPG ASSOCIATES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Old Exchange
    234 Southchurch Road
    SS1 2EG Southend-On-Sea
    Essex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MPG ASSOCIATES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MOTORWAY MEDIA LIMITED11. Jan. 199611. Jan. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MPG ASSOCIATES LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am30. Apr. 2010
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Jan. 2011
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für MPG ASSOCIATES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    20 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Mai 2016

    18 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Mai 2015

    22 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Mai 2014

    19 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Mai 2013

    19 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Mai 2012

    18 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Mai 2011

    10 Seiten4.68

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    11 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 17. Mai 2010

    LRESEX

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 1 London Wall London EC2Y 5AB* am 24. Mai 2010

    2 SeitenAD01

    legacy

    11 SeitenMG01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2009

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Feb. 2010

    Kapitalaufstellung am 18. Feb. 2010

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Maclay Murray & Spens Llp am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH04

    Änderung der Details des Direktors für Lee Robert Barwick am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Michael Gallucci am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2008

    6 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten395

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2007

    6 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von MPG ASSOCIATES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One
    United Kingdom
    Sekretär
    London Wall
    EC2Y 5AB London
    One
    United Kingdom
    RechtsformLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Art des AusweisesNicht-EWR
    RechtsgrundlageLIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS ACT 2000
    RegistrierungsnummerSO300744
    116685100001
    BARWICK, Lee Robert
    90 Welbeck Avenue
    Bedgrove
    HP21 9BN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    90 Welbeck Avenue
    Bedgrove
    HP21 9BN Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish61030870001
    GALLUCCI, Michael Paul
    2 Juniper Grove
    WD17 4RZ Watford
    Herts
    Geschäftsführer
    2 Juniper Grove
    WD17 4RZ Watford
    Herts
    United KingdomBritish46563550003
    GALLUCCI, Michael Paul
    2 Juniper Grove
    WD17 4RZ Watford
    Herts
    Sekretär
    2 Juniper Grove
    WD17 4RZ Watford
    Herts
    British46563550003
    SCF SECRETARIES LIMITED LIABILITY COMPANY
    American National Bank Building
    1912 Capital Avenue
    82001 Cheyenne
    Wyoming
    Usa
    Bevollmächtigter Sekretär
    American National Bank Building
    1912 Capital Avenue
    82001 Cheyenne
    Wyoming
    Usa
    900010880001
    ANDREA, Costas
    109 Puller Road
    EN5 4HQ Barnet
    Geschäftsführer
    109 Puller Road
    EN5 4HQ Barnet
    British88274810001
    WHITEFIELD, Kevin David
    34 Bedford Street
    WD24 5DT Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    34 Bedford Street
    WD24 5DT Watford
    Hertfordshire
    British80236410001
    S C F (UK) LIMITED
    90-100 Sydney Street
    Chelsea
    SW3 6NJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    90-100 Sydney Street
    Chelsea
    SW3 6NJ London
    900010870001

    Hat MPG ASSOCIATES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 12. Apr. 2010
    Geliefert am 13. Apr. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 02. Apr. 2009
    Geliefert am 03. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 30. Okt. 2008
    Geliefert am 12. Nov. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any one or more of the other parties to the agreement to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Omnibus letter of set-off
    Erstellt am 28. Dez. 2007
    Geliefert am 04. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 27. Juli 2005
    Geliefert am 10. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The amount from time to time standing to the credit of the interest earnings deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Inchstar Limited
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    All assets debenture deed
    Erstellt am 02. Juni 2003
    Geliefert am 04. Juni 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 24. Okt. 2001
    Geliefert am 07. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £6,777.40 together with other sums due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The deposit account and all money from time to time withdrawn from it in accordance with the deed.
    Berechtigte Personen
    • Inchstar Limited
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 15. Jan. 2001
    Geliefert am 18. Jan. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the agreement for the purchase of debts or otherwise
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge all debts and their related rights which fail to vest absolutely and effectively in the security holder.by way of floating charge all the undertaking all the property rights and assets of the company including stock in trade and its uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 18. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 21. Feb. 2000
    Geliefert am 24. Feb. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a rent deposit deed and an underlease of even date
    Kurze Angaben
    The amount standing to the credit of a designated deposit account under the terms of a rent deposit deed dated 21 february 2000.
    Berechtigte Personen
    • Lr Investments Limited
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 27. Aug. 1999
    Geliefert am 04. Sept. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date herewith
    Kurze Angaben
    £2,000.
    Berechtigte Personen
    • Frogmore Developments Limited
    Transaktionen
    • 04. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)

    Hat MPG ASSOCIATES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    17. Mai 2010Beginn der Liquidation
    30. Apr. 2017Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Lloyd Christopher Biscoe
    Begbies Traynor
    The Old Exchange
    SS1 2EG 234 Southchurch Road
    Southend-On-Sea Essex
    Praktiker
    Begbies Traynor
    The Old Exchange
    SS1 2EG 234 Southchurch Road
    Southend-On-Sea Essex
    Jamie Taylor
    Begbies Traynor
    The Old Exchange
    SS1 2EG 234 Southchurch Road
    Southend On Sea Essex
    Praktiker
    Begbies Traynor
    The Old Exchange
    SS1 2EG 234 Southchurch Road
    Southend On Sea Essex

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0