NORTH NELSON LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNORTH NELSON LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03145734
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NORTH NELSON LIMITED?

    • (5190) /

    Wo befindet sich NORTH NELSON LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O ROBSON LAIDLER LLP
    Fernwood House Fernwood Road Jesmond
    NE2 1TJ Newcastle Upon Tyne
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NORTH NELSON LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FONE LOGISTICS LIMITED03. Juni 199603. Juni 1996
    HAVANAH DISTRIBUTION LIMITED12. Jan. 199612. Jan. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NORTH NELSON LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für NORTH NELSON LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 31. Aug. 2010

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3 Atley Way North Nelson Industr Cramlington Northumberland NE23 1WA am 26. Apr. 2010

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 31. März 2010

    LRESEX

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008

    23 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    legacy

    5 SeitenMG02

    legacy

    5 SeitenMG02

    legacy

    5 SeitenMG02

    legacy

    5 SeitenMG02

    legacy

    5 SeitenMG02

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed fone logistics LIMITED\certificate issued on 10/11/09
    2 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name10. Nov. 2009

    Hinweis auf Namensänderung

    CONNOT

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 30. Okt. 2009

    RES15

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    legacy

    3 Seiten363a

    Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2007

    23 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2006

    22 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von NORTH NELSON LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FITZPATRICK, Michael Thomas
    35 Grosvenor Place
    NE29 0NH North Shields
    Tyne & Wear
    Sekretär
    35 Grosvenor Place
    NE29 0NH North Shields
    Tyne & Wear
    Irish99961200001
    FITZPATRICK, Michael Thomas
    35 Grosvenor Place
    NE29 0NH North Shields
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    35 Grosvenor Place
    NE29 0NH North Shields
    Tyne & Wear
    United KingdomIrish99961200001
    GILLESPIE, Ian William
    Heathery Edge
    Newton
    NE43 7XB Stocksfield
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Heathery Edge
    Newton
    NE43 7XB Stocksfield
    Northumberland
    United KingdomBritish39788280002
    DAVIS, Christine
    12 Brockwell Drive
    NE39 2PX Rowlands Gill
    Tyne & Wear
    Sekretär
    12 Brockwell Drive
    NE39 2PX Rowlands Gill
    Tyne & Wear
    British46005770002
    GILLESPIE, Ian William
    Havanah House
    East Farm Court
    NE23 9LF Cramlington
    Northumberland
    Sekretär
    Havanah House
    East Farm Court
    NE23 9LF Cramlington
    Northumberland
    British39788280001
    GILLESPIE, Ian William
    Havanah House
    East Farm Court
    NE23 9LF Cramlington
    Northumberland
    Sekretär
    Havanah House
    East Farm Court
    NE23 9LF Cramlington
    Northumberland
    British39788280001
    GUPPY, Richard David
    The Old Chapel
    West Woodburn
    NE48 2RA Hexham
    Northumberland
    Sekretär
    The Old Chapel
    West Woodburn
    NE48 2RA Hexham
    Northumberland
    British83393010001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BOWER, Michael John
    Ingle Manor
    Moor Park Beckwithshaw
    HG3 1QN Harrogate
    Geschäftsführer
    Ingle Manor
    Moor Park Beckwithshaw
    HG3 1QN Harrogate
    EnglandBritish141547520001
    FAWCETT, Gary
    Barleycote Hall
    Ilkley Road, Riddlesden
    BD20 5PN Keighley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Barleycote Hall
    Ilkley Road, Riddlesden
    BD20 5PN Keighley
    West Yorkshire
    British77042190001
    FULLER, Robert
    Fenrother Grange Fenrother
    Longhorsley
    NE61 3DP Morpeth
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Fenrother Grange Fenrother
    Longhorsley
    NE61 3DP Morpeth
    Northumberland
    British36842350002
    HUTCHINGS, Keith
    5 Shillingridge Park
    Frieth Road
    SL7 2QX Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    5 Shillingridge Park
    Frieth Road
    SL7 2QX Marlow
    Buckinghamshire
    British97358820001
    JOHNSON, Guy
    Ladham House
    Ladham Road
    TN17 1DB Goudhurst
    Kent
    Geschäftsführer
    Ladham House
    Ladham Road
    TN17 1DB Goudhurst
    Kent
    British98774840001
    LEA, Nicholas
    3 Peel Court
    Front Street
    NE13 6EA Seaton Burn
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    3 Peel Court
    Front Street
    NE13 6EA Seaton Burn
    Tyne & Wear
    British99431060001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Hat NORTH NELSON LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 17. Feb. 2006
    Geliefert am 25. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alan George Robson (Debenture Holder)
    Transaktionen
    • 25. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 17. Feb. 2006
    Geliefert am 25. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Peter John Stoker (Debenture Holder)
    Transaktionen
    • 25. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 17. Feb. 2006
    Geliefert am 25. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ian William Gillespie (Debenture Holder)
    Transaktionen
    • 25. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 17. Feb. 2006
    Geliefert am 25. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paul Graham Bell, Peter John Stoker, Richard Murrough Wilson and Rachel Elizabeth Mayall(Debenture Holder)
    Transaktionen
    • 25. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 17. Feb. 2006
    Geliefert am 18. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 11. Nov. 2003
    Geliefert am 15. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 23. Juni 2003
    Geliefert am 26. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge supplemental to a debenture dated 12TH october 1999 issued by the company
    Erstellt am 08. Jan. 2003
    Geliefert am 15. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in or arising out of a factoring invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 28 august 2002 between the company and the bank of scotland and all book and other debts the subject thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Aug. 2002
    Geliefert am 04. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge (supplemental to a debenture dated 12 october 1999)
    Erstellt am 05. Nov. 1999
    Geliefert am 11. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture
    Kurze Angaben
    All right title and interest in or arising out of a factoring invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 25 june 1996 between the company and singer & friedlander factors limited and all book and other debts the subject thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Okt. 1999
    Geliefert am 29. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 11. Nov. 1996
    Geliefert am 12. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Juni 1996
    Geliefert am 05. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and asets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Singer & Friedlander Factors Limited
    Transaktionen
    • 05. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat NORTH NELSON LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    14. Dez. 2010Aufgelöst am
    31. März 2010Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Martin Daley
    Fernwood House Fernwood Road
    Jesmond
    NE2 1TJ Newcastle Upon Tyne
    Praktiker
    Fernwood House Fernwood Road
    Jesmond
    NE2 1TJ Newcastle Upon Tyne
    William Paxton
    Fernwood House Fernwood Road
    NE2 1TJ Jesmond
    Newcastle Upon Tyne
    Praktiker
    Fernwood House Fernwood Road
    NE2 1TJ Jesmond
    Newcastle Upon Tyne

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0