BJ TRUSTEE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BJ TRUSTEE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03148118 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BJ TRUSTEE LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich BJ TRUSTEE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Frp Advisory Trading Limited Kings Orchard 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BJ TRUSTEE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BJ IT SERVICES LIMITED | 26. März 2004 | 26. März 2004 |
| PROTEK I.T. SERVICES LIMITED | 27. März 1996 | 27. März 1996 |
| BROOMCO (1032) LIMITED | 18. Jan. 1996 | 18. Jan. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BJ TRUSTEE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BJ TRUSTEE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Cody Technology Park Ively Road Farnborough Hampshire GU14 0LX zum C/O Frp Advisory Trading Limited Kings Orchard 1 Queen Street Bristol BS2 0HQ am 23. Nov. 2023 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für James Stephen Field am 17. Apr. 2023 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Dez. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Richard Willis als Geschäftsführer am 21. Okt. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Alexander Haworth als Geschäftsführer am 13. Sept. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von James Stephen Field als Sekretär am 25. Aug. 2022 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von James Stephen Field als Direktor am 25. Aug. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Heather Anne Cashin als Direktor am 25. Aug. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jon Messent als Sekretär am 11. Aug. 2022 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2022 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Dez. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2021 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Dez. 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2020 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for Boldon James Holdings Limited as a person with significant control on 22. Juni 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin Leslie Sugden als Geschäftsführer am 22. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BJ TRUSTEE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD, James Stephen | Sekretär | Kings Orchard 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol C/O Frp Advisory Trading Limited | 299524340001 | |||||||
| CASHIN, Heather Anne | Geschäftsführer | Kings Orchard 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol C/O Frp Advisory Trading Limited | England | British | 298988210001 | |||||
| FIELD, James Stephen | Geschäftsführer | Kings Orchard 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol C/O Frp Advisory Trading Limited | England | British | 298479420002 | |||||
| BOARDMAN, Lynton David | Sekretär | Cherwell Forest Drive KT20 6LU Kingswood Surrey | British | 72633900005 | ||||||
| FRENCH, Rodger Ernest Arthur | Sekretär | 1 Northumberland Avenue HP21 7HG Aylesbury Buckinghamshire | British | 23883290001 | ||||||
| HACKETT, Katherine Ann | Sekretär | The Hawthorns Harbour Lane, Wheelton PR6 8JS Chorley Lancashire | British | 105793600003 | ||||||
| MESSENT, Jon | Sekretär | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire England | British | 157180340001 | ||||||
| PERKS, Timothy Howard | Sekretär | Bowdown Farmhouse Burys Bank Road Greenham RG19 8DA Newbury Berkshire | British | 100207880001 | ||||||
| SUGDEN, Martin Leslie | Sekretär | Hill House Heckfield RG27 0JY Hook Hampshire | British | 63057200002 | ||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 | |||||||
| ADCOCK, Miles John, Dr | Geschäftsführer | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | 177091950001 | |||||
| BEAUMONT, Paul Anthony | Geschäftsführer | Church Croft Church Lane HX5 9QB Elland West Yorkshire | England | British | 89531160001 | |||||
| BENNETT, Simon David, Dr | Geschäftsführer | Manor Farm House Main Street, Westbury NN13 5JR Brackley Northamptonshire | United Kingdom | British | 74322240001 | |||||
| BUTCHER, Geoffrey Charles | Geschäftsführer | Fosse Way Harbury CV33 9JP Nr Leamington Spa Leamington Hall Farm Warwickshire | England | British | 134288870001 | |||||
| CORDING, Stephen | Geschäftsführer | 114 Norsey Road CM11 1BH Billericay Essex | England | British | 92462850001 | |||||
| EVANS, Spencer Gareth | Geschäftsführer | Buckingham Gate SW1E 6PD London 85 | England | British | 148976480001 | |||||
| GARROD, Kim Maria Michelle | Geschäftsführer | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire England | United Kingdom | British | 130666660002 | |||||
| GARROD, Michael James Baring | Geschäftsführer | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | 224052010001 | |||||
| HAWORTH, John Alexander | Geschäftsführer | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | 246944280001 | |||||
| HUMPHRIES, Nicholas James | Geschäftsführer | 8 Maple Fold New Farnley LS12 5RX Leeds West Yorkshire | British | 45629590001 | ||||||
| LING, Christopher Adam | Geschäftsführer | 85 Buckingham Gate London SW1E 6PD | England | British | 65865520001 | |||||
| MACFARLANE, Andrew John | Geschäftsführer | Gatehouse Ranters Lane TN17 1HL Kilndown Kent | England | British | 13050510001 | |||||
| MCNAUGHT-DAVIS, James | Geschäftsführer | 28 King Street SW1 London | Irish | 65403370002 | ||||||
| PALETHORPE, Mark John | Geschäftsführer | 2 Fitzwilliams Court Greatford PE9 4QQ Stamford Lincolnshire | British | 125949860001 | ||||||
| PALSER, Adam Howard, Dr | Geschäftsführer | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire England | United Kingdom | British | 248968590001 | |||||
| PICON, Jaime | Geschäftsführer | Apartado 60649 Caracas 10 FOREIGN Venezuela | Venezuelan | 46984050001 | ||||||
| RAZDAN, Sanjay | Geschäftsführer | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | Canadian | 165471790001 | |||||
| SUGDEN, Martin Leslie | Geschäftsführer | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | 63057200004 | |||||
| WATTERSON, Ian George Walter | Geschäftsführer | 314 Barkham Road RG41 4DA Wokingham Berkshire | British | 81496480001 | ||||||
| WILLIS, James Richard | Geschäftsführer | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | 243854880001 | |||||
| WOOD, Martin James | Geschäftsführer | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | 45073950001 | |||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003800001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BJ TRUSTEE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyldan 11 Limited | 06. Apr. 2016 | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat BJ TRUSTEE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 02. Juni 2005 Geliefert am 16. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the chargee or to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 02. Juni 2005 Geliefert am 16. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 02. Juni 2005 Geliefert am 08. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Juli 2003 Geliefert am 11. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 31. März 1998 Geliefert am 15. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the guarantee and debenture and all sums which have become due and shall not have been paid under a loan agreement dated 31 march 1998 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. März 1998 Geliefert am 07. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BJ TRUSTEE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0