HUDSON CAPITAL (SPH) LTD.

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHUDSON CAPITAL (SPH) LTD.
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03148655
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HUDSON CAPITAL (SPH) LTD.?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich HUDSON CAPITAL (SPH) LTD.?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Fairfax House
    15 Fulwood Place
    WC1V 6AY London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HUDSON CAPITAL (SPH) LTD.?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ROM CAPITAL (SPH) LIMITED04. Jan. 200804. Jan. 2008
    STOCKSTAR PROPERTY HOLDINGS LIMITED27. Aug. 199827. Aug. 1998
    STOCKSTAR LIMITED19. Jan. 199619. Jan. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HUDSON CAPITAL (SPH) LTD.?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für HUDSON CAPITAL (SPH) LTD.?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Martin Hamilton Croft-Sharland am 15. März 2013

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Andrew John Jenkins am 28. Jan. 2013

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Jan. 2013

    Kapitalaufstellung am 23. Jan. 2013

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    14 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Martin Hamilton Croft-Sharland am 02. Aug. 2012

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Andrew John Jenkins am 02. Aug. 2012

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Thomas Joseph Pearman am 02. Aug. 2012

    2 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Thomas Joseph Pearman am 02. Aug. 2012

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Hugh Macpherson Cameron Fraser am 02. Aug. 2012

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Charles Anthony Alcock am 02. Aug. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    15 SeitenAA

    legacy

    7 SeitenMG01

    Beschlüsse

    Resolutions
    34 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2010 bis 31. März 2011

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2009

    13 SeitenAA

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 22. Dez. 2010

    2 Seiten3.6

    legacy

    2 SeitenLQ02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 21. Dez. 2010

    2 Seiten3.6

    legacy

    2 SeitenLQ02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 22. Dez. 2010

    2 Seiten3.6

    Wer sind die Geschäftsführer von HUDSON CAPITAL (SPH) LTD.?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PEARMAN, Thomas Joseph
    Marble Arch Tower
    55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th Floor
    United Kingdom
    Sekretär
    Marble Arch Tower
    55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th Floor
    United Kingdom
    156863270001
    ALCOCK, Charles Anthony
    Floor Marble Arch Tower
    55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Floor Marble Arch Tower
    55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector141993640001
    CROFT-SHARLAND, Richard Martin Hamilton
    Floor
    Marble Arch Tower 55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Floor
    Marble Arch Tower 55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th
    United Kingdom
    United KingdomBritishSurveyor141629920025
    FRASER, Hugh Macpherson Cameron
    Marble Arch Tower
    55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Marble Arch Tower
    55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector157004960001
    JENKINS, Andrew
    55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th Floor Marble Arch Tower
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th Floor Marble Arch Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector142929030001
    PEARMAN, Thomas Joseph
    Floor
    Marble Arch Tower 55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Floor
    Marble Arch Tower 55 Bryanston Street
    W1H 7AA London
    7th
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector104558060003
    BURNEY, Daren Mark
    Forest Lane
    IG7 5AE Chigwell
    46
    Essex
    Sekretär
    Forest Lane
    IG7 5AE Chigwell
    46
    Essex
    BritishDirector102580230005
    MORRIS, Martin Alan
    17 Copsewood Way
    HA6 2JP Northwood
    Middlesex
    Sekretär
    17 Copsewood Way
    HA6 2JP Northwood
    Middlesex
    BritishCompany Director13448160001
    SILVERMAN, Alan
    32 Copsewood Way
    HA6 2UA Northwood
    Middlesex
    Sekretär
    32 Copsewood Way
    HA6 2UA Northwood
    Middlesex
    CanadianEstate Agent46409830001
    STELLON, Marco Pompeo
    Burney Court
    113 Manor Road
    IG7 5PS Chigwell
    Essex
    Sekretär
    Burney Court
    113 Manor Road
    IG7 5PS Chigwell
    Essex
    150738050001
    STELLON, Marco Pompeo
    Burney Court
    113 Manor Road
    IG7 5PS Chigwell
    Essex
    Sekretär
    Burney Court
    113 Manor Road
    IG7 5PS Chigwell
    Essex
    150737080001
    THOMPSON, Peter Mckelvey
    127 Bells Hill
    EN5 2SY Barnet
    Hertfordshire
    Sekretär
    127 Bells Hill
    EN5 2SY Barnet
    Hertfordshire
    BritishAccountant97178760001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BURNEY, Daren Mark
    Forest Lane
    IG7 5AE Chigwell
    46
    Essex
    Geschäftsführer
    Forest Lane
    IG7 5AE Chigwell
    46
    Essex
    United KingdomBritishDirector102580230005
    JACKMAN, Robert Maurice Henry
    38 Millfield Lane
    N6 6JB London
    Geschäftsführer
    38 Millfield Lane
    N6 6JB London
    United KingdomBritishSurveyor5882990003
    LESTER, Michael Arthur
    405 Cockfosters Road
    EN4 0JS Hadley Wood
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    405 Cockfosters Road
    EN4 0JS Hadley Wood
    Hertfordshire
    BritishCompany Director16107200001
    MORRIS, Martin Alan
    17 Copsewood Way
    HA6 2JP Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    17 Copsewood Way
    HA6 2JP Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director13448160001
    MURPHY, Peter Laurence
    42a Totteridge Common
    N20 London
    Geschäftsführer
    42a Totteridge Common
    N20 London
    EnglandBritishCompany Director77374270003
    SILVERMAN, Alan
    32 Copsewood Way
    HA6 2UA Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    32 Copsewood Way
    HA6 2UA Northwood
    Middlesex
    EnglandCanadianEstate Agent46409830001
    STELLON, Marco Pompeo
    Burney Court
    113 Manor Road
    IG7 5PS Chigwell
    Essex
    Geschäftsführer
    Burney Court
    113 Manor Road
    IG7 5PS Chigwell
    Essex
    EnglandEnglishDirector150726360001
    STELLON, Marco Pompeo
    Burney Court
    113 Manor Road
    IG7 5PS Chigwell
    Essex
    Geschäftsführer
    Burney Court
    113 Manor Road
    IG7 5PS Chigwell
    Essex
    EnglandEnglishDirector150726360001
    THOMPSON, Peter Mckelvey
    127 Bells Hill
    EN5 2SY Barnet
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    127 Bells Hill
    EN5 2SY Barnet
    Hertfordshire
    BritishAccountant97178760001
    WHITTON, Robert David
    6 Gidea Close
    Gidea Park
    RM2 5NP Romford
    Essex
    Geschäftsführer
    6 Gidea Close
    Gidea Park
    RM2 5NP Romford
    Essex
    EnglandBritishDirector141553070002
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Hat HUDSON CAPITAL (SPH) LTD. Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed charge over shares
    Erstellt am 21. Nov. 2011
    Geliefert am 02. Dez. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower and the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Full title guarantee as continuing security for the payment and discharge of the indebtedness charged to nationwide its entir right title and interest in and to the shares and their proceeds of sale. Number of shares in the guarantor - 215 (two hundred and fifteen). Denomination or type of shares - ordinary a shares see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Charge over deposit account
    Erstellt am 15. Jan. 2009
    Geliefert am 16. Jan. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The balance for the time being on the following bank account - account no. 46114246 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Dez. 2007
    Geliefert am 27. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land being unit 2 martinfields business centre martinfields welwyn garden ci. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 27. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 127. März 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 119. März 2011Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 1
    Debenture
    Erstellt am 19. Dez. 2007
    Geliefert am 27. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a unit f trevithick roadwillow brook industrial estate corby northamptonshire t/no NN215139,f/h property k/a rippleside commercial estate barking essex t/no EGL363117,f/h property k/A1-17 marlow workshops tower hamlets london t/no EGL202466 (for details of further properties charged please refer to for. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 27. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Sept. 2007
    Geliefert am 04. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property at rippleside commercial es. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 220. Apr. 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 219. März 2011Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 2
    Legal charge
    Erstellt am 25. Sept. 2007
    Geliefert am 04. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property being unit f, trevithick road willowbrook industrial estate corby N. together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 420. Apr. 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 419. März 2011Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 4
    Legal charge
    Erstellt am 25. Sept. 2007
    Geliefert am 04. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 1-17 marlow workshops T. together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 320. Apr. 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 313. Aug. 2010Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 3
    Debenture
    Erstellt am 25. Sept. 2007
    Geliefert am 04. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a unit f, trvithick roadwillow brook industrial estate corby northamptonshire t/no NN215139. F/h property k/a rippleside commercial estate barking essex t/no EGL363117 and f/h property k/a 1-17 marlow workshops tower hamlets. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 21. März 2006
    Geliefert am 05. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings at unit 2 martinfields business centre martinfield welwyn garden city herts t/no HD263190. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. März 2006
    Geliefert am 28. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Units 1-17 marlow workshops arnold circus tower hamlets london borough t/n EGL202466,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. März 2006
    Geliefert am 28. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Rippleside commercial estate ripple road barking t/n EGL363117,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. März 2006
    Geliefert am 28. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit f trevithick road willowbrook industrial estate corby northants t/n NN215139,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. März 2003
    Geliefert am 29. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a land on the west side of trvithick road corby t/no: NN215139.
    Berechtigte Personen
    • Standard Bank Jersey Limited
    Transaktionen
    • 29. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Juni 1998
    Geliefert am 01. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 1A-1C daleside road nottingham t/no;-NT34372 all buildings and fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lazard Brothers & Co. (Jersey) Limited
    Transaktionen
    • 01. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Jan. 1998
    Geliefert am 05. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F.h marshgate 16 marshgate lane stratford london E15 t/n NGL95958.
    Berechtigte Personen
    • Lazard Brothers & Co (Jersey) Limited
    Transaktionen
    • 05. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Jan. 1998
    Geliefert am 05. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a rippleside commercial estate,ripple road,barking,essex.t/no.EGL363117.
    Berechtigte Personen
    • Lazard Brothers & Co (Jersey) Limited
    Transaktionen
    • 05. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Jan. 1998
    Geliefert am 05. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that l/h property k/a woodside industrial estate,works road,letchworth,herts.t/no.HD205102.
    Berechtigte Personen
    • Lazard Brothers & Co (Jersey) Limited
    Transaktionen
    • 05. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second legal charge
    Erstellt am 16. Dez. 1997
    Geliefert am 30. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a deed of guarantee dated 19TH september 1997 and/or under the terms of this second legal charge
    Kurze Angaben
    Rippleside commercial estate ripple road barking t/n-EGL363117.
    Berechtigte Personen
    • Rothschild Trust Guernsey Limited
    Transaktionen
    • 30. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Sept. 1997
    Geliefert am 25. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a rippleside commercial estate all income and rights relating thereto proceeds of sale thereof and proceeds of all insurance floating charge undertaking and all other property assets and rights whatsoever and wheresoever present and future. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • N.M.Rothschild & Sons (C.I.) Limited
    Transaktionen
    • 25. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat HUDSON CAPITAL (SPH) LTD. Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Anthony Moore Haines
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Receiver Manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Andrew Vaughan
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Receiver Manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Anthony Moore Haines
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Receiver Manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Andrew Vaughan
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Receiver Manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    3Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Anthony Moore Haines
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Receiver Manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Andrew Vaughan
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Receiver Manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    4Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Anthony Moore Haines
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Receiver Manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Andrew Vaughan
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Receiver Manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0