WM (2002) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWM (2002) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03150483
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WM (2002) LIMITED?

    • (6420) /

    Wo befindet sich WM (2002) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place, Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WM (2002) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    IMS TELECOM LIMITED30. Okt. 199830. Okt. 1998
    WORLD TELECOMMUNICATIONS CORPORATION LIMITED20. Mai 199620. Mai 1996
    NUMBERASSET LIMITED24. Jan. 199624. Jan. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WM (2002) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis

    Welche sind die letzten Einreichungen für WM (2002) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    1 Seiten4.43

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Liquidators

    1 Seiten4.31

    Verschiedenes

    O/C - replacement of liquidator
    6 SeitenMISC

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    3 Seiten2.15

    Ernennung eines Liquidators

    1 Seiten4.31

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    2 SeitenCOCOMP

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    2 SeitenCOCOMP

    Mitteilung über die Aufhebung des Verwaltungsbeschlusses

    3 Seiten2.19

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    3 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    3 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    3 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators

    3 Seiten2.15

    legacy

    1 Seiten287

    Mitteilung über das Ergebnis der Gläubigerversammlung

    2 Seiten2.23

    Vorschlag des Administrators

    23 Seiten2.21

    legacy

    1 Seiten287

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    24 SeitenMA

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed ims telecom LIMITED\certificate issued on 15/02/02
    3 SeitenCERTNM

    Verwaltungsbeschluss

    4 Seiten2.7

    Mitteilung über den Verwaltungsbeschluss

    1 Seiten2.6

    legacy

    5 Seiten395

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von WM (2002) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HOWE, Trevor Bruce
    82 Main Street
    LS29 6HS Menston
    West Yorkshire
    Sekretär
    82 Main Street
    LS29 6HS Menston
    West Yorkshire
    English72313700001
    RYAN, Liam Francis
    9 Goole Road
    Swinefleet
    DN14 8AR Goole
    North Humberside
    Geschäftsführer
    9 Goole Road
    Swinefleet
    DN14 8AR Goole
    North Humberside
    EnglandBritish46971060001
    BELL, Kevin
    24 Hall Lee Fold
    HD3 3NX Huddersfield
    West Yorkshire
    Sekretär
    24 Hall Lee Fold
    HD3 3NX Huddersfield
    West Yorkshire
    British68546980001
    FOXFORD, Michael John
    5 Cooper Street
    M2 2FW Manchester
    Greater Manchester
    Sekretär
    5 Cooper Street
    M2 2FW Manchester
    Greater Manchester
    British96216260001
    FROGGATT, Nicholas Paul
    2 Leadhall Crescent
    HG2 9NG Harrogate
    North Yorkshire
    Sekretär
    2 Leadhall Crescent
    HG2 9NG Harrogate
    North Yorkshire
    British31066820001
    HALL, David
    22 Milton Rough
    Acton Bridge
    CW8 2RF Northwich
    Cheshire
    Sekretär
    22 Milton Rough
    Acton Bridge
    CW8 2RF Northwich
    Cheshire
    British6387590001
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    BELL, Kevin
    24 Hall Lee Fold
    HD3 3NX Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    24 Hall Lee Fold
    HD3 3NX Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish68546980001
    FROGGATT, Nicholas Paul
    2 Leadhall Crescent
    HG2 9NG Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    2 Leadhall Crescent
    HG2 9NG Harrogate
    North Yorkshire
    British31066820001
    HALL, David
    22 Milton Rough
    Acton Bridge
    CW8 2RF Northwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    22 Milton Rough
    Acton Bridge
    CW8 2RF Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish6387590001
    HOFFMAN, Lawrence
    Winton Lodge 11 Bentinck Road
    WA14 2BY Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Winton Lodge 11 Bentinck Road
    WA14 2BY Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish35569030002
    KNOWLES, Keith
    Bowden View
    Moss Lane, Ollerton
    WA16 8SW Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Bowden View
    Moss Lane, Ollerton
    WA16 8SW Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish65992090002
    NIELD, Gary Eric
    161 Mottram Road
    SK15 2QU Stalybridge
    Cheshire
    Geschäftsführer
    161 Mottram Road
    SK15 2QU Stalybridge
    Cheshire
    British61786060001
    ROUSE, Paul Michael
    Derwent Lodge
    Main Street
    YO4 5BN Sutton Upon Derwent
    York North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Derwent Lodge
    Main Street
    YO4 5BN Sutton Upon Derwent
    York North Yorkshire
    United KingdomBritish30392350001
    SMITH, Norman Harold
    14 Gorse Lane
    Oadby
    LE2 4RQ Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    14 Gorse Lane
    Oadby
    LE2 4RQ Leicester
    Leicestershire
    British43126170001
    WILSON, William Robinson
    Brendene, Layton Avenue
    Rawdon
    LS19 6QQ Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Brendene, Layton Avenue
    Rawdon
    LS19 6QQ Leeds
    West Yorkshire
    British29588110002
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    Hat WM (2002) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 30. Jan. 2002
    Geliefert am 02. Feb. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank S.A./N.V. (UK Branch)
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 31. Okt. 2000
    Geliefert am 08. Nov. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank Sa-Nv
    Transaktionen
    • 08. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Single debenture
    Erstellt am 26. März 1998
    Geliefert am 07. Apr. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Generale Bank N.V.-Generale De Banque S.A.
    Transaktionen
    • 07. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Single debenture
    Erstellt am 16. Dez. 1997
    Geliefert am 17. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Mai 1997
    Geliefert am 10. Juni 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • David Hall
    Transaktionen
    • 10. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Mai 1997
    Geliefert am 10. Juni 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Keith Knowles
    Transaktionen
    • 10. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 04. Juni 1996
    Geliefert am 10. Juni 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat WM (2002) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    07. Feb. 2002Beginn der Verwaltung
    14. Mai 2004Verwaltung entlassen
    Verwaltungsordnung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Garry Wilson
    Arthur Andersen
    1 City Square
    Leeds
    Ls1 2al
    Praktiker
    Arthur Andersen
    1 City Square
    Leeds
    Ls1 2al
    Simon Allport
    Bank House
    9 Charlotte Street
    M1 4EU Manchester
    Praktiker
    Bank House
    9 Charlotte Street
    M1 4EU Manchester
    2
    DatumTyp
    07. März 2011Aufgelöst am
    26. März 2004Antragsdatum
    30. Nov. 2010Abschluss der Liquidation
    14. Mai 2004Beginn der Liquidation
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Garry Wilson
    Ernst & Young
    Po Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    Praktiker
    Ernst & Young
    Po Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    Simon Allport
    Ernst & Young
    Cloth Hall Court
    14 King Street
    Leeds Ls1 2jn
    Praktiker
    Ernst & Young
    Cloth Hall Court
    14 King Street
    Leeds Ls1 2jn
    Garry Wilson
    Ernst & Young
    Po Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    Praktiker
    Ernst & Young
    Po Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    Simon Allport
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praktiker
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp
    Po Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    Po Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0