ABBEYPARK PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ABBEYPARK PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03152403 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ABBEYPARK PROPERTIES LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich ABBEYPARK PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Gable House 239 Regents Park Road N3 3LF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ABBEYPARK PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ABBEYPARK PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2020 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Jan. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Jan. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Jan. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Daniel Lloyd Platt am 20. Apr. 2012 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ABBEYPARK PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATT, Daniel Lloyd | Sekretär | 239 Regents Park Road N3 3LF London Gable House | British | 74067500002 | ||||||
| PLATT, Daniel Lloyd | Geschäftsführer | 239 Regents Park Road N3 3LF London Gable House | United Kingdom | British | 74067500005 | |||||
| SORSKY, Harold John | Geschäftsführer | 239 Regents Park Road N3 3LF London Gable House | United Kingdom | British | 36981120003 | |||||
| ACCESS REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | International House 31 Church Road Hendon NW4 4EB London | 900011510001 | |||||||
| ACCESS NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | International House 31 Church Road Hendon NW4 4EB London | 900011500001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ABBEYPARK PROPERTIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Daniel Lloyd Platt | 06. Apr. 2016 | 239 Regents Park Road N3 3LF Finchley Gable House London United Kingdom | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Harold John Sorsky | 06. Apr. 2016 | 239 Regents Park Road N3 3LF Finchley Gable House London United Kingdom | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat ABBEYPARK PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Third party legal charge | Erstellt am 22. Aug. 2006 Geliefert am 31. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from harber display limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that land and buildings on the west side of park road raunds northants,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Feb. 1998 Geliefert am 17. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a 4 crompton street,london W2.t/no.ngl 684036. the present and future goodwill of any business carried on at the property by or on behalf of the company and the proceeds of any insurance from time to time affecting the property.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Okt. 1996 Geliefert am 01. Nov. 1996 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 174 beam avenue dagenham essex t/n: egl 185796 the present and future goodwill of any business and the proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Okt. 1996 Geliefert am 10. Okt. 1996 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 54 coleman road dagenham essex t/n EGL259582 the present and future goodwill of any business and the proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Okt. 1996 Geliefert am 10. Okt. 1996 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property situate and k/a 4 brackley court pollitt drive wharncliffe gardens estate london NW8 the present and future goodwill of any business and the proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Aug. 1996 Geliefert am 14. Sept. 1996 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 3 leamington close manor park london E12 t/n EGL245568 and the present and future goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Mai 1996 Geliefert am 01. Juni 1996 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property known as 111 rowdons rd,dagenham,essex RM9 6NH; t/no egl 26239 with all plant,machinery,fixtures/fittings thereon; the goodwill of business and all furniture,equipment,tools and other chattels of the company; any proceeds of insurance. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0