AMEY DATEL GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAMEY DATEL GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03152636
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AMEY DATEL GROUP LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich AMEY DATEL GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von AMEY DATEL GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DATEL FERRANTI GROUP LIMITED30. Jan. 199630. Jan. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AMEY DATEL GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für AMEY DATEL GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Verschiedenes

    Section 519
    1 SeitenMISC

    Verschiedenes

    Section 519
    1 SeitenMISC

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Juni 2012

    Kapitalaufstellung am 21. Juni 2012

    • Kapital: GBP 10,504,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    14 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Melvyn Ewell am 30. Nov. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 02. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Sherard Secretariat Services Limited am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH04

    legacy

    1 Seiten190a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    14 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    14 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    14 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    4 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    14 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von AMEY DATEL GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer5615519
    109588620001
    EWELL, Melvyn
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritish61515760002
    NELSON, Andrew Latham
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish36191090003
    HUI, Carol
    GU8
    Sekretär
    GU8
    British72371980001
    SMITH, Michael John
    63 Fields Road
    Haslingden
    BB4 6QA Rossendale
    Lancashire
    Sekretär
    63 Fields Road
    Haslingden
    BB4 6QA Rossendale
    Lancashire
    British61711420001
    TETLOW, John Richard
    Whittaker Court, Gawsworth New Hall
    Church Lane, Gawsworth
    SK11 9RQ Macclesfield
    Cheshire
    Sekretär
    Whittaker Court, Gawsworth New Hall
    Church Lane, Gawsworth
    SK11 9RQ Macclesfield
    Cheshire
    British68445840001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ADAMS, Richard Hawthorn
    Bramley Cottage Coppice Hill
    Chalford
    GL6 8DZ Stroud
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Bramley Cottage Coppice Hill
    Chalford
    GL6 8DZ Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritish56940900001
    BATCHELOR, Graeme Warwick
    2 Brookway
    Wrea Green
    PR4 2NU Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    2 Brookway
    Wrea Green
    PR4 2NU Preston
    Lancashire
    British58892340002
    BRADBURY, Richard George
    Beech Cottage Beech Lane
    WA6 6LP Norley
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Beech Cottage Beech Lane
    WA6 6LP Norley
    Cheshire
    British42234330002
    ENTWISTLE, Richard William
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    British50174710001
    ENTWISTLE, Richard William
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    British50174710001
    HARRIS, Howard Daniel
    The Oaks Station Road
    Singleton
    FY6 8LG Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Geschäftsführer
    The Oaks Station Road
    Singleton
    FY6 8LG Poulton Le Fylde
    Lancashire
    British44607740001
    KAYSER, Michael Arthur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritish141893610001
    LEO, Jose
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Spanish93348510004
    MCCARTNEY, Alan
    17 The Orchards
    WA16 0LS Pickmere
    Cheshire
    Geschäftsführer
    17 The Orchards
    WA16 0LS Pickmere
    Cheshire
    British118583390001
    MILLER, David John
    1 Asmara Road
    NW2 3SS London
    Geschäftsführer
    1 Asmara Road
    NW2 3SS London
    United KingdomBritish152304230002
    MOGG, Charles Michael
    Ladywood Stray
    Church Road, Wilmcote
    CV37 9XD Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Ladywood Stray
    Church Road, Wilmcote
    CV37 9XD Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British87961010001
    MORRIS, Keith Peter
    Keepers Cottage
    Lilac Avenue
    FY8 4LG Lytham St. Annes
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Keepers Cottage
    Lilac Avenue
    FY8 4LG Lytham St. Annes
    Lancashire
    United KingdomBritish43135960002
    MURAD, Simon William
    The Rookeries
    Roundabout Copse
    RH20 2RB West Chiltington
    West Sussex
    Geschäftsführer
    The Rookeries
    Roundabout Copse
    RH20 2RB West Chiltington
    West Sussex
    United KingdomBritish75114990001
    PEAT, Stephen Hedley
    25 Canynge Square
    Clifton
    BS8 3LB Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    25 Canynge Square
    Clifton
    BS8 3LB Bristol
    Avon
    British70137370001
    POWERS, Glenn Patrick
    23 Sefton Drive
    M28 2NG Worsley
    Manchester
    Geschäftsführer
    23 Sefton Drive
    M28 2NG Worsley
    Manchester
    British72486520001
    PUGH, Graham John
    The Windmill Mill Lane
    Wrea Green
    PR4 2WP Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    The Windmill Mill Lane
    Wrea Green
    PR4 2WP Preston
    Lancashire
    British24512450001
    ROBINSON, John Hamilton
    Bull Rush House 8 Kennett Place
    Chilton Foliat
    RG17 0TB Hungerford
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Bull Rush House 8 Kennett Place
    Chilton Foliat
    RG17 0TB Hungerford
    Berkshire
    American69410760003
    STAPLES, Brian Lynn
    Pendle House
    Castle Hill Prestbury
    SK10 4AR Macclesfield
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Pendle House
    Castle Hill Prestbury
    SK10 4AR Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritish55479560003
    SWEENEY, John Trevor
    6 Scarlet Oaks
    Portsmouth Road
    GU15 1RD Camberley
    Surrey
    Geschäftsführer
    6 Scarlet Oaks
    Portsmouth Road
    GU15 1RD Camberley
    Surrey
    British70137390001
    WILLIAMSON, Stephen
    120 Warbreck Hill Road
    FY2 0TR Blackpool
    Lancashire
    Geschäftsführer
    120 Warbreck Hill Road
    FY2 0TR Blackpool
    Lancashire
    British36188290001

    Hat AMEY DATEL GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 14. März 2003
    Geliefert am 26. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee on Behalf of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 26. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. Juni 1998
    Geliefert am 17. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 10. Okt. 1996
    Geliefert am 17. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. März 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0