BUCKINGHAM HUNTS CROSS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BUCKINGHAM HUNTS CROSS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03153697 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BUCKINGHAM HUNTS CROSS LIMITED?
- Glücksspiel- und Wettbetriebe (92000) / Kunst, Unterhaltung und Erholung
Wo befindet sich BUCKINGHAM HUNTS CROSS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Haberfield Old Moor Road Wennington LA2 8PD Lancaster |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BUCKINGHAM HUNTS CROSS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CAMBOS HUNTS CROSS LIMITED | 12. Apr. 1996 | 12. Apr. 1996 |
| INVESTDAY LIMITED | 31. Jan. 1996 | 31. Jan. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BUCKINGHAM HUNTS CROSS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BUCKINGHAM HUNTS CROSS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2019 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2018 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2017 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2016 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2015 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2014 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Verschiedenes Sec 519 | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2013 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Apr. 2012 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jonathan James Walker am 02. Feb. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. März 2011 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BUCKINGHAM HUNTS CROSS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIMMER, David Norman | Geschäftsführer | Newport Road ST21 6BE Eccleshall Ridgefield 23 Staffordshire England | United Kingdom | British | 71617270002 | |||||
| WALKER, Jonathan James | Geschäftsführer | Old Moor Road Wennington LA2 8PD Lancaster Haberfield England | England | British | 39444010001 | |||||
| ALLY, Bibi Rahima | Sekretär | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | British | 38963210003 | ||||||
| O'CALLAGHAN, Joseph | Sekretär | 9 Mallard Walk DE3 0TF Derby Derbyshire | British | 110216340001 | ||||||
| PEARSON, Andrew Guy | Sekretär | Ladyhill View Worsley M28 7LH Manchester 42 | British | 134403640001 | ||||||
| RICHMOND, Chantal Zenobia Renee | Sekretär | 3 Brookside Cuddington CW8 2QA Northwich Cheshire | British | 17429610002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ANDERSON, John Frederick | Geschäftsführer | 69 Culcheth Hall Drive Culcheth WA3 4PX Warrington | United Kingdom | British | 4569620002 | |||||
| CUNNINGHAM, William Andrew | Geschäftsführer | 4 Goodwood Rise CW10 9FJ Middlewich Cheshire | England | British | 113656620001 | |||||
| DOBSON, Stephen | Geschäftsführer | 24 Parklands Drive Weston CW2 5FH Crewe | United Kingdom | British | 127852340001 | |||||
| KOSSOWSKI, Mark Sylvester | Geschäftsführer | St Jude Stoney Lane SK9 6LG Wilmslow Cheshire | British | 110423140001 | ||||||
| O'CALLAGHAN, Joseph | Geschäftsführer | 9 Mallard Walk DE3 0TF Derby Derbyshire | England | British | 110216340001 | |||||
| PANAYI, Panico | Geschäftsführer | Kato Drys Victoria Road Heaton BL1 5AW Bolton Lancashire | British | 9075400001 | ||||||
| PEARSON, Andrew Guy | Geschäftsführer | Ladyhill View Worsley M28 7LH Manchester 42 | England | British | 134403640001 | |||||
| RICHMOND, Chantal Zenobia Renee | Geschäftsführer | 3 Brookside Cuddington CW8 2QA Northwich Cheshire | British | 17429610002 | ||||||
| TAYLOR, Graham Jack | Geschäftsführer | 36 Ullswater Drive Killingworth NE12 8GX Newcastle | British | 110423300001 | ||||||
| WALSH, Neil | Geschäftsführer | The Paddock Beardwood BB2 7QY Blackburn 2 Lancashire | United Kingdom | British | 134469650001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BUCKINGHAM HUNTS CROSS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckingam Bingo Limited | 06. Apr. 2016 | Old Moor Road Wennington LA2 8PD Lancaster Haberfield Lancashire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat BUCKINGHAM HUNTS CROSS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 19. Dez. 2005 Geliefert am 29. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 249 stanley road bootle t/n MS235764 bingo club poplar bank huyton knowsley merseyside t/n MS365314 601 chester road old trafford t/n GM817722 for furter details of the properties charged please refer to form 395 the real property any goodwill the shares all dividends interest and other monies the proceeds of insurance floating charge the companys undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 19. Dez. 2005 Geliefert am 29. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land south of speke hall cross liverpool t/n MS352781 MS352843 MS352999. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage (customer's account) | Erstellt am 06. März 2003 Geliefert am 14. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the customer to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land on west side of speke hall road liverpool title numbers MS352781, MS352843 and MS352999. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Okt. 1998 Geliefert am 07. Nov. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a buckingham bingo hall speke hall road liverpool together with the proceeds of sale thereof all buildings and fixtures the insurance policy in respect of the property and the goodwill of the business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Juli 1998 Geliefert am 29. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a land south of industrial estate access road merseyside enterprise trading park speke hall road hunts cross liverpool together with all buildings and fixtures (including trade and tenant's fixtures) thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Apr. 1998 Geliefert am 01. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0