BS REALISATIONS (2009) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BS REALISATIONS (2009) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03153784 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BS REALISATIONS (2009) LIMITED?
- (5243) /
Wo befindet sich BS REALISATIONS (2009) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BS REALISATIONS (2009) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BERTIE SHOES LIMITED | 08. Feb. 2001 | 08. Feb. 2001 |
| CABLE & CO (UK) LIMITED | 26. Jan. 1996 | 26. Jan. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BS REALISATIONS (2009) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 26. Jan. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BS REALISATIONS (2009) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 30. März 2010 | 8 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 30. März 2010 | 1 Seiten | 2.35B | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 01. Sept. 2009 | 21 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 5 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 33 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed bertie shoes LIMITED\certificate issued on 23/03/09 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Jan. 2008 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Jan. 2007 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 31 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
legacy | 18 Seiten | 155(6)a | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 5 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BS REALISATIONS (2009) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILKS, Jessica | Sekretär | 1 Forge Cottages High Street RH8 0DT Limpsfield Surrey | British | 116562380001 | ||||||
| GLANVILLE, Richard Spencer | Geschäftsführer | Babshole Farm Sudburys Farm Road CM12 9SP Little Burstead Essex | United Kingdom | British | 69669910005 | |||||
| LOVELOCK, Derek John | Geschäftsführer | Oldfields Farm Amersham Road HP9 2UG Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 116560620001 | |||||
| LUSTMAN, Margaret Eve | Geschäftsführer | Exeter Road NW2 4SE London 49 | England | British | 40930620002 | |||||
| SHEARWOOD, Mike | Geschäftsführer | Upton Fields House Upton Road NG25 0QA Southwell Nottinghamshire | England | British | 95093740001 | |||||
| CASSAR, Stefan | Sekretär | 48 Norroy Road SW15 1PF London | British | 57039310004 | ||||||
| FLEETWOOD, Matthew David | Sekretär | 37 Hunts Field Close WA13 0SS Lymm Cheshire | British | 67509880002 | ||||||
| HALL, Vikki | Sekretär | 28 Burman Drive Coleshill B46 3NB Birmingham | British | 82602670001 | ||||||
| KAPPES, Alyson Elizabeth | Sekretär | 40 Duke Street W1A 2HP London | British | 47964550001 | ||||||
| KAPPES, Alyson Elizabeth | Sekretär | 139 Clapham Road SW99 0HR London | British | 46132570001 | ||||||
| MCCARTHY, Donald | Sekretär | 20 Copley Dene BR1 2PW Bromley Kent | British | 64482220001 | ||||||
| MCCARTHY, Julie Ann | Sekretär | Attleborough House Townsend Drive Attleborough Fields Indu CV11 6RU Nuneaton Warwickshire | British | 54849760001 | ||||||
| PHILIP, Colin James | Sekretär | 11 Oakcroft Close HA5 3YY Pinner Middlesex | British | 8205160001 | ||||||
| QUINLAN, Diane | Sekretär | 40 Duke Street W1A 2HP London | British | 38760910001 | ||||||
| CASSAR, Stefan | Geschäftsführer | 48 Norroy Road SW15 1PF London | British | 57039310004 | ||||||
| COTTERELL, Rebecca Jane | Geschäftsführer | Attleborough House CV11 6RU Nuneaton Warwickshire | British | 37924130001 | ||||||
| DANSKY, Ira | Geschäftsführer | 115 Dundee Drive Stamford Connecticut 06903 Usa | Us Citizen | 72028040001 | ||||||
| DARLINGTON, John | Geschäftsführer | Attleborough House Townsend Drive CV11 6RU Nuneaton Warwickshire | British | 145849750001 | ||||||
| DEFTY, David Andrew | Geschäftsführer | Radcliffe House Blenheim Court B91 2AA Solihull | British | 38530980001 | ||||||
| DIPUMA, Gloria Walker | Geschäftsführer | 45 Tupper Drive 06902 Stamford Connecticut America | Us Citizen | 59134040001 | ||||||
| DRUM, John David Francis | Geschäftsführer | 1 Garrick Road Hendon NW9 6AU London | British | 13103440003 | ||||||
| DRUM, John David Francis | Geschäftsführer | 1 Garrick Road Hendon NW9 6AU London | British | 13103440003 | ||||||
| EGAN, John Gerard | Geschäftsführer | 17 Kent Road KT8 9JZ East Molesey Surrey | British | 73851980002 | ||||||
| GALVIN, Robert | Geschäftsführer | 44 Holmes Road Ridgefield Connecticut Ct 06877 Usa | American | 53481670001 | ||||||
| GRIFFITHS, David John | Geschäftsführer | Radcliffe Houseet Blenheim Court B91 2AA Solihull West Midlands | British | 78157950001 | ||||||
| HODSON, Beverley Cliffe | Geschäftsführer | 139 Clapham SW9 0HR London | British | 53709690001 | ||||||
| HOWALD, Jeffrey Kevin | Geschäftsführer | 2155 Riding Trail Drive Chesterfield 63005 FOREIGN Missouri Usa | Us Citizen | 72240490001 | ||||||
| LENICH, William | Geschäftsführer | 5 Spruce Meadow Court Wilton Connecticut Ct 06897 Usa | American | 50466570001 | ||||||
| MADORE, Robert | Geschäftsführer | 463 North Street Ridefield Ct 06877 United States | American | 73693980001 | ||||||
| MCCARTHY, Donald | Geschäftsführer | 2 Fairway Gardens Park Langley BR3 6YL Beckenham London | British | 64482220002 | ||||||
| MINTERN, Andrew | Geschäftsführer | 1 Garrick Road Hendon NW9 6AU London | British | 49420330001 | ||||||
| O'CONNOR, Michael Victor | Geschäftsführer | 40 Duke Street W1A 2HP London | British | 67194680004 | ||||||
| PACK, Michael Anthony | Geschäftsführer | 40 Duke Street W1A 2HP London | British | 40673900001 | ||||||
| RENNISON, Gordon | Geschäftsführer | Attleborough House Townsend Drive Attleborough Fields Indu CV11 6RU Nuneaton Warwickshire | British | 59804930003 | ||||||
| SPITZ, David Barry | Geschäftsführer | Flat 3 The Pavilions 24/26 Avenue Road St Johns Wood NW8 6BS London | United Kingdom | British | 34724360002 |
Hat BS REALISATIONS (2009) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession | Erstellt am 14. März 2008 Geliefert am 27. März 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Okt. 2006 Geliefert am 21. Okt. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Feb. 2005 Geliefert am 12. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Aug. 2003 Geliefert am 02. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due , subject to a maximum aggregate amount of £3,500,000, from the company and each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Floating charge all assets now or in future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture between the company and others (as charging companies) and the chargee | Erstellt am 29. Jan. 2001 Geliefert am 09. Feb. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (formerly k/a cable & co (UK) limited and/or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BS REALISATIONS (2009) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0