BS REALISATIONS (2009) LIMITED

BS REALISATIONS (2009) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBS REALISATIONS (2009) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03153784
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BS REALISATIONS (2009) LIMITED?

    • (5243) /

    Wo befindet sich BS REALISATIONS (2009) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BS REALISATIONS (2009) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BERTIE SHOES LIMITED08. Feb. 200108. Feb. 2001
    CABLE & CO (UK) LIMITED26. Jan. 199626. Jan. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BS REALISATIONS (2009) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis26. Jan. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für BS REALISATIONS (2009) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 30. März 2010

    8 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 30. März 2010

    1 Seiten2.35B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 01. Sept. 2009

    21 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    5 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    33 Seiten2.17B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten287

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed bertie shoes LIMITED\certificate issued on 23/03/09
    3 SeitenCERTNM

    Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Jan. 2008

    12 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Jan. 2007

    13 SeitenAA

    legacy

    31 Seiten395

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    7 Seiten363s

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    legacy

    18 Seiten155(6)a

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Facility/loan agreement 12/10/06
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Gewährung finanzieller Unterstützung für den Erwerb von Aktien

    RES07

    Beschlüsse

    Resolutions
    5 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von BS REALISATIONS (2009) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WILKS, Jessica
    1 Forge Cottages
    High Street
    RH8 0DT Limpsfield
    Surrey
    Sekretär
    1 Forge Cottages
    High Street
    RH8 0DT Limpsfield
    Surrey
    British116562380001
    GLANVILLE, Richard Spencer
    Babshole Farm
    Sudburys Farm Road
    CM12 9SP Little Burstead
    Essex
    Geschäftsführer
    Babshole Farm
    Sudburys Farm Road
    CM12 9SP Little Burstead
    Essex
    United KingdomBritish69669910005
    LOVELOCK, Derek John
    Oldfields Farm
    Amersham Road
    HP9 2UG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Oldfields Farm
    Amersham Road
    HP9 2UG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116560620001
    LUSTMAN, Margaret Eve
    Exeter Road
    NW2 4SE London
    49
    Geschäftsführer
    Exeter Road
    NW2 4SE London
    49
    EnglandBritish40930620002
    SHEARWOOD, Mike
    Upton Fields House
    Upton Road
    NG25 0QA Southwell
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Upton Fields House
    Upton Road
    NG25 0QA Southwell
    Nottinghamshire
    EnglandBritish95093740001
    CASSAR, Stefan
    48 Norroy Road
    SW15 1PF London
    Sekretär
    48 Norroy Road
    SW15 1PF London
    British57039310004
    FLEETWOOD, Matthew David
    37 Hunts Field Close
    WA13 0SS Lymm
    Cheshire
    Sekretär
    37 Hunts Field Close
    WA13 0SS Lymm
    Cheshire
    British67509880002
    HALL, Vikki
    28 Burman Drive
    Coleshill
    B46 3NB Birmingham
    Sekretär
    28 Burman Drive
    Coleshill
    B46 3NB Birmingham
    British82602670001
    KAPPES, Alyson Elizabeth
    40 Duke Street
    W1A 2HP London
    Sekretär
    40 Duke Street
    W1A 2HP London
    British47964550001
    KAPPES, Alyson Elizabeth
    139 Clapham Road
    SW99 0HR London
    Sekretär
    139 Clapham Road
    SW99 0HR London
    British46132570001
    MCCARTHY, Donald
    20 Copley Dene
    BR1 2PW Bromley
    Kent
    Sekretär
    20 Copley Dene
    BR1 2PW Bromley
    Kent
    British64482220001
    MCCARTHY, Julie Ann
    Attleborough House Townsend Drive
    Attleborough Fields Indu
    CV11 6RU Nuneaton
    Warwickshire
    Sekretär
    Attleborough House Townsend Drive
    Attleborough Fields Indu
    CV11 6RU Nuneaton
    Warwickshire
    British54849760001
    PHILIP, Colin James
    11 Oakcroft Close
    HA5 3YY Pinner
    Middlesex
    Sekretär
    11 Oakcroft Close
    HA5 3YY Pinner
    Middlesex
    British8205160001
    QUINLAN, Diane
    40 Duke Street
    W1A 2HP London
    Sekretär
    40 Duke Street
    W1A 2HP London
    British38760910001
    CASSAR, Stefan
    48 Norroy Road
    SW15 1PF London
    Geschäftsführer
    48 Norroy Road
    SW15 1PF London
    British57039310004
    COTTERELL, Rebecca Jane
    Attleborough House
    CV11 6RU Nuneaton
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Attleborough House
    CV11 6RU Nuneaton
    Warwickshire
    British37924130001
    DANSKY, Ira
    115 Dundee Drive
    Stamford
    Connecticut 06903
    Usa
    Geschäftsführer
    115 Dundee Drive
    Stamford
    Connecticut 06903
    Usa
    Us Citizen72028040001
    DARLINGTON, John
    Attleborough House Townsend Drive
    CV11 6RU Nuneaton
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Attleborough House Townsend Drive
    CV11 6RU Nuneaton
    Warwickshire
    British145849750001
    DEFTY, David Andrew
    Radcliffe House
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    Geschäftsführer
    Radcliffe House
    Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    British38530980001
    DIPUMA, Gloria Walker
    45 Tupper Drive
    06902 Stamford
    Connecticut
    America
    Geschäftsführer
    45 Tupper Drive
    06902 Stamford
    Connecticut
    America
    Us Citizen59134040001
    DRUM, John David Francis
    1 Garrick Road
    Hendon
    NW9 6AU London
    Geschäftsführer
    1 Garrick Road
    Hendon
    NW9 6AU London
    British13103440003
    DRUM, John David Francis
    1 Garrick Road
    Hendon
    NW9 6AU London
    Geschäftsführer
    1 Garrick Road
    Hendon
    NW9 6AU London
    British13103440003
    EGAN, John Gerard
    17 Kent Road
    KT8 9JZ East Molesey
    Surrey
    Geschäftsführer
    17 Kent Road
    KT8 9JZ East Molesey
    Surrey
    British73851980002
    GALVIN, Robert
    44 Holmes Road
    Ridgefield Connecticut Ct 06877
    Usa
    Geschäftsführer
    44 Holmes Road
    Ridgefield Connecticut Ct 06877
    Usa
    American53481670001
    GRIFFITHS, David John
    Radcliffe Houseet Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Radcliffe Houseet Blenheim Court
    B91 2AA Solihull
    West Midlands
    British78157950001
    HODSON, Beverley Cliffe
    139 Clapham
    SW9 0HR London
    Geschäftsführer
    139 Clapham
    SW9 0HR London
    British53709690001
    HOWALD, Jeffrey Kevin
    2155 Riding Trail Drive
    Chesterfield 63005
    FOREIGN Missouri Usa
    Geschäftsführer
    2155 Riding Trail Drive
    Chesterfield 63005
    FOREIGN Missouri Usa
    Us Citizen72240490001
    LENICH, William
    5 Spruce Meadow Court
    Wilton
    Connecticut Ct 06897
    Usa
    Geschäftsführer
    5 Spruce Meadow Court
    Wilton
    Connecticut Ct 06897
    Usa
    American50466570001
    MADORE, Robert
    463 North Street
    Ridefield
    Ct 06877
    United States
    Geschäftsführer
    463 North Street
    Ridefield
    Ct 06877
    United States
    American73693980001
    MCCARTHY, Donald
    2 Fairway Gardens
    Park Langley
    BR3 6YL Beckenham
    London
    Geschäftsführer
    2 Fairway Gardens
    Park Langley
    BR3 6YL Beckenham
    London
    British64482220002
    MINTERN, Andrew
    1 Garrick Road
    Hendon
    NW9 6AU London
    Geschäftsführer
    1 Garrick Road
    Hendon
    NW9 6AU London
    British49420330001
    O'CONNOR, Michael Victor
    40 Duke Street
    W1A 2HP London
    Geschäftsführer
    40 Duke Street
    W1A 2HP London
    British67194680004
    PACK, Michael Anthony
    40 Duke Street
    W1A 2HP London
    Geschäftsführer
    40 Duke Street
    W1A 2HP London
    British40673900001
    RENNISON, Gordon
    Attleborough House Townsend Drive
    Attleborough Fields Indu
    CV11 6RU Nuneaton
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Attleborough House Townsend Drive
    Attleborough Fields Indu
    CV11 6RU Nuneaton
    Warwickshire
    British59804930003
    SPITZ, David Barry
    Flat 3 The Pavilions
    24/26 Avenue Road St Johns Wood
    NW8 6BS London
    Geschäftsführer
    Flat 3 The Pavilions
    24/26 Avenue Road St Johns Wood
    NW8 6BS London
    United KingdomBritish34724360002

    Hat BS REALISATIONS (2009) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of accession
    Erstellt am 14. März 2008
    Geliefert am 27. März 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Kaupthing Bank Hf. (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 27. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 12. Okt. 2006
    Geliefert am 21. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kaupthing Bank Hf. (As Security Trustee for the Secured Parties) (the "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 02. Feb. 2005
    Geliefert am 12. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kaupthing Bank Hf (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Aug. 2003
    Geliefert am 02. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due , subject to a maximum aggregate amount of £3,500,000, from the company and each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Floating charge all assets now or in future.
    Berechtigte Personen
    • David Spitz for and on Behalf of Himself and as Agent on Behalf of the Noteholders
    Transaktionen
    • 02. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture between the company and others (as charging companies) and the chargee
    Erstellt am 29. Jan. 2001
    Geliefert am 09. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly k/a cable & co (UK) limited and/or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BS REALISATIONS (2009) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    02. März 2009Beginn der Verwaltung
    30. März 2010Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Philip Stephen Bowers
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Lee Antony Manning
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0