PHONES 4U LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePHONES 4U LIMITED
    UnternehmensstatusIn Verwaltung
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03154198
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PHONES 4U LIMITED?

    • Einzelhandel mit Mobiltelefonen (47421) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich PHONES 4U LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Central Square 8th Floor
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PHONES 4U LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PHONES (4U) LIMITED25. Feb. 199725. Feb. 1997
    4U (RETAIL) LIMITED06. März 199606. März 1996
    TRYLASER LIMITED02. Feb. 199602. Feb. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PHONES 4U LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2013
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Sept. 2014
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für PHONES 4U LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis31. Okt. 2016
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung14. Nov. 2016
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PHONES 4U LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für PHONES 4U LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    57 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    61 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    51 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    52 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    53 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    51 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    4 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    53 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    51 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    50 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    60 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    49 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    48 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    61 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    7 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    59 SeitenAM10

    Mitteilung über den Beschluss zur Abberufung des Administrators vom Amt

    14 SeitenAM16

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    64 SeitenAM10

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz- oder zusätzlichen Verwalters

    3 SeitenAM11

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    62 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    62 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    6 SeitenAM19

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    4 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    62 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 20. Jan. 2017

    59 Seiten2.24B

    Wer sind die Geschäftsführer von PHONES 4U LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LLOYD, Steven
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    Sekretär
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    British127681060001
    DOBSON, Philip David
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    United KingdomBritish95437530004
    FISHER, Nicholas Paul
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    EnglandBritish191557090001
    HOOTON, Scott
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    EnglandBritish80561600003
    KASSLER, David Nicholas
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    EnglandBritish,American139908820001
    LLOYD, Steven
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    EnglandBritish139477080001
    MORRIS, John Edward
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    EnglandBritish92903390003
    SHORTEN, Thomas
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    United KingdomBritish124006980001
    WHITING, Timothy James
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    United KingdomBritish44028500003
    WHITTLE, John James
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    EnglandBritish184246600001
    BENNETT, Craig
    Merry Fox
    Hall Lane
    WA16 7AH Mobberley
    Cheshire
    Sekretär
    Merry Fox
    Hall Lane
    WA16 7AH Mobberley
    Cheshire
    British34704080002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARTON, John Michael
    30 Deerings Drive
    HA5 2NZ Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    30 Deerings Drive
    HA5 2NZ Pinner
    Middlesex
    British34831450001
    BENNETT, Craig
    Merry Fox
    Hall Lane
    WA16 7AH Mobberley
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Merry Fox
    Hall Lane
    WA16 7AH Mobberley
    Cheshire
    United KingdomBritish34704080002
    BERESFORD-WILLIAMS, Andrew David
    Ore Close
    Lymedale Business Park
    ST5 9QD Newcastle Under Lyme
    Osprey House
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Ore Close
    Lymedale Business Park
    ST5 9QD Newcastle Under Lyme
    Osprey House
    Staffordshire
    EnglandBritish104764870003
    BILLINGS, Darren John
    Ore Close
    Lymedale Business Park
    ST5 9QD Newcastle Under Lyme
    Osprey House
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Ore Close
    Lymedale Business Park
    ST5 9QD Newcastle Under Lyme
    Osprey House
    Staffordshire
    United KingdomBritish103631680002
    BOYCE, Stephen
    2 Acton Court
    Acton
    DY13 9TF Nr Stourport Upon Severn
    The Wain Hosue
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    2 Acton Court
    Acton
    DY13 9TF Nr Stourport Upon Severn
    The Wain Hosue
    Worcestershire
    EnglandBritish177964100001
    BRATERMAN, Russell Charles
    Ore Close
    Lymedale Business Park
    ST5 9QD Newcastle Under Lyme
    Osprey House
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Ore Close
    Lymedale Business Park
    ST5 9QD Newcastle Under Lyme
    Osprey House
    Staffordshire
    EnglandBritish142333580001
    BROWN, Peter
    Hawthorn Cottage 19 Station Road
    Barlaston
    ST12 9DH Stoke On Trent
    Geschäftsführer
    Hawthorn Cottage 19 Station Road
    Barlaston
    ST12 9DH Stoke On Trent
    British46865080001
    CATTERSON, Anthony James Christopher
    22 The Stables
    Bostock Hall, Bostock
    CW10 9JN Middlewich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    22 The Stables
    Bostock Hall, Bostock
    CW10 9JN Middlewich
    Cheshire
    British77737100002
    CAUDWELL, Brian, Mr.
    Brooklands
    Sarisbury Green
    SO31 7EE Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Brooklands
    Sarisbury Green
    SO31 7EE Southampton
    Hampshire
    EnglandBritish15920410004
    CAUDWELL, John David
    Broughton Hall
    Broughton
    ST21 6NS Eccleshall
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Broughton Hall
    Broughton
    ST21 6NS Eccleshall
    Staffordshire
    EnglandBritish21185880002
    CAUNCE, Stephen James
    The Gables 88 Station Road
    Croston
    PR26 9RP Leyland
    Geschäftsführer
    The Gables 88 Station Road
    Croston
    PR26 9RP Leyland
    EnglandBritish97375180001
    CHIBNALL, Jason Martin
    43 Salt Meadows
    CW5 5HF Nantwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    43 Salt Meadows
    CW5 5HF Nantwich
    Cheshire
    British96948320001
    COLLEY, William Paul
    78a Deacons Hill Road
    Elstree
    WD6 3JG Borehamwood
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    78a Deacons Hill Road
    Elstree
    WD6 3JG Borehamwood
    Hertfordshire
    British34503660001
    DOWNIE, David Stewart
    Gable Court
    Crabtree Green Collingham
    LS22 5AB Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gable Court
    Crabtree Green Collingham
    LS22 5AB Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish101857040001
    GIBBONS, David John
    2 Jackson Way
    KT19 7LG Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Jackson Way
    KT19 7LG Epsom
    Surrey
    British86869020001
    GRANT, Mary Alexander
    Ore Close
    Lymedale Business Park
    ST5 9QD Newcastle Under Lyme
    Osprey House
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Ore Close
    Lymedale Business Park
    ST5 9QD Newcastle Under Lyme
    Osprey House
    Staffordshire
    United KingdomBritish69815990010
    GREEN, Peter Raymond
    Tennant Laithe
    Hebden Road, Grassington
    BD23 5DA Skipton
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Tennant Laithe
    Hebden Road, Grassington
    BD23 5DA Skipton
    North Yorkshire
    British86310880001
    HAMBURGER, Paul
    98 Park Road
    Hale
    WA15 9LF Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    98 Park Road
    Hale
    WA15 9LF Altrincham
    Cheshire
    British68012450002
    HAMBURGER, Paul
    98 Park Road
    Hale
    WA15 9LF Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    98 Park Road
    Hale
    WA15 9LF Altrincham
    Cheshire
    British68012450002
    KELLETT, Ian Michael
    35 Cherry Fields
    Kings Road
    BD2 1LB Bradford
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    35 Cherry Fields
    Kings Road
    BD2 1LB Bradford
    West Yorkshire
    British56311820001
    MOORE, Trevor Philip
    G4 The Ziggurat
    Saffron Hill
    EC1N 8QX London
    Geschäftsführer
    G4 The Ziggurat
    Saffron Hill
    EC1N 8QX London
    British96948240001
    O'QUINN, Richard Charles
    Barn House Duck End Lane
    Biddenham
    MK40 4AL Bedford
    Geschäftsführer
    Barn House Duck End Lane
    Biddenham
    MK40 4AL Bedford
    EnglandEnglish47892720001
    O'REILLY, Ian Mark
    Clevedon
    Bedcroft Road
    ST12 9AL Barlaston
    Stoke On Trent
    Geschäftsführer
    Clevedon
    Bedcroft Road
    ST12 9AL Barlaston
    Stoke On Trent
    British74412930001

    Hat PHONES 4U LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 15. Mai 2013
    Geliefert am 24. Mai 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Mai 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    An omnibus set-off agreement
    Erstellt am 22. Dez. 2011
    Geliefert am 23. Dez. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the companies with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in any other currency or currency unit, and the debt or debts owing by the bank represented by any such sum or sums (each such sum and debt being a credit balance).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 03. Mai 2011
    Geliefert am 16. Mai 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any member of the group to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V.London Branch (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 16. Mai 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off
    Erstellt am 12. Feb. 2010
    Geliefert am 16. Feb. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Feb. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 24. Apr. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Consent letter
    Erstellt am 08. Dez. 2009
    Geliefert am 18. Dez. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The short particulars of all the property mortgaged or charged are as set out in the debenture, in the consent letter the company charges, all investments, including any dividend, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V. London Branch
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 24. Apr. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    An omnibus letter of set-off (olso)
    Erstellt am 24. Sept. 2009
    Geliefert am 01. Okt. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Apr. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A shares charge
    Erstellt am 11. Okt. 2006
    Geliefert am 20. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge the charged property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V,London Branch as Security Trustee
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Apr. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A shares charge
    Erstellt am 11. Okt. 2006
    Geliefert am 20. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge the charged property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V,London Branch as the Security Trustee
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Apr. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of accession
    Erstellt am 11. Okt. 2006
    Geliefert am 20. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each charger to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V, London Branch as Security Trustee for the Secured Creditors (The Securitytrustee)
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Apr. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 22. Feb. 1996
    Geliefert am 27. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat PHONES 4U LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    15. Sept. 2014Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul David Copley
    45 Garden Road
    BR1 3LU Bromley
    Kent
    Praktiker
    45 Garden Road
    BR1 3LU Bromley
    Kent
    David James Kelly
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Robert John Moran
    7 More London
    Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London
    Riverside
    SE1 2RT London
    Robert Jonathan Hunt
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Ian David Green
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0