CAMERA EQUITY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CAMERA EQUITY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03155952 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CAMERA EQUITY LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich CAMERA EQUITY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Central Square 8th Floor 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CAMERA EQUITY LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| JESSOPS LIMITED | 12. Sept. 2002 | 12. Sept. 2002 |
| JESSOPS PUBLIC LIMITED COMPANY | 05. Mai 1998 | 05. Mai 1998 |
| JESSOP INTERNATIONAL LIMITED | 05. Juli 1996 | 05. Juli 1996 |
| INGLEBY (874) LIMITED | 06. Feb. 1996 | 06. Feb. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CAMERA EQUITY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CAMERA EQUITY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 18 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Insolvenzmeldung Insolvency:secretary of state certificate of release of liquidator | 1 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | Seiten | 600 | ||||||||||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order insolvency:court order replacement/removal of liquidator | 10 Seiten | LIQ MISC OC | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Pricewaterhousecoopersllp Benson House 33 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4JP zum Central Square 8th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL am 14. Okt. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. Mai 2016 | 15 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Insolvenzmeldung INSOLVENCY:secretary of state's release of liquidator | 1 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. Mai 2014 | 8 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 7 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Jessop House 98 Scudamore Road Leicester Leicestershire LE3 1TZ* am 14. Mai 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2012 bis 31. März 2013 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Molyneux als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Hannan als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Sean Emmett als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Chris Yates als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Joanna Boydell als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CAMERA EQUITY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOYDELL, Joanna | Geschäftsführer | 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square 8th Floor | United Kingdom | British | 164373820001 | |||||
| EMMETT, Sean Robert | Geschäftsführer | 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square 8th Floor | United Kingdom | British | 152701300001 | |||||
| YATES, Chris Paul | Geschäftsführer | 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square 8th Floor | England | British | 152699330001 | |||||
| CRABTREE, John Nigel | Sekretär | 37 Redlake Drive Pedmore DY9 0RX Stourbridge West Midlands | British | 48224770001 | ||||||
| GEARY, Robert Alan | Sekretär | 2 Hilders Road LE3 6HD Leicester Leicestershire | British | 11918210001 | ||||||
| MOLYNEUX, Nicholas John | Sekretär | 168 Kenrick Road Mapperley NG3 6EX Nottingham Nottinghamshire | British | 93529300001 | ||||||
| INGLEBY NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007860001 | |||||||
| BROOKES, Timothy Alastair Edward | Geschäftsführer | Holt WR6 6TX Worcester Bentley Court Worcestershire England | England | English | 36187190004 | |||||
| CASHMAN, David | Geschäftsführer | 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester Jessop House Leicestershire | England | British | 152688720001 | |||||
| CHURCHILL, Roger | Geschäftsführer | 61 Sapcote Road Burbage LE10 2AS Hinckley Leicestershire | British | 48957720002 | ||||||
| CRABTREE, John Nigel | Geschäftsführer | 37 Redlake Drive Pedmore DY9 0RX Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | 48224770001 | |||||
| GEARY, Robert Alan | Geschäftsführer | 2 Hilders Road LE3 6HD Leicester Leicestershire | United Kingdom | British | 11918210001 | |||||
| GIDDINGS, Michael John | Geschäftsführer | 3 Nailsworth Road Dorridge B93 8NS Solihull West Midlands | British | 105128310002 | ||||||
| HANNAN, Andrew | Geschäftsführer | 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester Jessop House Leicestershire | England | British | 153976980001 | |||||
| HANNAN, Andrew | Geschäftsführer | Googly Grange Main Street Mowsley LE17 6NT Leicester Leicestershire | England | British | 153976980001 | |||||
| HARRIS, Ian Michael Brian | Geschäftsführer | Meadowsteep Berry Lane WD3 5EY Chorleywood Hertfordshire | United Kingdom | British | 116885790001 | |||||
| HINE, Derek Leslie | Geschäftsführer | Red Lion Witley Road Holt Heath WR6 6LX Worcester | United Kingdom | British | 61935280001 | |||||
| HUGHES, Jonathan Raoul | Geschäftsführer | 4 Sudbrooke Road SW12 8TG London | British | 61123800001 | ||||||
| HUGHES, Jonathan Raoul | Geschäftsführer | 4 Sudbrooke Road SW12 8TG London | British | 61123800001 | ||||||
| ISAACS, Paul | Geschäftsführer | 136 Mill Lane B93 8NZ Bentley Heath West Midlands | British | 84187490001 | ||||||
| MASON, James Christopher | Geschäftsführer | 1 The Croft Kirby Muxloe LE9 2AR Leicester | British | 48964800001 | ||||||
| MAXWELL STEWART, Alasdair | Geschäftsführer | Keepers Cottage Haynes Green Doddenham WR6 5NX Broadwas On Teme Worcestershire | British | 124662440001 | ||||||
| REDPATH, James | Geschäftsführer | 16 Bosworth Way NG10 1EA Long Eaton Nottinghamshire | England | British | 123915050001 | |||||
| REYNOLDS, Kevin Paul | Geschäftsführer | 19 York Street Harborne B17 0HG Birmingham West Midlands | British | 101625190001 | ||||||
| ROLLASON, William Peter | Geschäftsführer | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester | United Kingdom | British | 67354680003 | |||||
| SAMWELL, Peter John | Geschäftsführer | Barnfield House Buttersend Lane Hartpury GL19 3DD Gloucester | British | 71645510001 | ||||||
| SCOTT, Julia Clare | Geschäftsführer | 1 Blackthorn Road Glenfield LE3 8QP Leicester | British | 48964840001 | ||||||
| TUCKER, David John | Geschäftsführer | Alveston House Alveston CV37 7QL Stratford-Upon-Avon Warwickshire | England | British | 35555350001 | |||||
| TUPPEN, Graham Edward | Geschäftsführer | Kingswood House Pittville Circus Road GL52 2PZ Cheltenham Gloucestershire | British | 9549960002 | ||||||
| WHITE, Geoffrey Charles | Geschäftsführer | 8 Rawlings Street SW3 2LS London | British | 86433340001 | ||||||
| WILDE, Theresa Maria | Geschäftsführer | 1 The Woodlands Countesthorpe LE8 5RU Leicester Leicestershire | British | 76029620001 | ||||||
| INGLEBY HOLDINGS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007850001 |
Hat CAMERA EQUITY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite debenture | Erstellt am 29. Sept. 2009 Geliefert am 06. Okt. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 29. Sept. 2009 Geliefert am 02. Okt. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 30. Aug. 2007 Geliefert am 17. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land investments equipment book debts credit balanaces intellectual property rights goodwill uncalled capital authorisations in surances and other assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third party charge over shares | Erstellt am 30. Aug. 2007 Geliefert am 11. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the jessop group limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares the distribution rights from time to time and all interest in the secured proeprty. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A supplemental deed | Erstellt am 07. Juni 2007 Geliefert am 13. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from jessops PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Apr. 2007 Geliefert am 19. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and jessops PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Sept. 2002 Geliefert am 01. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of shares | Erstellt am 10. März 2000 Geliefert am 22. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 2,080,000 ordinary shares of £1 each and 1,520,000 deferred shares of £1 each in techno holdings limited together with all dividends. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Juli 1998 Geliefert am 28. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Juli 1998 Geliefert am 28. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of life policy | Erstellt am 24. Juli 1996 Geliefert am 25. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage | |
Kurze Angaben All that policy of insurance dated 24 july 1996 issued by guardian royal exchange insurance assurance (policy number L0104693959) for the assured sum of £1,000,000 and all money payable under the policy. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 24. Juli 1996 Geliefert am 25. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of life policy | Erstellt am 24. Juli 1996 Geliefert am 25. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that policy of insurance dated 24 july 1996 policy number LO1O4693959 for the assured sum of £1,000,000 (exclusive of bonus). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 24. Juli 1996 Geliefert am 25. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CAMERA EQUITY LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0