CAMERA EQUITY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCAMERA EQUITY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03155952
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CAMERA EQUITY LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich CAMERA EQUITY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Central Square 8th Floor
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CAMERA EQUITY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    JESSOPS LIMITED12. Sept. 200212. Sept. 2002
    JESSOPS PUBLIC LIMITED COMPANY05. Mai 199805. Mai 1998
    JESSOP INTERNATIONAL LIMITED05. Juli 199605. Juli 1996
    INGLEBY (874) LIMITED06. Feb. 199606. Feb. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CAMERA EQUITY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für CAMERA EQUITY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    18 SeitenLIQ14

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:secretary of state certificate of release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:court order replacement/removal of liquidator
    10 SeitenLIQ MISC OC

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Pricewaterhousecoopersllp Benson House 33 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4JP zum Central Square 8th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL am 14. Okt. 2016

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. Mai 2016

    15 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    INSOLVENCY:secretary of state's release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. Mai 2014

    8 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    7 Seiten4.20

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Jessop House 98 Scudamore Road Leicester Leicestershire LE3 1TZ* am 14. Mai 2013

    2 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. März 2013

    Kapitalaufstellung am 07. März 2013

    • Kapital: GBP 15,686,679.1
    SH01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2012 bis 31. März 2013

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    7 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Molyneux als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Hannan als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Sean Emmett als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Chris Yates als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Ms Joanna Boydell als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    13 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von CAMERA EQUITY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BOYDELL, Joanna
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    United KingdomBritish164373820001
    EMMETT, Sean Robert
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    United KingdomBritish152701300001
    YATES, Chris Paul
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 8th Floor
    EnglandBritish152699330001
    CRABTREE, John Nigel
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    Sekretär
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    British48224770001
    GEARY, Robert Alan
    2 Hilders Road
    LE3 6HD Leicester
    Leicestershire
    Sekretär
    2 Hilders Road
    LE3 6HD Leicester
    Leicestershire
    British11918210001
    MOLYNEUX, Nicholas John
    168 Kenrick Road
    Mapperley
    NG3 6EX Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    168 Kenrick Road
    Mapperley
    NG3 6EX Nottingham
    Nottinghamshire
    British93529300001
    INGLEBY NOMINEES LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Bevollmächtigter Sekretär
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007860001
    BROOKES, Timothy Alastair Edward
    Holt
    WR6 6TX Worcester
    Bentley Court
    Worcestershire
    England
    Geschäftsführer
    Holt
    WR6 6TX Worcester
    Bentley Court
    Worcestershire
    England
    EnglandEnglish36187190004
    CASHMAN, David
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Jessop House
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Jessop House
    Leicestershire
    EnglandBritish152688720001
    CHURCHILL, Roger
    61 Sapcote Road
    Burbage
    LE10 2AS Hinckley
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    61 Sapcote Road
    Burbage
    LE10 2AS Hinckley
    Leicestershire
    British48957720002
    CRABTREE, John Nigel
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    Geschäftsführer
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritish48224770001
    GEARY, Robert Alan
    2 Hilders Road
    LE3 6HD Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    2 Hilders Road
    LE3 6HD Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritish11918210001
    GIDDINGS, Michael John
    3 Nailsworth Road
    Dorridge
    B93 8NS Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    3 Nailsworth Road
    Dorridge
    B93 8NS Solihull
    West Midlands
    British105128310002
    HANNAN, Andrew
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Jessop House
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Jessop House
    Leicestershire
    EnglandBritish153976980001
    HANNAN, Andrew
    Googly Grange
    Main Street Mowsley
    LE17 6NT Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Googly Grange
    Main Street Mowsley
    LE17 6NT Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish153976980001
    HARRIS, Ian Michael Brian
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritish116885790001
    HINE, Derek Leslie
    Red Lion Witley Road
    Holt Heath
    WR6 6LX Worcester
    Geschäftsführer
    Red Lion Witley Road
    Holt Heath
    WR6 6LX Worcester
    United KingdomBritish61935280001
    HUGHES, Jonathan Raoul
    4 Sudbrooke Road
    SW12 8TG London
    Geschäftsführer
    4 Sudbrooke Road
    SW12 8TG London
    British61123800001
    HUGHES, Jonathan Raoul
    4 Sudbrooke Road
    SW12 8TG London
    Geschäftsführer
    4 Sudbrooke Road
    SW12 8TG London
    British61123800001
    ISAACS, Paul
    136 Mill Lane
    B93 8NZ Bentley Heath
    West Midlands
    Geschäftsführer
    136 Mill Lane
    B93 8NZ Bentley Heath
    West Midlands
    British84187490001
    MASON, James Christopher
    1 The Croft
    Kirby Muxloe
    LE9 2AR Leicester
    Geschäftsführer
    1 The Croft
    Kirby Muxloe
    LE9 2AR Leicester
    British48964800001
    MAXWELL STEWART, Alasdair
    Keepers Cottage
    Haynes Green Doddenham
    WR6 5NX Broadwas On Teme
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Keepers Cottage
    Haynes Green Doddenham
    WR6 5NX Broadwas On Teme
    Worcestershire
    British124662440001
    REDPATH, James
    16 Bosworth Way
    NG10 1EA Long Eaton
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    16 Bosworth Way
    NG10 1EA Long Eaton
    Nottinghamshire
    EnglandBritish123915050001
    REYNOLDS, Kevin Paul
    19 York Street
    Harborne
    B17 0HG Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    19 York Street
    Harborne
    B17 0HG Birmingham
    West Midlands
    British101625190001
    ROLLASON, William Peter
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Geschäftsführer
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    United KingdomBritish67354680003
    SAMWELL, Peter John
    Barnfield House Buttersend Lane
    Hartpury
    GL19 3DD Gloucester
    Geschäftsführer
    Barnfield House Buttersend Lane
    Hartpury
    GL19 3DD Gloucester
    British71645510001
    SCOTT, Julia Clare
    1 Blackthorn Road
    Glenfield
    LE3 8QP Leicester
    Geschäftsführer
    1 Blackthorn Road
    Glenfield
    LE3 8QP Leicester
    British48964840001
    TUCKER, David John
    Alveston House
    Alveston
    CV37 7QL Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Alveston House
    Alveston
    CV37 7QL Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    EnglandBritish35555350001
    TUPPEN, Graham Edward
    Kingswood House
    Pittville Circus Road
    GL52 2PZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Kingswood House
    Pittville Circus Road
    GL52 2PZ Cheltenham
    Gloucestershire
    British9549960002
    WHITE, Geoffrey Charles
    8 Rawlings Street
    SW3 2LS London
    Geschäftsführer
    8 Rawlings Street
    SW3 2LS London
    British86433340001
    WILDE, Theresa Maria
    1 The Woodlands
    Countesthorpe
    LE8 5RU Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    1 The Woodlands
    Countesthorpe
    LE8 5RU Leicester
    Leicestershire
    British76029620001
    INGLEBY HOLDINGS LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007850001

    Hat CAMERA EQUITY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite debenture
    Erstellt am 29. Sept. 2009
    Geliefert am 06. Okt. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 29. Sept. 2009
    Geliefert am 02. Okt. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Composite debenture
    Erstellt am 30. Aug. 2007
    Geliefert am 17. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land investments equipment book debts credit balanaces intellectual property rights goodwill uncalled capital authorisations in surances and other assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 17. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Third party charge over shares
    Erstellt am 30. Aug. 2007
    Geliefert am 11. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the jessop group limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares the distribution rights from time to time and all interest in the secured proeprty. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paul Colin Weston Nicholas John Molyneux Yasmin Teja and James Graham Being the Trustees of Thejessop Group Limited Pension and Life Assurancescheme (1993)
    Transaktionen
    • 11. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A supplemental deed
    Erstellt am 07. Juni 2007
    Geliefert am 13. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from jessops PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 11. Apr. 2007
    Geliefert am 19. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and jessops PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 13. Sept. 2002
    Geliefert am 01. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Investment Bank PLC as Security Trusee (As Defined Therein)
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 10. März 2000
    Geliefert am 22. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2,080,000 ordinary shares of £1 each and 1,520,000 deferred shares of £1 each in techno holdings limited together with all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Juli 1998
    Geliefert am 28. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Juli 1998
    Geliefert am 28. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Investment Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Apr. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of life policy
    Erstellt am 24. Juli 1996
    Geliefert am 25. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage
    Kurze Angaben
    All that policy of insurance dated 24 july 1996 issued by guardian royal exchange insurance assurance (policy number L0104693959) for the assured sum of £1,000,000 and all money payable under the policy. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 24. Juli 1996
    Geliefert am 25. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of life policy
    Erstellt am 24. Juli 1996
    Geliefert am 25. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that policy of insurance dated 24 july 1996 policy number LO1O4693959 for the assured sum of £1,000,000 (exclusive of bonus).
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Investment Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Apr. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 24. Juli 1996
    Geliefert am 25. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Investment Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Apr. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CAMERA EQUITY LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    24. Mai 2013Beginn der Liquidation
    11. Nov. 2017Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Robert Jonathan Hunt
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Edward Williams
    Donington Court Pegasus Business Park
    DE74 2UZ Castle Donington
    East Midlands
    Praktiker
    Donington Court Pegasus Business Park
    DE74 2UZ Castle Donington
    East Midlands
    Anthony Steven Barrell
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0