SOUTHERN CROSS HEALTHCARE SERVICES LIMITED

SOUTHERN CROSS HEALTHCARE SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSOUTHERN CROSS HEALTHCARE SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03156327
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SOUTHERN CROSS HEALTHCARE SERVICES LIMITED?

    • Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich SOUTHERN CROSS HEALTHCARE SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Fifth Floor
    100 Wood Street
    EC2V 7EX London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SOUTHERN CROSS HEALTHCARE SERVICES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LEGISLATOR 1270 LIMITED07. Feb. 199607. Feb. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SOUTHERN CROSS HEALTHCARE SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2010

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SOUTHERN CROSS HEALTHCARE SERVICES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für SOUTHERN CROSS HEALTHCARE SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 31. Mai 2016

    23 Seiten1.3

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    20 Seiten1.4

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 20 North Audley Street London W1K 6WE United Kingdom zum Fifth Floor 100 Wood Street London EC2V 7EX am 29. Apr. 2016

    2 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 04. Apr. 2016

    2 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 19. Juni 2015

    23 Seiten1.3

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 19. Juni 2014

    21 Seiten1.3

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 19. Juni 2013

    25 Seiten1.3

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Southgate House, Archer Street Darlington County Durham DL3 6AH* am 09. Okt. 2012

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr David Charles Lovett als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Timothy Bolot als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Francis Mccormack als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs

    4 Seiten1.1

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Feb. 2012

    Kapitalaufstellung am 10. Feb. 2012

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Beendigung der Bestellung von David Smith als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor

    2 SeitenAP01

    legacy

    5 SeitenMG01

    Ernennung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    27 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von SOUTHERN CROSS HEALTHCARE SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LOVETT, David Charles
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    Geschäftsführer
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    United KingdomBritishDirector34419700002
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    100 Wood Street
    EC2V 7EX London
    Fifth Floor
    Geschäftsführer
    100 Wood Street
    EC2V 7EX London
    Fifth Floor
    United KingdomBritishDirector163496070001
    GREEN, Gillian Leigh
    72 Bexley Street
    SL4 5BX Windsor
    Berkshire
    Sekretär
    72 Bexley Street
    SL4 5BX Windsor
    Berkshire
    British14181190001
    MARK, Athanasia
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    Sekretär
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    BritishCompany Secretary44960510001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158305940001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    O`REILLY, John
    35a Court Farm Road
    UB5 5HQ Northolt
    Middlesex
    Sekretär
    35a Court Farm Road
    UB5 5HQ Northolt
    Middlesex
    BritishFinancial Controller48337750001
    POOLEY, Maureen
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    Sekretär
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    EnglishCorporate Controller51896650001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Sekretär
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    BritishDirector103588940001
    STEVEN, Kenneth
    72 Fountain Gardens
    SL4 3SX Windsor
    Berkshire
    Sekretär
    72 Fountain Gardens
    SL4 3SX Windsor
    Berkshire
    BritishAccountant64425700001
    ARTHUR, Kevin Mccabe
    The Landings
    Beningbrough
    YO30 1BY York
    Geschäftsführer
    The Landings
    Beningbrough
    YO30 1BY York
    BritishAccountant51886750002
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector107837080002
    BUCHAN, William James
    North Audley Street
    W1K 6WE London
    20
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    North Audley Street
    W1K 6WE London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritishDirector51697890003
    FARMER, Nicholas John
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector124228290001
    FARMER, Nicholas John
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector124228290001
    FEARN, Lynn
    Elmwood Drive
    DE55 7QJ Alfreton
    24
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Elmwood Drive
    DE55 7QJ Alfreton
    24
    Derbyshire
    United KingdomBritishDirector130867640001
    FINNIS, Pam
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector133719530001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishManaging Director111188390002
    GEE, Andrew Anthony Edward
    83a Sutherland Avenue
    TN16 3HG Biggin Hill
    Kent
    Geschäftsführer
    83a Sutherland Avenue
    TN16 3HG Biggin Hill
    Kent
    EnglandBritishDirector93592160001
    HEAPS, Ann
    8 Oakwood Close
    BL8 1DD Bury
    Lancashire
    Geschäftsführer
    8 Oakwood Close
    BL8 1DD Bury
    Lancashire
    BritishDirector124068050001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Geschäftsführer
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritishDirector144822040001
    MACINTOSH, Michael
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector137864880001
    MALHAM, Janette
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishManaging Director91088900004
    MARK, Larry Edward
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    Geschäftsführer
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    New ZealanderCompany Director5076900001
    MARSHALL, Diana Jane
    9 The Elms
    St Faiths Road, Old Catton
    NR6 7BP Norwich
    Geschäftsführer
    9 The Elms
    St Faiths Road, Old Catton
    NR6 7BP Norwich
    BritishSolicitor47799990002
    MCKEEVER, Pauline Ann
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    Geschäftsführer
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    BritainBritishManaging Director91521130001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritishDirector110640170001
    MORETON, John Ernest
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    New ZealanderCheif Executive80392940001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Geschäftsführer
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritishDirector26177180004
    MURRAY, Andrew John
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    BritishManaging Director110957990001
    POOLEY, Maureen
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    EnglandEnglishCorporate Controller51896650001
    POYNTON, Ellen
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    Geschäftsführer
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    United KingdomBritishManaging Director89071020004
    PRESTON, Mary
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector124068010001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Geschäftsführer
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    BritishDirector103588940001

    Hat SOUTHERN CROSS HEALTHCARE SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge over account
    Erstellt am 30. Sept. 2011
    Geliefert am 20. Okt. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company not exceeding £4,125,000 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all right title and interest in and to the deposit being all sums standing to the credit of the account constituting the secured asset from time to time. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • SC Trustco Limited (As the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 30. Nov. 2001
    Geliefert am 05. Dez. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all right title estate and other interests in l/h premises situate at lyndon hall nursing home, malvern close, all saints way, west bromwich, B71 1PP.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 05. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 30. Nov. 2001
    Geliefert am 05. Dez. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 9 june 1998
    Kurze Angaben
    The initial deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 05. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of substituted security
    Erstellt am 27. Nov. 2001
    Geliefert am 29. Nov. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right title estate and other interests of the company in leasehold premises at oaklands nursing and residential home,forest glade,dunton hills,laindon,essex SS16 6SA; fixed charge over all right title estate and other interests in each of the properties as described in the mortgage debenture; the goodwill of business and uncalled capital; floating charge over. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Care Homes No.1 Limited
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 28. Sept. 2001
    Geliefert am 13. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 9 june 1998
    Kurze Angaben
    The initial deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 28. Sept. 2001
    Geliefert am 12. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 9 june 1998
    Kurze Angaben
    The intial deposit all interest the deposit account and the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    Transaktionen
    • 12. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 28. Sept. 2001
    Geliefert am 12. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The initial deposit all interest the deposit account and the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 12. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 28. Sept. 2001
    Geliefert am 11. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The initial deposit; all interest; the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transaktionen
    • 11. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 28. Sept. 2001
    Geliefert am 11. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The initial deposit; all interest; the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.12 Limited
    Transaktionen
    • 11. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 28. Sept. 2001
    Geliefert am 11. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The initial deposit; all interest; the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.8 Limited
    Transaktionen
    • 11. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 28. Sept. 2001
    Geliefert am 11. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The initial deposit; all interest; the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.8 Limited
    Transaktionen
    • 11. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 28. Sept. 2001
    Geliefert am 11. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The initial deposit; all interest; the deposit account; and the deposit abalance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 11. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. Sept. 2001
    Geliefert am 04. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the l/h premises at oaklands nursing home hexham street bishop auckland county durham DL14 7PU. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.12 Limited
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. Sept. 2001
    Geliefert am 04. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all right title estate and other interests in l/h premises situate at washington lodge nursing home, the avenue, washington village, washington, tyne & wear, NE38 7LE together with all buildings structures fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings but excluding landlord's fixtures) and fixed plant and machinery. By way of fixed charge all right title estate and other interests in each of the properties not effectively mortgaged above all equipment plant and machinery, intellectual property, goodwill and uncalled capital and debts. By way of floating charge all undertaking and all the assets, rights and income present and future not otherwise effectively mortgaged or charged by the mortgage debenture.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 10 Limited (Nhps)
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. Sept. 2001
    Geliefert am 04. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a avalon park nursing home dove street salem oldham greater manchester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 8 Limited
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. Sept. 2001
    Geliefert am 04. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a kings park nursing home kings road hurst cross ashton-under-lyne greater manchester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 8 Limited
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. Sept. 2001
    Geliefert am 04. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a brandon house nursing home 140 church road bell green coventry. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. Sept. 2001
    Geliefert am 04. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a pendle nursing and rsidential home scholl street radcliffe manchester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. Sept. 2001
    Geliefert am 04. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a clarendon hall nursing and residential home 19 church avenue humberstone gt grimsby. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. Sept. 2001
    Geliefert am 04. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a snapethorpe nursing home snapethorpe gate snapethorpe wakefield. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 01. Aug. 2001
    Geliefert am 04. Aug. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H northmoor nursing home elgar street longsight manchester M8 8XG together with all buildings structures fixtures and fittings fixed plant and machinery and a fixed and floating charge over all undertaking property and assets including goodwill uncalled capital intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 01. Aug. 2001
    Geliefert am 04. Aug. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H barton house nursing home 23-29 marsh road luton LU3 2QF together with all buildings structures fixtures and fittings fixed plant and machinery and a fixed and floating charge over all undertaking property and assets including goodwill uncalled capital intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 01. Aug. 2001
    Geliefert am 04. Aug. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H ascot nursing home 48A newlands road intake sheffield south yorkshire S12 2FZ together with all buildings structures fixtures and fittings fixed plant and machinery and a fixed and floating charge over all undertaking property and assets including goodwill uncalled capital intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 01. Aug. 2001
    Geliefert am 04. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right title estate and other interests of the company in l/h property in st helen's nursing home 6 manor road bishop auckland county durham DL1 9DL. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 01. Aug. 2001
    Geliefert am 04. Aug. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right title estate and other interests of the company in l/h property at trafalgar house nursing home 290 wilbraham road manchester M16 8LT. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)

    Hat SOUTHERN CROSS HEALTHCARE SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Juni 2012Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    31. Mai 2016Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Howard Smith
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    Praktiker
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0