BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03156768 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o BRUNTWOOD LIMITED York House York Street M2 3BB Manchester England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
SLATERSHELFCO 312 LIMITED | 08. Feb. 1996 | 08. Feb. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Bruntwood Limited City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT zum C/O Bruntwood Limited York House York Street Manchester M2 3BB am 07. Juni 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Kevin James Crotty am 28. Juni 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Kevin James Crotty als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Allan als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT United Kingdom* am 21. Dez. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Yates als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Malin als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Iain Grant als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BD* am 10. März 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKES, Katharine Jane | Sekretär | c/o Bruntwood Limited York Street M2 3BB Manchester York House England | British | Company Director | 96739300002 | |||||
CROTTY, Kevin James | Geschäftsführer | c/o Bruntwood Limited York Street M2 3BB Manchester York House England | England | British | Chartered Accountant | 117797270004 | ||||
OGLESBY, Christopher George | Geschäftsführer | c/o Bruntwood Limited York Street M2 3BB Manchester York House England | United Kingdom | British | Company Director | 53530470002 | ||||
OGLESBY, Michael John | Geschäftsführer | c/o Bruntwood Limited York Street M2 3BB Manchester York House England | United Kingdom | British | Company Director | 148307320001 | ||||
GREENWOOD, Clive Norman Kristian | Sekretär | Meadows Farm SK12 7EH Kettleshulme Cheshire | British | 2582690002 | ||||||
ORRELL, Jeremy Peter | Bevollmächtigter Sekretär | 2 Greylands Close M33 6GS Sale Cheshire | British | 900005190001 | ||||||
ALLAN, Andrew John | Geschäftsführer | c/o Bruntwood Limited Piccadilly Plaza M1 4BT Manchester City Tower United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 80043450001 | ||||
DUNN, Christopher Frank | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 4 Ashcroft Close SK9 1RB Wilmslow Cheshire | British | 900005180001 | ||||||
GRANT, Iain James | Geschäftsführer | Piccadilly Plaza M1 4BT Manchester City Tower United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 45918940003 | ||||
GREENWOOD, Clive Norman Kristian | Geschäftsführer | Meadows Farm SK12 7EH Kettleshulme Cheshire | United Kingdom | British | Accountant | 2582690002 | ||||
MALIN, Richard William | Geschäftsführer | Piccadilly Plaza M1 4BT Manchester City Tower United Kingdom | United Kingdom | British | Banker | 48153170001 | ||||
OGLESBY, Jean Davies | Geschäftsführer | Moss Farm Southdowns Road Bowdon WA14 3DR Altrincham Cheshire | England | British | Company Director | 29553390001 | ||||
ORRELL, Jeremy Peter | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 2 Greylands Close M33 6GS Sale Cheshire | British | 900005190001 | ||||||
YATES, Robert David | Geschäftsführer | Piccadilly Plaza M1 4BT Manchester City Tower United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 30535590006 |
Hat BRUNTWOOD FIRST PROPERTIES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
B2000 borrower security agreement | Erstellt am 06. Feb. 2007 Geliefert am 20. Feb. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 06. Dez. 2001 Geliefert am 18. Dez. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee and/or the banks and each of them whether actually or contingently and whether solely or jointly with any other or others in partnership or otherwise or in any other manner whatsoever and also all monies and liabilities which shall for the time being be due or to become due from bruntwood estates limited and/or bruntwood 2000 first properties limited to the chargee and/or the banks and each of them whether actually or contingently and whether solely or jointly with any other or others in partnership and on any account or in any other manner whatsoever | |
Kurze Angaben The property being freehold property known as fanum house (now known as landmark house) station road cheadle hulme stockport greater manchester title number GM76157 leasehold property known as land being part of fanum house (now known as landmark house) title number GM682291 for further details of the property please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of supplemental charge | Erstellt am 02. Feb. 2000 Geliefert am 18. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag (A) all monies and liabilties due or to become due from the company to lloyds tsb bank PLC, capital markets (the "agent") and/or the banks and each of them on any account whatsoever and (b) the third party liabilities (as defined) | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage l/h land k/a north tower (formerly k/a highland house) victoria bridge street and 19 chapel street salford greater manchester. By way of first fixed charge all plant machinery implements building materials furniture and equipment; by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils building materials furniture and equipment.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Sept. 1996 Geliefert am 30. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of a credit agreement dated 20/9/96 and the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 31. Mai 1996 Geliefert am 13. Juni 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fanum house station road cheadle hulme greater manchester t/no GM676157 and GM682291 with the goodwill of the business and. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 31. Mai 1996 Geliefert am 06. Juni 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £262,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the legal charge | |
Kurze Angaben Fanum house, station road, cheadle hume, greater manchester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 29. Mai 1996 Geliefert am 04. Juni 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fittings fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0