TONSTATE GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTONSTATE GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03162082
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TONSTATE GROUP LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich TONSTATE GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TONSTATE GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TONSTATE LIMITED21. Feb. 199621. Feb. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TONSTATE GROUP LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am28. Sept. 2020
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am28. Sept. 2021
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2019

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für TONSTATE GROUP LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis12. Juni 2022
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung26. Juni 2022
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis12. Juni 2021
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für TONSTATE GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Okt. 2025

    15 SeitenLIQ03

    Beendigung der Bestellung von Arthur Matyas als Geschäftsführer am 06. Juli 2024

    1 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Okt. 2024

    16 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Okt. 2023

    14 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Okt. 2022

    18 SeitenLIQ03

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 26. Okt. 2021

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3 Park Place St James London SW1A 1LP zum 82 st John Street London EC1M 4JN am 10. Nov. 2021

    2 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. Juni 2021 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2019

    13 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. Juni 2020 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Change of details for Arthur Matyas as a person with significant control on 04. Juni 2020

    2 SeitenPSC04

    Cessation of Edward Oded Wojakovski as a person with significant control on 04. Juni 2020

    1 SeitenPSC07

    Notification of Renate Matyas as a person with significant control on 04. Juni 2020

    2 SeitenPSC01

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2018

    15 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2017

    15 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Edward Oded Wojakovski als Sekretär am 14. Mai 2019

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Edward Oded Wojakovski als Geschäftsführer am 09. Mai 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mrs Miriam Michelle Evens als Direktor am 04. Dez. 2018

    2 SeitenAP01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 29. Sept. 2017 bis 28. Sept. 2017

    1 SeitenAA01

    Wer sind die Geschäftsführer von TONSTATE GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    EVENS, Miriam Michelle
    Park Place
    SW1A 1LP London
    3
    England
    Geschäftsführer
    Park Place
    SW1A 1LP London
    3
    England
    IsraelBritish254913980001
    MATYAS, Renate
    Park Place
    St James's
    SW1A 1LP London
    3
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Park Place
    St James's
    SW1A 1LP London
    3
    United Kingdom
    United KingdomDutch4266800001
    WOJAKOVSKI, Edward Oded, Dr
    3 Park Place
    St. James`S
    SW1A 1LP London
    Sekretär
    3 Park Place
    St. James`S
    SW1A 1LP London
    British114629300001
    NOTEHOLD LIMITED
    6 Stoke Newington Road
    N16 7XN London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6 Stoke Newington Road
    N16 7XN London
    900002210001
    MATYAS, Arthur
    Park Place
    St James's
    SW1A 1LP London
    3
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Park Place
    St James's
    SW1A 1LP London
    3
    United Kingdom
    United KingdomBritish,36810610001
    ROBERTSON, Ian
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish106197810002
    ROBERTSON, Rachel Elizabeth
    Park Place
    SW1A 1LP London
    3
    Geschäftsführer
    Park Place
    SW1A 1LP London
    3
    EnglandBritish96527400001
    SMITH, Norman Alan
    Park Place
    St James's
    SW1A 1LP London
    3
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Park Place
    St James's
    SW1A 1LP London
    3
    United Kingdom
    ScotlandBritish156114890003
    WOJAKOVSKI, Edward Oded, Dr
    3 Park Place
    St. James`S
    SW1A 1LP London
    Geschäftsführer
    3 Park Place
    St. James`S
    SW1A 1LP London
    EnglandBritish114629300001
    NOTEHURST LIMITED
    6 Stoke Newington Road
    N16 7XN London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6 Stoke Newington Road
    N16 7XN London
    900002200001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TONSTATE GROUP LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mrs Renate Matyas
    Cornwall Avenue
    St Jamess
    N3 1LF London
    Aston House
    United Kingdom
    04. Juni 2020
    Cornwall Avenue
    St Jamess
    N3 1LF London
    Aston House
    United Kingdom
    Nein
    Nationalität: Dutch
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.
    Dr Edward Oded Wojakovski
    Park Place
    St James's
    SW1A 1LP London
    3
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Park Place
    St James's
    SW1A 1LP London
    3
    United Kingdom
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    Arthur Matyas
    Park Place
    St James's
    SW1A 1LP London
    3
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Park Place
    St James's
    SW1A 1LP London
    3
    United Kingdom
    Nein
    Nationalität: British,
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat TONSTATE GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 28. Mai 2014
    Geliefert am 12. Juni 2014
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Venn Capital S.A.R.L.
    Transaktionen
    • 12. Juni 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 10. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Apr. 2011
    Geliefert am 28. Apr. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    21/33 odd numbers inclusive stonehills and 5/59 odd numbers inclusive howardsgate welwyn garden city hertfordshire t/no HD216723 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Okt. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over account
    Erstellt am 10. Juli 2007
    Geliefert am 20. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from an obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit account being the deposit account number 06115730, sort code 80-20-00, the deposit and all interest that may from time to time be payable on the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, as Agent and Security Trustee for Each of Thefinance Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Sept. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee incorporating a pledge
    Erstellt am 22. Jan. 2004
    Geliefert am 28. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from mm&s (3020) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company's right title and interest in and to the pledged sum of £1,799,999 together with all interest accrued thereon from time to time.
    Berechtigte Personen
    • Pillar Projects Limited
    Transaktionen
    • 28. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Mai 2003
    Geliefert am 04. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as 113-117 (odd) farringdon road london EC1 title number 333437. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Sept. 2000
    Geliefert am 29. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    21/23 stonehills house stonehill and 51/59 howardsgate welwyn garden city. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A standard security dated 06/09/00 which was presented for registration in scotland on 13/09/00
    Erstellt am 13. Sept. 2000
    Geliefert am 27. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by any group member to the trustee or any lender of for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lender whether present or future actual or contingent on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 35,37 and 39 st vincent place glasgow G1 2ER t/n GLA41114 and all buildings erections and fixtures and fittings.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited (The Trustee)
    Transaktionen
    • 27. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of rents
    Erstellt am 08. Sept. 2000
    Geliefert am 20. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group member to the chargee as trustee for itself and the other lenders on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the rights titles benefits and interests of the company to the rents including the right to receive the same and the full benefit of any guarantee or security together with all claims actions and damages arising in connection therewith. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of rent
    Erstellt am 07. Juli 2000
    Geliefert am 11. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due owing or incurred by any group member to any lender or for or in respect of which any group member may be liable to any lender on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right title benefit and interest present or future to the rents including the right to recieve the same and the full benefit of any guarantee or security for the performance thereof together with all claims actions and damages arising in connection therewith and any proceeds of the foregoing.
    Berechtigte Personen
    • )
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited as Trustee for Itself and the Other Lenders from Time to Time (The Trustee)
    Transaktionen
    • 11. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 3 july 2000
    Erstellt am 03. Juli 2000
    Geliefert am 11. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due owing or incurred by any group member to the trustee or any lender or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lender on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 9 and 11 ferniehill drive gilmerton edinburgh.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited as Trustee for Itself and the Other Lenders from Time to Time (The Trustees)
    Transaktionen
    • 11. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Mai 2000
    Geliefert am 20. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £3,400,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Property k/a 21/23 (odd) stonehills house stonehills and 51/59 howardsgate welwyn garden city. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 20. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Mai 2000
    Geliefert am 16. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a 2-10 (even) high street bognor regis west sussex t/n SK87239. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Mai 2000
    Geliefert am 16. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a land and buildings on the south east side of lodge way northampton northamptonshire t/n NN189180. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Second legal charge
    Erstellt am 20. Jan. 2000
    Geliefert am 03. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge
    Kurze Angaben
    F/H shaftesbury house 402 high street west bromwich t/no.SF39209.
    Berechtigte Personen
    • Maxima Corporate Holdings Limited
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental deed
    Erstellt am 16. Nov. 1999
    Geliefert am 30. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys and indebtedness due from and all moneys covenanted to be paid by any group member to the chargee as trustee for itself and any other lender supplemental to the legal charge dated 25TH may 1999
    Kurze Angaben
    Freehold land and buildings k/a east side of grimrod place gillibrands skelmersdale lancashire t/n LA774090 and shaftesbury house 402 high street west bromwich in the sandwell west midlands t/n SF39209 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery and all improvements and additions.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 30. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of assignment
    Erstellt am 16. Nov. 1999
    Geliefert am 30. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by tonstate limited limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of tonstate limited limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company (group member) to the chargee as trustee for itself and the other lenders (trustee) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the occupational lease/s in respect of east side of grimrod place gillibrands skelmersdale lancashire t/n LA774090 other than the sums due by way of insurance rent or service charge and any proceeds of the forgoing. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 30. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Okt. 1999
    Geliefert am 04. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a olympia house 2/6 corn street 174/178 dock street and 23/28 skinner street newport t/n WA897444 and the proceeds of sale thereof and allcompensationor grants paid to the company an assignment of such interest in the property that are not capable of being legally charged a floating security over all property and assets now or in the future * see form 395 for further details *.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 04. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Okt. 1999
    Geliefert am 01. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Olympia house,2-6 corn st,174-178 dock street and 23-28 skinner st,newport; wa 897444. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 01. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Nov. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Assignation of rents
    Erstellt am 02. Juni 1999
    Geliefert am 09. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group member to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies due under the leases dated 22 april 1987, 21 june 1988, 5 april 1991, 27 april 1988, and 17 march 1988. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited(The "Trustee")
    Transaktionen
    • 09. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 25. Mai 1999
    Geliefert am 10. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies deposited with the trustee. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited,as Trustee for Itself and the Other Lenders (As Defined)
    Transaktionen
    • 10. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 1 june 1999 and
    Erstellt am 20. Mai 1999
    Geliefert am 09. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group member to the chargee on any acount whatsoever
    Kurze Angaben
    Berkley house 285 bath street glasgow t/n GLA92637 and all buildings and fixtures etc.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited(The "Trustee")
    Transaktionen
    • 09. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Apr. 1999
    Geliefert am 08. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property at 5 and 7 ramsden street huddersfield t/no.WYK610376. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Jan. 1999
    Geliefert am 21. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage f/h 31 oxford row 43, 45 and 47 great george street leeds t/n-WYK606979.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 18. Jan. 1999
    Geliefert am 21. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal mortgage
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage f/h 174 lincoln road peterborough t/n-CB75412. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 21. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment by way of charge
    Erstellt am 28. Sept. 1998
    Geliefert am 16. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of the company and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargees on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rights titles benefits and interest in and to all monies from time to time due owing or incurred to the company under the occupational leases in respect of shaftesbury house 402 high street west bromwich sandwell west midlands other than sums due to the company by way of rent insurance service charge or vat. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited(As Trustee for Itself and the Other Lenders)
    Transaktionen
    • 16. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat TONSTATE GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    26. Okt. 2021Beginn der Liquidation
    26. Okt. 2021Erklärung der Zahlungsfähigkeit geleistet am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Andrew James Pear
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Praktiker
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Michael Stephen Elliot Solomons
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Praktiker
    82 St John Street
    EC1M 4JN London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0