EURAMAX INTERNATIONAL LIMITED

EURAMAX INTERNATIONAL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEURAMAX INTERNATIONAL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03162836
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EURAMAX INTERNATIONAL LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich EURAMAX INTERNATIONAL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Brunel Road
    Earlstrees Industrial Estate
    NN17 4JW Corby
    Northamptonshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EURAMAX INTERNATIONAL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HAWKMIST LIMITED22. Feb. 199622. Feb. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EURAMAX INTERNATIONAL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis25. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für EURAMAX INTERNATIONAL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Feb. 2012

    Kapitalaufstellung am 23. Feb. 2012

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    legacy

    3 SeitenSH20

    legacy

    3 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Kapitalaufstellung am 14. Dez. 2011

    • Kapital: GBP 1.00
    4 SeitenSH19

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2010 bis 30. Juni 2011

    1 SeitenAA01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 25. Dez. 2009

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Dez. 2008

    11 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten403a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Dez. 2007

    13 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Dez. 2006

    12 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von EURAMAX INTERNATIONAL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WADE, Steve
    5 Horrocks Way
    NN15 5DH Kettering
    Northamptonshire
    Sekretär
    5 Horrocks Way
    NN15 5DH Kettering
    Northamptonshire
    British117491680001
    LEWIS, Mitchell B
    Lazy Oaks Court
    GA30350 Atlanta
    8435
    Georgia
    United States Of America
    Geschäftsführer
    Lazy Oaks Court
    GA30350 Atlanta
    8435
    Georgia
    United States Of America
    UsaAmerican135352620001
    SMAILES, Nigel Andrew
    11 Nook Green
    Tingley
    WF3 1ER Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    11 Nook Green
    Tingley
    WF3 1ER Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish16154490003
    VANSANT, Robert Scott
    150 Brightmore Way
    Alpharetta
    FOREIGN Georgia
    30005
    Usa
    Geschäftsführer
    150 Brightmore Way
    Alpharetta
    FOREIGN Georgia
    30005
    Usa
    UsaAmerican92216760001
    PITTENDREIGH, Ian
    5 Stirling Road
    Burley In Wharfedale
    LS29 7LH Ilkley
    West Yorkshire
    Sekretär
    5 Stirling Road
    Burley In Wharfedale
    LS29 7LH Ilkley
    West Yorkshire
    British42432160002
    VANSANT, Scott
    150 Brightmore Way
    Alpharetta
    Ga 30202
    America
    Sekretär
    150 Brightmore Way
    Alpharetta
    Ga 30202
    America
    British50676030001
    WILLIAMS, Paul Frederick
    21 Alvington Way
    LE16 7NF Market Harborough
    Leicestershire
    Sekretär
    21 Alvington Way
    LE16 7NF Market Harborough
    Leicestershire
    British18038590002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    CASHIN, Richard
    10 Gracie Square Aprtment 8g
    New York 10028 New York
    FOREIGN Usa
    Geschäftsführer
    10 Gracie Square Aprtment 8g
    New York 10028 New York
    FOREIGN Usa
    American50225090001
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    COMFORT, William Twyman
    Flat 1
    38 Pont Street
    SW1 London
    Geschäftsführer
    Flat 1
    38 Pont Street
    SW1 London
    British53760460001
    CUYPERS, Jo
    Heerbaan 57
    6061 Ec Posterholt
    31-475-401697
    The Netherlands
    Geschäftsführer
    Heerbaan 57
    6061 Ec Posterholt
    31-475-401697
    The Netherlands
    Dutch77533550001
    DRACK, Paul Edward
    9865 Farmbrook Lane
    30202 Alpharetta
    Georgia
    Usa
    Geschäftsführer
    9865 Farmbrook Lane
    30202 Alpharetta
    Georgia
    Usa
    American52018610002
    PITTENDREIGH, Ian
    5 Stirling Road
    Burley In Wharfedale
    LS29 7LH Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    5 Stirling Road
    Burley In Wharfedale
    LS29 7LH Ilkley
    West Yorkshire
    British42432160002
    PUGH, David Christopher
    16 Henley Close
    Rawdon
    LS19 6QB Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    16 Henley Close
    Rawdon
    LS19 6QB Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish50680510001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SILVESTRI, Joseph
    48 West 68th Street
    Apartment 8c
    10023 New York
    New York
    Usa
    Geschäftsführer
    48 West 68th Street
    Apartment 8c
    10023 New York
    New York
    Usa
    American49636400001
    SMITH, John David
    5130 Riverlake Drive
    Duluth
    Ga 30097
    Usa
    Geschäftsführer
    5130 Riverlake Drive
    Duluth
    Ga 30097
    Usa
    American92216850001
    SMITH, John David
    5130 Riverlake Drive
    Duluth
    Ga 30097
    Usa
    Geschäftsführer
    5130 Riverlake Drive
    Duluth
    Ga 30097
    Usa
    American92216850001
    SMITH, Michael David Cook
    Springwood House The Ridges
    Finchampstead
    RG11 3TA Wokingham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Springwood House The Ridges
    Finchampstead
    RG11 3TA Wokingham
    Berkshire
    British35559630002
    VAN RAPPARD, Rolly
    Zurderende 11
    124344 Graveland
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Zurderende 11
    124344 Graveland
    Netherlands
    Dutch50904200001
    WALLIS, Stuart Michael
    37 Third Floor
    Lombard Street
    EC3V 9BQ London
    Geschäftsführer
    37 Third Floor
    Lombard Street
    EC3V 9BQ London
    United KingdomBritish10075160008
    WALTERS, Roger Anthony
    Woodstock Cottesmore Road
    Ashwell Oakham
    LE15 7LJ Rutland
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Woodstock Cottesmore Road
    Ashwell Oakham
    LE15 7LJ Rutland
    Leicestershire
    United KingdomBritish50421200001
    WILLIAMS, Gerald David John
    1 Mill Close
    Wing
    LE15 8RH Oakham Rutland
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    1 Mill Close
    Wing
    LE15 8RH Oakham Rutland
    Leicestershire
    British50420930001
    WILLIAMS, Paul Frederick
    21 Alvington Way
    LE16 7NF Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    21 Alvington Way
    LE16 7NF Market Harborough
    Leicestershire
    British18038590002

    Hat EURAMAX INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Share pledge agreement
    Erstellt am 29. Juni 2005
    Geliefert am 19. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The financial instruments account credited with 96,029 shares of capital stock. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • General Electric Capital Corporation as Agent on Behalf and for the Benefit of the Secured Parties (The Agent)
    Transaktionen
    • 19. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    First lien debenture
    Erstellt am 29. Juni 2005
    Geliefert am 15. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each credit party to the agents, the lenders or any of them and lender counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • General Electric Capital Corporation as Agent and Trustee for Itself and Each of the Securedcreditors (The Trustee)
    Transaktionen
    • 15. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Third U.K. consent agreement
    Erstellt am 15. März 2002
    Geliefert am 04. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The "secured obligations" meaning the guarantied obligations (as defined) of the company provided that no obligation or liability shall be included in the definition of "secured obligations" to the extent that, if it were so included, the legal mortgage (or any part thereof) would constitute unlawful financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    The mortgaged shares. "Mortgaged shares" means such of the shares (as defined) as are identified in the schedule to this form 395 and such other shares as the company may have transferred or be obliged to the transfer to the mortgagee pursuant to clause 3.2 (subsequently acquired shares) of the legal mortgage....please refer to form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bnp Paribas as Trustee for the Secured Creditors (As Defined)
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Domestic consent agreement between the various parties (as named therein)
    Erstellt am 10. Apr. 2000
    Geliefert am 26. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The full and promt payment when due, of, and the performance of, all of the obligations and all of the guarantied obligations (as defined) of the company under the euromax guaranty and all obligations of any loan party under any currency contract with the currency swap party (each as defined)
    Kurze Angaben
    All rights, title and interest under all contracts and all other claims thereunder and all general intangibles and the proceeds of each of the foregoing. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paribas (As Trustee for the Secured Creditors (as Defined))
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Domestic consent agreement between the various parties (as named therein)
    Erstellt am 10. Apr. 2000
    Geliefert am 26. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The performance of the obligations, the guranteed obligations (as defined) of the company under the euramax guaranty, including without limitation, all obligations of the company under the agreement
    Kurze Angaben
    100 shares of $0.01 each in amerimax holdings inc. And all other shares rights dividends etc in relation thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paribas (As Trustee for the Secured Creditors (as Defined))
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    U.K. consent agreement between euramax international inc., The company, euramax international holdings limited, euramax continental limited, euramax holdings limited, euramax european holdings limited, euramax coated products limited, ellbee limited and paribas
    Erstellt am 10. Apr. 2000
    Geliefert am 26. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the chargee the "secured obligations" meaning the guarantied obligations (as defined) of the company provided that no obligation or liability shall be included in the definition of "secured obligations" to the extent that, if it were so included, the legal mortgage (or any part thereof) would constitute unlawful financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    1. the mortgaged shares. "Mortgaged shares" means such of the shares (as defined) as are identified in the schedule to this form 395 and such other shares as the company may have transferred or be obliged to the transfer to the mortgagee pursuant to clause 3.2 (subsequently acquired shares) of the legal mortgage.... "Shares" means any shares in the capital of the company referred to in the schedule to the form 395 and all dividends interest or other monies paid or payable thereon...". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paribas (As Trustee for the Secured Creditors (as Defined))
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of pledge
    Erstellt am 25. Sept. 1996
    Geliefert am 11. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The pledgor's guaranteed obligations (as defined) due or to become due from the company to the chargee including the pledgor's covenant obligations and the currency obligations (both as defined in the deed)
    Kurze Angaben
    The shares; provided however that only the shares numbered 1 up to and inclusive 26 (being 65% of the shares) shall secure the U.S. revolver liabilities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Banque Paribas
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Sept. 1996
    Geliefert am 10. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "collateral documents"
    Kurze Angaben
    50,000 ordinary shares of and in euromax european holdings PLC and all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Banque Paribas
    Transaktionen
    • 10. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment agreement
    Erstellt am 25. Sept. 1996
    Geliefert am 07. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the euramax guaranty and all obligations of any loan party under any currency contract with the currency swap party (as defined)
    Kurze Angaben
    All rights,title and interest under all contracts and all other claims thereunder for damages. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Banque Paribas,as Trustees for the Secured Creditors (As Defined)
    Transaktionen
    • 07. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Share pledge agreement (as defined)
    Erstellt am 25. Sept. 1996
    Geliefert am 07. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the euramax guaranty or any other collateral document (as defined)
    Kurze Angaben
    2,494 shares of the capital of the company representing 99.76% of the total issued capital stock. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Banque Paribas,as Trustees for the Secured Creditors (As Defined)
    Transaktionen
    • 07. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Euromax stock (U.S.) and debt pledge agreement
    Erstellt am 25. Sept. 1996
    Geliefert am 07. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the euramax guaranty,including all obligations of any loan party under any currency contract
    Kurze Angaben
    All pledged shares,stocks or other securities of U.S.holdings from time to time; the certificates representing the shares and all dividends,cash,interest and other property or proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Banque Paribas,as Trustees for the Secured Creditors (As Defined)
    Transaktionen
    • 07. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0