LASER HOTELS FOUR LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLASER HOTELS FOUR LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03165887
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LASER HOTELS FOUR LIMITED?

    • Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe

    Wo befindet sich LASER HOTELS FOUR LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o HUDSON ADVISORS UK LIMITED
    17 Dominion Street
    EC2M 2EF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LASER HOTELS FOUR LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MREF HOTELS FOUR LIMITED07. Feb. 200707. Feb. 2007
    HERITAGE HOTELS LIMITED19. Juli 199619. Juli 1996
    245TH SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED28. Feb. 199628. Feb. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LASER HOTELS FOUR LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für LASER HOTELS FOUR LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Sept. 2020

    7 SeitenLIQ03

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 13. Sept. 2019

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Vincent Frederic Marc Vernier als Geschäftsführer am 08. Juli 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Vincent Vernier als Sekretär am 08. Juli 2019

    1 SeitenTM02

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 07. Juni 2019

    • Kapital: GBP 1
    5 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Cancellation of share premium account 07/06/2019
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Ernennung von Mr Timothy Selwyn Jones als Direktor am 13. Dez. 2018

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Robert Edward Gray als Geschäftsführer am 24. Okt. 2018

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    18 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 031658870090 vollständig

    4 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von John Brennan als Geschäftsführer am 04. Mai 2018

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Michael Gallagher als Direktor am 20. Dez. 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Darren William Guy als Geschäftsführer am 20. Dez. 2017

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Vincent Vernier am 13. Nov. 2017

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Mr Vincent Vernier als Direktor am 06. Okt. 2017

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Vincent Vernier als Sekretär am 06. Okt. 2017

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Neal Morar als Geschäftsführer am 03. Okt. 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Neal Morar als Sekretär am 03. Okt. 2017

    1 SeitenTM02

    Wer sind die Geschäftsführer von LASER HOTELS FOUR LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GALLAGHER, Michael
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    IrelandIrish243693110001
    JONES, Timothy Selwyn
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish226437520001
    FRASER, Robert Gordon
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    Sekretär
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    British120322350001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British12314170002
    MORAR, Neal
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Sekretär
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    197427990001
    SANDERSON, Timothy Robin Llewelyn
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Sekretär
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    British69033180003
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Sekretär
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    British37564540001
    VERNIER, Vincent
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    Sekretär
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    239131660001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Bevollmächtigter Sekretär
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    ALIBONE, Lee Russell
    Darnley Lodge 68 Marsh Road
    HA5 5NQ Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Darnley Lodge 68 Marsh Road
    HA5 5NQ Pinner
    Middlesex
    British53633890001
    BRENNAN, John
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    Geschäftsführer
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish211131050001
    BUSBY, James George William
    16 Fairyknowe Court
    Bothwell
    G71 8SZ Glasgow
    Geschäftsführer
    16 Fairyknowe Court
    Bothwell
    G71 8SZ Glasgow
    United KingdomBritish584980007
    CARTWRIGHT, Stacey Lee
    46 Chiddingstone Road
    SW6 3TG London
    Geschäftsführer
    46 Chiddingstone Road
    SW6 3TG London
    British37682070002
    CAU, Antoine Edmond Andre
    10a Durward House
    31 Kensington Court
    S8 5BH London
    Geschäftsführer
    10a Durward House
    31 Kensington Court
    S8 5BH London
    French59395250002
    CHRISTIE, Scott Sommervaille
    Gospatric House
    Bankhead Road Dalmeny
    EH30 9TT Edinburgh
    Geschäftsführer
    Gospatric House
    Bankhead Road Dalmeny
    EH30 9TT Edinburgh
    ScotlandBritish104262520001
    COPELAND, Patrick Joseph
    120 Hamilton Terrace
    NW8 9UT London
    Geschäftsführer
    120 Hamilton Terrace
    NW8 9UT London
    United KingdomBritish40574670003
    CRAWFORD, Guy Lindsay Macintyre
    86 Kingston Hill
    KT2 7NP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    86 Kingston Hill
    KT2 7NP Kingston Upon Thames
    Surrey
    British77508520001
    EDWARDS, Nicholas William John
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Geschäftsführer
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    EnglandBritish166575000001
    FERGUSON DAVIE, Charles John
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Geschäftsführer
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    United KingdomBritish159387570001
    FIGGE, Heiko
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Geschäftsführer
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish183639640001
    FRASER, Robert Gordon
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    Geschäftsführer
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    United KingdomBritish120322350001
    GILBARD, Marc Edward Charles
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Geschäftsführer
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish29232300002
    GRATTON, David Martin
    Rosemead
    9 Chiltern Hills Road
    HP9 1PJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Rosemead
    9 Chiltern Hills Road
    HP9 1PJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British71901350002
    GRAY, Robert Edward
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Geschäftsführer
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    United KingdomBritish188584900001
    GUILE, David Andrew
    5 Leaheath Way
    RG10 0TY Hurst
    Berkshire
    Geschäftsführer
    5 Leaheath Way
    RG10 0TY Hurst
    Berkshire
    United KingdomBritish100133280001
    GUY, Darren
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    Geschäftsführer
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish294582970001
    HALL, Steven
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Geschäftsführer
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish147752500001
    MACDONALD, Donald John
    Cardrona
    Glen Road
    FK15 0DT Dunblane
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Cardrona
    Glen Road
    FK15 0DT Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish557590001
    MACKENZIE, Lisa Marie
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    Geschäftsführer
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    British78059700001
    MARTIN, Andrew David
    5 Dalkeith Road
    AL5 5PP Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    5 Dalkeith Road
    AL5 5PP Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish52743800001
    MORAR, Neal
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Geschäftsführer
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    EnglandBritish173110500001
    MORLEY, Ronald Martin
    8 Pinewood Close
    SL0 0QT Iver Heath
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    8 Pinewood Close
    SL0 0QT Iver Heath
    Buckinghamshire
    UkBritish517180003
    PARROTT, Graham Joseph
    Flat 1 27 Redington Road
    Hampstead
    NW3 7QY London
    Geschäftsführer
    Flat 1 27 Redington Road
    Hampstead
    NW3 7QY London
    British6741720003
    POSTER, Stephen Michael
    46 Boileau Road
    W5 3AH London
    Geschäftsführer
    46 Boileau Road
    W5 3AH London
    British67532380001
    SEDGWICK, Sarah Melanie
    42 Muncaster Road
    SW11 6NU London
    Geschäftsführer
    42 Muncaster Road
    SW11 6NU London
    British68249060001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LASER HOTELS FOUR LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    17 Dominion Street
    EC2M 2EF London
    C/O Hudson Advisors Uk Limited
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    17 Dominion Street
    EC2M 2EF London
    C/O Hudson Advisors Uk Limited
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer05893844
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat LASER HOTELS FOUR LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 18. Feb. 2015
    Geliefert am 26. Feb. 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Wells Fargobank, N.A., London Branch as Trustee for Each of the Secured Parties (The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 26. Feb. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 21. Juni 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 20. Aug. 2010
    Geliefert am 03. Sept. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Sept. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Juni 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 1 november 2005 dated 19 october 2005 and
    Erstellt am 19. Okt. 2005
    Geliefert am 08. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole that piece of ground extending to 2 acres 2 roods and 18 poles part of the lands and farm of north berwick abbey in the parish of north berwick and county of east lothian k/a marine hotel.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 31 october 2005 and
    Erstellt am 19. Okt. 2005
    Geliefert am 05. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole rusacks hotel st andrews t/n FFE11940 including all buildings erections and fixtures and fittings and fixed plant. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Okt. 2005
    Geliefert am 27. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property known as the former central club south street farnham. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties
    Transaktionen
    • 27. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Okt. 2005
    Geliefert am 27. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H the blossoms hotel st john street chester t/no CH87315.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties
    Transaktionen
    • 27. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Okt. 2005
    Geliefert am 27. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H and l/h property known as the bear hotel woodstock t/nos ON192408 ON166125 ON192410 ON192406 ON166127 and a portion of land adjoining bear hotel - unregistered f/h brandon hall hotel t/no WK242011 f/h castle hotel high street windsor t/no bk 261820 for details of further properties charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Tthe Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transaktionen
    • 27. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Okt. 2005
    Geliefert am 27. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 27. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Dez. 2003
    Geliefert am 10. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The properties known as the thames lodge hotel thames street staines (including 42 and 44 thames street) and 91 and 93 gresham road staines t/n SY373030, SY551892 and SY539815 and MX397832 including all buildings erections and fixtures and fittings and fixed plant for the time being thereon and all improvements and additions thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 10. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Dez. 2003
    Geliefert am 03. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property known as the green dragon hotel (which includes 47 broad street), broad street, hereford t/no HW66342, including all buildings, erections and fixtures and fittings and fixed plant for the time being thereon and all improvements and additions thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties
    Transaktionen
    • 03. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Dez. 2003
    Geliefert am 03. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property known as blossoms hotel, st john street, chester t/no CH87315, including all buildings, erections and fixtures and fittings and fixed plant for the time being thereon and all improvements and additions thereto and all servitudes and other heritable rights appurtenant thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 03. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Nov. 2003
    Geliefert am 22. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property known as bush hotel, shops and flats in the borough and 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9 and 9A south street, farnham t/no SY425153, including all buildings, erections and fixtures and fittings and fixed plant for the time being thereon and all improvements and additions thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Nov. 2003
    Geliefert am 20. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a former central club t/n SK164707. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties
    Transaktionen
    • 20. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Okt. 2003
    Geliefert am 28. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The properties known as bear hotel woodstock oxfordshire t/n ON166127, 36 rectory lane 11, 11A and 13 market place, 5C market place, 74 oxford street t/n ON192408, t/n ON166125, t/n ON192410, ON192406 and land adjoining the bear hotel woodstock oxfordshire including all buildings erections and fixtures fittings and fixed plant. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties) (the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 05 september 2003 and
    Erstellt am 03. Sept. 2003
    Geliefert am 10. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and whole (first) all and whole that area or piece of ground extending to two acres, two roods and eighteen poles or thereby, part of the lands and farm of north berwick abbey in the parish of north berwick and county of east lothian;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 05 september 2003 and
    Erstellt am 03. Sept. 2003
    Geliefert am 10. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and whole rusacks hotel, st andrews, t/n FFE11940, including all buildings, erections and fixtures and fittings and fixed plant for the time being thereon and all improvements and additions thereto;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Sept. 2003
    Geliefert am 06. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Properties k/a the white hart hotel and numbers 2, 93 and 94 bailgate, lincoln t/nos. LL20354 and LL141872. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Sept. 2003
    Geliefert am 06. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a the new bath hotel, matlock, bath, derbyshire t/no. DY278979. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Sept. 2003
    Geliefert am 06. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a leeming house and leeming cottages, watermillock, nr penrith, cumbria t/nos. CU152326, CU164397 and CU164398. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Sept. 2003
    Geliefert am 06. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Properties k/a white hart hotel and land adjoining land and 90 and 02 brown street, salisbury, wiltshire t/nos. WT155989, WT198683 and WT171056. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Sept. 2003
    Geliefert am 06. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a the whateley hall hotel, horsefair, banbury, oxfordshire and land lying to the west of horsefair, banbury t/nos. ON192790 and ON34875. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Sept. 2003
    Geliefert am 06. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a the eastgate hotel, high street, oxford t/no. ON207888. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Sept. 2003
    Geliefert am 06. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Properties k/a (1) the queens hotel and queens hotel garage, imperial square, the promenade, cheltenham (2) land lying to the north east of montpellier spa road, cheltenham and (3) land and buildings on the south side of imperial square, the promenade, cheltenham t/nos. GR154133, GR183974 and GR238164 respectively. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Sept. 2003
    Geliefert am 06. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The properties k/a upper reaches, thames street (including abbey mill), abingdon, oxfordshire t/no. BK103989. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 03. Sept. 2003
    Geliefert am 06. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat LASER HOTELS FOUR LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    13. Sept. 2019Beginn der Liquidation
    18. Jan. 2022Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0