MERCURY TAVERNS (LONDON) LIMITED

MERCURY TAVERNS (LONDON) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMERCURY TAVERNS (LONDON) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03175599
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MERCURY TAVERNS (LONDON) LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich MERCURY TAVERNS (LONDON) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Marston's House
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MERCURY TAVERNS (LONDON) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ROXLEA LIMITED20. März 199620. März 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MERCURY TAVERNS (LONDON) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis04. Okt. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für MERCURY TAVERNS (LONDON) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    legacy

    1 SeitenCAP-MDSC

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des genehmigten Stammkapitals

    RES05
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Satzung

    RES01

    legacy

    2 Seiten88(2)

    legacy

    1 Seiten123

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10
    capital

    Beschluss zur Erhöhung des genehmigten Stammkapitals

    RES04

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    legacy

    1 SeitenCAP-MDSC

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Satzung

    RES01
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des genehmigten Stammkapitals

    RES05

    legacy

    2 Seiten88(2)

    legacy

    1 Seiten123

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Beschluss zur Kapitalisierung oder Ausgabe von Gratisaktien

    100 accumulated reserces to be capitalised 18/09/2009
    RES14
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10
    capital

    Beschluss zur Erhöhung des genehmigten Stammkapitals

    RES04

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    5 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 04. Okt. 2008

    6 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Sept. 2007

    5 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    3 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von MERCURY TAVERNS (LONDON) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRENNAN, Anne Marie
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    Sekretär
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    British109935620001
    ANDREA, Andrew Andonis
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    EnglandBritish137383120001
    ANDREW, Derek
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    British39071260003
    DARBY, Alistair William
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    British87846880002
    FINDLAY, Ralph Graham
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marstons House
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marstons House
    West Midlands
    EnglandBritish129897400001
    OLIVER, Stephen John
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    British66123690003
    CLARK, Alan William
    72 Flures Drive
    Abbeyfield
    PA8 7DG Erskine
    Renfrewshire
    Sekretär
    72 Flures Drive
    Abbeyfield
    PA8 7DG Erskine
    Renfrewshire
    British51280050001
    MARSHALL, Anthony Derek
    Inglenook
    18 Chartwell Grove,Mapperley Plains
    NG3 5RD Nottingham
    Sekretär
    Inglenook
    18 Chartwell Grove,Mapperley Plains
    NG3 5RD Nottingham
    British5277910002
    PORTER, Hugh Leslie
    The Wolverhampton & Dudley
    Breweries Plc PO BOX 26
    WV1 4NY Park Brewery Bath Road
    Wolverhampton
    Sekretär
    The Wolverhampton & Dudley
    Breweries Plc PO BOX 26
    WV1 4NY Park Brewery Bath Road
    Wolverhampton
    British63443690002
    SANDERS, Anthony Raymond
    Foxwood
    Kington Rise Kington Lane
    CV35 8PN Claverdon
    Warwickshire
    Sekretär
    Foxwood
    Kington Rise Kington Lane
    CV35 8PN Claverdon
    Warwickshire
    British44653470002
    EMCEE NOMINEES LIMITED
    First Floor 31 Southampton Row
    WC1B 5HT London
    Sekretär
    First Floor 31 Southampton Row
    WC1B 5HT London
    38708590001
    SECRETAIRE LIMITED
    3rd Floor
    2 Luke Street
    EC2A 4NT London
    Bevollmächtigter Sekretär
    3rd Floor
    2 Luke Street
    EC2A 4NT London
    900011490001
    BOURTON, Richard
    Gold Acre
    Burton Road Elford
    B79 9BN Tamworth
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Gold Acre
    Burton Road Elford
    B79 9BN Tamworth
    Staffordshire
    United KingdomBritish37624870001
    CLARK, Alan William
    72 Flures Drive
    Abbeyfield
    PA8 7DG Erskine
    Renfrewshire
    Geschäftsführer
    72 Flures Drive
    Abbeyfield
    PA8 7DG Erskine
    Renfrewshire
    British51280050001
    INGLETT, Paul
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    British81617110002
    MARSHALL, Anthony Derek
    Inglenook
    18 Chartwell Grove,Mapperley Plains
    NG3 5RD Nottingham
    Geschäftsführer
    Inglenook
    18 Chartwell Grove,Mapperley Plains
    NG3 5RD Nottingham
    British5277910002
    SANDERS, Anthony Raymond
    Foxwood
    Kington Rise Kington Lane
    CV35 8PN Claverdon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Foxwood
    Kington Rise Kington Lane
    CV35 8PN Claverdon
    Warwickshire
    British44653470002
    WOMACK, Martin
    10 Friars Street
    WV16 4BJ Bridgnorth
    Shropshire
    Geschäftsführer
    10 Friars Street
    WV16 4BJ Bridgnorth
    Shropshire
    British75969860001
    MARRIOTTS LIMITED
    2 Luke Street
    EC2A 4NT London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    2 Luke Street
    EC2A 4NT London
    900013400001

    Hat MERCURY TAVERNS (LONDON) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 10. Okt. 1996
    Geliefert am 21. Okt. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the indemnity agreement of even date
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Wolverhampton & Dudley Breweries PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 10. Okt. 1996
    Geliefert am 21. Okt. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the indemnity agreement of even date
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Marston Thompson & Evershed PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 26. Apr. 1996
    Geliefert am 10. Mai 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company formerly known as roxlea limited to the chargees pursuant to the terms of a facility agreement dated 17/11/95
    Kurze Angaben
    First legal mortgage over the properties k/a flamingo brewery 88 london road kingston-upon-thames surrey magpie and stump 132 stoke newington church street london. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Trustee for the Agent and the Beneficiaries(As Defined)
    Transaktionen
    • 10. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Apr. 1996
    Geliefert am 04. Mai 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as roxlea limited to the chargee pursuant to an omnibus guarantee and set off agreement dated 30TH november 1995 and a facilities agreement dated 17TH november 1994
    Kurze Angaben
    All right title and interest held by the mortgagor in the l/h property k/a dean swift 1 lafone street london SE1.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Trustee for the Agent and the Banks and the Overdraft Bank and the Swap Counterparties (Eachas Defined in the Facilities Agreement)
    Transaktionen
    • 04. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Apr. 1996
    Geliefert am 04. Mai 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as roxlea limited to the chargee pursuant to an omnibus guarantee and set off agreement dated 30TH november 1995 and a facilities agreement dated 17TH november 1994
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the l/h property k/a lowndes arms 37 chesham street london SW1.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Trustee for the Agent and the Banks and the Overdraft Bank and the Swap Counterparties (Eachas Defined in the Facilities Agreement)
    Transaktionen
    • 04. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Apr. 1996
    Geliefert am 04. Mai 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as roxlea limited to the chargee pursuant to an omnibus guarantee and set off agreement dated 30TH november 1995 and a facilities agreement dated 17TH november 1994
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the l/h property k/a the hedgehog & stump 13 richmond road twickenham middlesex.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Trustee for the Agent and the Banks and the Overdraft Bank and the Swap Counterparties (Eachas Defined in the Facilities Agreement)
    Transaktionen
    • 04. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Apr. 1996
    Geliefert am 04. Mai 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as roxlea limited to the chargee pursuant to an omnibus guarantee and set off agreement dated 30TH november 1995 and a facilities agreement dated 17TH november 1994
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the l/h property k/a minogues bar 80 liverpool road islington london.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Trustee for the Agent and the Banks and the Overdraft Bank and the Swap Counterparties (Eachas Defined in the Facilities Agreement)
    Transaktionen
    • 04. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Apr. 1996
    Geliefert am 04. Mai 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as roxlea limited to the chargee pursuant to an omnibus guarantee and set off agreement dated 30TH november 1995 and a facilities agreement dated 17TH november 1994
    Kurze Angaben
    All right title and interest held by the mortgagor in the l/h property k/a flamingo brewery 88 london road kingston upon thames surrey.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Trustee for the Agent and the Banks and the Overdraft Bank and the Swap Counterparties(Each as Defined in the Facilities Agreement)
    Transaktionen
    • 04. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Apr. 1996
    Geliefert am 04. Mai 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as roxlea limited to the chargee pursuant to an omnibus guarantee and set off agreement dated 30TH november 1995 and a facilities agreement dated 17TH november 1995
    Kurze Angaben
    All right title and interest held by the mortgagor now or at any time in the future in the l/h property k/a flamingo brewery 88 london road kingston upon thames surrey.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Trustee for the Agent and the Banks and the Overdraft Bank and the Swap Counterparties (Eachas Defined in the Facilities Agreement)
    Transaktionen
    • 04. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Apr. 1996
    Geliefert am 04. Mai 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as roxlea limited to the chargee pursuant to an omnibus guarantee and set off agreement dated 30TH november 1995 and a facilities agreement dated 17TH november 1995
    Kurze Angaben
    All right title and interest noe or at any time in the l/h property k/a molly blooms 142-146 whitecross street london EC1Y 8QJ.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Trustee for the Agent and the Banks and the Overdraft Bank and the Swap Counterparties (Eachas Defined in the Facilities Agreement)
    Transaktionen
    • 04. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Apr. 1996
    Geliefert am 04. Mai 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as roxlea limited to the chargee pursuant to an omnibus guarantee and set off agreement dated 30TH november 1995 and a facilities agreement dated 17TH november 1995
    Kurze Angaben
    All right title and interest held by the mortgagor now or at any time in the future in the l/h property k/a magpie & stump 132 stoke newington church street london N16.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Trustee for the Agent and the Banks and the Overdraft Bank and the Swap Counterparties (Eachas Defined in the Facilities Agreement)
    Transaktionen
    • 04. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0