SPORTING LIFE UK LIMITED
Überblick
Unternehmensname | SPORTING LIFE UK LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03177760 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SPORTING LIFE UK LIMITED?
- (9251) /
- (9262) /
Wo befindet sich SPORTING LIFE UK LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8 Salisbury Square EC4Y 8BB London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SPORTING LIFE UK LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
PA SPORTING LIFE LIMITED | 29. Nov. 1996 | 29. Nov. 1996 |
PA WEATHERBYS RACING COMMUNICATIONS LIMITED | 17. Juni 1996 | 17. Juni 1996 |
DIPLEMA 324 LIMITED | 26. März 1996 | 26. März 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SPORTING LIFE UK LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SPORTING LIFE UK LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 4 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 24. März 2012 | 4 Seiten | 4.68 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Grant Way Isleworth Middlesex TW7 5QD am 13. Apr. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Ernennung von Christopher Jon Taylor als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von David Joseph Gormley als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Flint als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Steele als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Piers Croton als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 18. Feb. 2011
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 14. Feb. 2011
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010 | 20 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 20 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Simon Naunton Steele als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Vincent Russell als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008 | 25 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SPORTING LIFE UK LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORMLEY, David Joseph | Sekretär | Grant Way TW7 5QD Isleworth Middlesex | British | 150780210001 | ||||||
GORMLEY, David Joseph | Geschäftsführer | Grant Way TW7 5QD Isleworth British Sky Broadcasting Group Plc Middlesex | United Kingdom | British | Company Secretary | 150780210001 | ||||
TAYLOR, Christopher Jon | Geschäftsführer | Grant Way TW7 5QD Isleworth British Sky Broadcasting Group Plc Middlesex | England | British | Company Secretary | 135143490001 | ||||
BROWN, Steven John | Sekretär | 7 Broadwater Lane Aston SG2 7EN Stevenage Hertfordshire | British | Managing Director Chartered Ac | 3379480001 | |||||
GALVIN, Andrew Michael | Sekretär | North Longlands Leeds Road Lightcliffe HX3 8JN Halifax West Yorkshire | British | Director | 49667690003 | |||||
KENNEDY, Christina Lillian | Sekretär | Walnut House Walnut Gardens Claydon OX17 1NA Banbury Oxfordshire | British | Secretary | 7909160003 | |||||
MARJORIBANKS, Richard John Bradley | Sekretär | 8 Tewit Well Avenue HG2 8AP Harrogate North Yorkshire | British | 56196620001 | ||||||
WEBSTER, Martin | Bevollmächtigter Sekretär | 10 St Peters Place W9 2EE London | British | 900005040001 | ||||||
ADSHEAD, Vivienne | Geschäftsführer | The Old Chapel Tong Park, Baildon BD17 7QH Shipley West Yorkshire | British | Commercial Director | 68166530001 | |||||
ALLWOOD, Charles John | Geschäftsführer | Park Farm The Twist Wigginton HP23 6DU Tring Hertfordshire | England | British | Company Director | 35681240003 | ||||
ANNAT, David Christie | Geschäftsführer | Watergap Dig Street SK17 0AQ Hartington Derbyshire | British | Company Director | 2145940001 | |||||
ANNAT, David Christie | Geschäftsführer | Watergap Dig Street SK17 0AQ Hartington Derbyshire | British | Managing Director | 2145940001 | |||||
BROWN, Steven John | Geschäftsführer | 7 Broadwater Lane Aston SG2 7EN Stevenage Hertfordshire | United Kingdom | British | Finance Director | 3379480001 | ||||
CROTON, Piers Maitland Adrian | Geschäftsführer | Grant Way TW7 5QD Isleworth British Sky Broadcasting Group Plc Middlesex | British | Director | 36253150002 | |||||
DUBENS, Peter Adam Daiches | Geschäftsführer | The Economist Building 8th Floor 25 St Jamess Street SW1A 1HA London | Switzerland | British | Director | 153016810001 | ||||
EWING, Margaret | Geschäftsführer | Maraval Hamm Court KT13 8YG Weybridge Surrey | British | Financial Director | 68009020001 | |||||
FLINT, Richard | Geschäftsführer | Grant Way TW7 5QD Isleworth British Sky Broadcasting Group Plc Middlesex | British | Company Director | 103872130004 | |||||
GALVIN, Andrew Michael | Geschäftsführer | North Longlands Leeds Road Lightcliffe HX3 8JN Halifax West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 49667690003 | ||||
GRIFFITH, Andrew John | Geschäftsführer | British Sky Broadcasting Group Plc Grant Way TW7 5QD Isleworth Middlesex | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 129926510001 | ||||
NORRIS, John Lionel | Geschäftsführer | Roseland 42 Debdale Road NN8 5AJ Wellingborough Northamptonshire | United Kingdom | British | Business Executive | 15693810004 | ||||
PEREIRA, Alan Dennis | Geschäftsführer | 30 Kingscliffe Gardens SW19 6NR London | British | Director | 61856670002 | |||||
POTTS, Paul John | Geschäftsführer | Western Gardens Ealing W5 3RU London 26 | United Kingdom | British | Chief Executive | 43329700002 | ||||
REARDON, Jonathan Andrew | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Westfield Latchmore Bank Little Hallingbury CM22 7PH Bishop's Stortford Hertfordshire | British | 900005030001 | ||||||
REED, Jeremy Peter | Geschäftsführer | Palletts Farmhouse High Street CB11 3PE Newport Essex | British | Managing Director | 94644540001 | |||||
RIKLIN, Cornel Carl | Geschäftsführer | 11 Warrington Crescent W9 1ED London | British | Company Director | 50935910001 | |||||
RUSSELL, Vincent Harvey | Geschäftsführer | Grant Way TW7 5QD Isleworth British Sky Broadcasting Group Plc Middlesex | United Kingdom | British | Accountant | 168038230001 | ||||
RUST, Nicholas John | Geschäftsführer | 2 Manor Court Little Ouseburn YO26 9TB York North Yorkshire | United Kingdom | British | Managing Director | 112088680001 | ||||
SEMEL, Eric | Geschäftsführer | 33 Chesham Street Flat 8 SW1X 8NQ London | American | Director | 102427690001 | |||||
SHERWOOD, Barrie John | Geschäftsführer | 1 Lodge Road Sharnbrook MK44 1JB Bedford Bedfordshire | British | Accountant | 13479190001 | |||||
SIMPSON, Robert Brian | Geschäftsführer | 1 Combe Royal Crescent BA2 6EZ Bath Avon | British | Chief Executive | 100368690001 | |||||
STEELE, Simon Naunton | Geschäftsführer | Grant Way TW7 5QD Isleworth British Sky Broadcasting Plc Middlesex | England | British | Accountant | 220122710001 | ||||
WEATHERBY, Jonathan Roger, Sir | Geschäftsführer | Preston Lodge Withcote LE15 8DP Oakham Leicestershire | England | British | Business Executive | 10579020003 | ||||
WEBSTER, Martin | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 10 St Peters Place W9 2EE London | British | 900005040001 |
Hat SPORTING LIFE UK LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 14. Okt. 2004 Geliefert am 21. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Memorandum of variation | Erstellt am 03. März 2000 Geliefert am 22. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag To the chargee the amount secured by a secured loan note dated 28 june 1996 and granted by the company in favour of weatherbys group limited as varied by a memorandum of variation dated 28 november 1996 and as further varied by this memorandum of variation is £1,085,000 and such additional sums (up to a further £415,000) as may be advanced under the terms of the secured loan note | |
Kurze Angaben The property charge is that charged by the secured loan note as described in the form 395 for such loan note as registered on the 8/7/96. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Memorandum of variation | Erstellt am 03. März 2000 Geliefert am 22. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag To the chargee the amount secured by a secured loan note dated 28 june 1996 and granted by the company in favour of ananova limited (formerly pa news limited) as varied by a memorandum of variation and as further varied by this memorandum of variation is £1,085,000 and such additional sums (up to a further £415,000) as may be advanced under the terms of the secured loan note | |
Kurze Angaben The property charged is that charged by the secured loan note as described in the form 395 for such loan note as registered on the 15/7/96. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Memorandum of variation | Erstellt am 28. Nov. 1996 Geliefert am 18. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £350,000 due or to become from the company to the chargee | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Secured loan note | Erstellt am 28. Juni 1996 Geliefert am 15. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £250,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Secured loan note | Erstellt am 28. Juni 1996 Geliefert am 08. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the secured loan note | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat SPORTING LIFE UK LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0