CHADALE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CHADALE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03183455 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHADALE LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich CHADALE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Thane Road West NG2 3AA Nottingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHADALE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHADALE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von David Charles Geoffrey Foster als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von David Charles Geoffrey Foster als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Muller als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Patricia Kennerley als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Aylward als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Muller als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Christopher James Giles als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CHADALE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOSTER, David Charles Geoffrey | Sekretär | 1 Thane Road West NG90 1BS Nottingham D90 | British | 150377370001 | ||||||
| FOSTER, David Charles Geoffrey | Geschäftsführer | 1 Thane Road West NG90 1BS Nottingham D90 | England | British | 52040210004 | |||||
| GILES, Christopher James | Geschäftsführer | Thane Road West NG2 3AA Nottingham 1 | England | British | 149729660001 | |||||
| CHADWICK, Michal Charles | Sekretär | Ivy Cottage 72 Church Road Uppermill OL3 6EH Oldham | British | 47285370001 | ||||||
| GREER, Richard David | Sekretär | Sidebank House Holmfirth Road Greenfield OL3 7NL Oldham Lancashire | British | 63038770002 | ||||||
| MULLER, Mark Francis, Mr. | Sekretär | Elm Lodge 15 Oaken Coppice KT21 1DL Ashtead Surrey | British | 63620010002 | ||||||
| VIBRANS, Philip Charles | Bevollmächtigter Sekretär | 1 Ashfield Road Davenport SK3 8UD Stockport Cheshire | British | 900008370001 | ||||||
| AYLWARD, Christopher David | Geschäftsführer | Buchan Cottage 2 Cheapside GU21 4JG Horsell Woking | United Kingdom | British | 59741430002 | |||||
| CHADWICK, Michal Charles | Geschäftsführer | Ivy Cottage 72 Church Road Uppermill OL3 6EH Oldham | British | 47285370001 | ||||||
| DALE, Allan | Geschäftsführer | 39 Stoneswood Road Delph OL3 5DY Oldham | British | 47285600001 | ||||||
| GREER, Janette | Geschäftsführer | Sidebank House Holmfirth Road Greenfield OL3 7NL Oldham Lancashire | British | 63038660002 | ||||||
| GREER, Richard David | Geschäftsführer | Sidebank House Holmfirth Road Greenfield OL3 7NL Oldham Lancashire | British | 63038770002 | ||||||
| KENNERLEY, Patricia Diane | Geschäftsführer | D90 1 Thane Road West NG90 1BS Nottingham | Great Britain | British | 110727230002 | |||||
| MULLER, Mark Francis, Mr. | Geschäftsführer | Elm Lodge 15 Oaken Coppice KT21 1DL Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 63620010002 | |||||
| DAVENPORT CREDIT LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 1 Ashfield Road Davenport SK3 8UD Stockport Cheshire | 900008360001 |
Hat CHADALE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 24. Mai 1996 Geliefert am 29. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or allan dale and/or michael charles chadwick to the chargee under a guarantee or other arrangement and in respect of any one or more trading account or loan account or equipment loan or otherwise howsoever | |
Kurze Angaben Legal mortgage over all freehold and leasehold property now vested in the company, whether registered or unregistered title including all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed pllant and machinery from time to time thereon;. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Mai 1996 Geliefert am 29. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage all the freehold and leasehold property now vested in or charged to the company. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Mai 1996 Geliefert am 29. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage:- all that leasehold property at 18 peel street marsden t/n-WYK325102 by way of fixed charge, the plant machinery and fixtures and fittings of the company; the furniture furnishings equipment tools and other chattels of the company; the present and future goodwill of any business carried on at the property by or on behalf of the company and the proceeds of any insurance from time to time affecting the property or the assets referred to above. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0