TRINITY CARE HOMES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | TRINITY CARE HOMES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03184056 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TRINITY CARE HOMES LIMITED?
- Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich TRINITY CARE HOMES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TRINITY CARE HOMES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
STONEYFORD CHRISTIAN NURSING HOME LIMITED | 06. Sept. 1996 | 06. Sept. 1996 |
AYCEECO (140) LIMITED | 10. Apr. 1996 | 10. Apr. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRINITY CARE HOMES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TRINITY CARE HOMES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 31. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Charles Lovett als Direktor am 31. Aug. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs | 6 Seiten | 1.4 | ||||||||||
Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs | 4 Seiten | 1.1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Midmer als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2009 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Andrew Smith am 07. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung eines Direktors | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kamma Foulkes als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TRINITY CARE HOMES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOVETT, David Charles | Geschäftsführer | The Grange SW19 4PS London 17 England England | United Kingdom | British | Director | 34419700002 | ||||
TAYLOR, Stephen Jonathan | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 163496070001 | ||||
GOODALL, Christopher John | Sekretär | 4 Manor Court Bramcote NG9 3DR Nottingham Nottinghamshire | British | Company Director | 84003280001 | |||||
LONG, Anne Marguerite Dorothy | Sekretär | Flat 6 107 Metchley Lane Harborne B17 0HP Birmingham | British | Solicitor | 43180700001 | |||||
MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158661940001 | |||||||
MCLEISH, William David | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
RUTTER, Christopher | Sekretär | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | Company Director | 103588940001 | |||||
ARTHUR, Kevin Mccabe | Geschäftsführer | The Landings Beningbrough YO30 1BY York | British | Company Director | 51886750002 | |||||
BOLOT, Timothy James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 107837080002 | ||||
BUCHAN, William James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | Director | 79917240001 | ||||
COLVIN, William | Geschäftsführer | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | Director | 51697890003 | ||||
FARMER, Nicholas John | Geschäftsführer | 62 Freshwater Close Great Sankey WA5 3PU Warrington Cheshire | United Kingdom | British | Director | 124228290001 | ||||
FINNIS, Pam | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 133719530001 | ||||
FOULKES, Kamma | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Managing Director | 111188390002 | ||||
GEE, Andrew Anthony Edward | Geschäftsführer | 83a Sutherland Avenue TN16 3HG Biggin Hill Kent | England | British | Director | 93592160001 | ||||
GOODALL, Christopher John | Geschäftsführer | 4 Manor Court Bramcote NG9 3DR Nottingham Nottinghamshire | England | British | Company Director | 84003280001 | ||||
HENDERSON, David Greig | Geschäftsführer | 20 Lydney Park West Bridgford NG2 7TJ Nottingham | England | British | Company Director | 6112570002 | ||||
HILL, Randolph Paul | Geschäftsführer | 40 Bridgetown Road CV37 7JA Stratford Upon Avon Warwickshire | British | Company Director | 15223790003 | |||||
LOCK, Jason David | Geschäftsführer | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | Director | 144822040001 | ||||
LONG, Anne Marguerite Dorothy | Geschäftsführer | Flat 6 107 Metchley Lane Harborne B17 0HP Birmingham | British | Solicitor | 43180700001 | |||||
MARK, Larry Edward | Geschäftsführer | 29 Cedar Drive SL5 0UA Sunningdale Berkshire | New Zealander | Company Director | 5076900001 | |||||
MIDMER, Richard Neil | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | Director | 110640170001 | ||||
MORETON, John Ernest | Geschäftsführer | The Old Farm Winkfield Row RG12 6NG Reading Berkshire | New Zealander | Company Director | 80392940001 | |||||
MURPHY, John | Geschäftsführer | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | Director | 26177180004 | ||||
POYNTON, Ellen | Geschäftsführer | Whiteoaks 10 St Richards Close, Wychbold WR9 7PP Droitwich | United Kingdom | British | Director | 89071020004 | ||||
PRESTON, Mary | Geschäftsführer | 1 Pall Mall Cottage Rivington Lane BL6 7RY Bolton | United Kingdom | British | Director | 124068010001 | ||||
RUTTER, Christopher | Geschäftsführer | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | Company Director | 103588940001 | |||||
SCOTT, Philip Henry | Geschäftsführer | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | England | British | Company Director | 174231320001 | ||||
SIZER, Graham Kevin | Geschäftsführer | Old Salutation Barn Low Street Little Fencote DL7 9LR Northallerton | England | British | Chartered Accountant | 77274540003 | ||||
SMITH, David Andrew, Mr. | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 147997950001 | ||||
SUFFIELD, Mervyn John, Dr | Geschäftsführer | The Cottage Winchester Road Waltham Chase SO32 2LG Southampton Hampshire | British | Company Director | 34214100001 | |||||
THORNE, Anthony David | Geschäftsführer | 41 Bartholomew Place RG42 3DQ Warfield Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 80445640001 | ||||
WEARING, John Howard | Geschäftsführer | 56 Rosemary Hill Road B74 4HJ Sutton Coldfield West Midlands | England | British | Solicitor | 46626990001 |
Hat TRINITY CARE HOMES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A supplemental debenture | Erstellt am 29. Okt. 1999 Geliefert am 03. Nov. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 11. Apr. 1997 Geliefert am 23. Apr. 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums payable by the company to the chargee in the event of default (as defined) under the terms of a lease dated 4TH february 1997 | |
Kurze Angaben The initial deposit means the sum equivalent to twice the basic rent (as defined) and interest which means all interest credited to the deposit account. Deposit account means an interest bearing deposit account at such bank or institution as the landlord shall from time to time decide.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 11. Apr. 1997 Geliefert am 22. Apr. 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in the event of a default | |
Kurze Angaben The company with full title guarantee charges the initial deposit,all interest,the deposit account being an interest bearing account specifically designated "deposit account" at such bank or institution as the chargee (landlord) shall from time to time decide in it's absolute discretion and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 03. Feb. 1997 Geliefert am 06. Feb. 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property k/a chandlers ford christian nursing home winchester road chandlers ford eastleigh hampshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 28. Nov. 1996 Geliefert am 14. Dez. 1996 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge on l/hold premises at stoneyford nursing home,stoneyford rd,sutton in ashfield,nottinghamshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 28. Nov. 1996 Geliefert am 10. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in the event of default | |
Kurze Angaben The deposit as defined on the reverse of the form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat TRINITY CARE HOMES LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0