TRINITY CARE HOMES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTRINITY CARE HOMES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03184056
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TRINITY CARE HOMES LIMITED?

    • Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich TRINITY CARE HOMES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TRINITY CARE HOMES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    STONEYFORD CHRISTIAN NURSING HOME LIMITED06. Sept. 199606. Sept. 1996
    AYCEECO (140) LIMITED10. Apr. 199610. Apr. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRINITY CARE HOMES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für TRINITY CARE HOMES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 31. Aug. 2012

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr David Charles Lovett als Direktor am 31. Aug. 2012

    2 SeitenAP01

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    6 Seiten1.4

    Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs

    4 Seiten1.1

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Apr. 2012

    Kapitalaufstellung am 10. Apr. 2012

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    19 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Ernennung von Mr Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Richard Midmer als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Explanatory statment to sole member 14/05/2010
    RES13

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2009

    17 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Andrew Smith am 07. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Ernennung eines Direktors

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Kamma Foulkes als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von TRINITY CARE HOMES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LOVETT, David Charles
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    Geschäftsführer
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    United KingdomBritishDirector34419700002
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector163496070001
    GOODALL, Christopher John
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director84003280001
    LONG, Anne Marguerite Dorothy
    Flat 6 107 Metchley Lane
    Harborne
    B17 0HP Birmingham
    Sekretär
    Flat 6 107 Metchley Lane
    Harborne
    B17 0HP Birmingham
    BritishSolicitor43180700001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158661940001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Sekretär
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    BritishCompany Director103588940001
    ARTHUR, Kevin Mccabe
    The Landings
    Beningbrough
    YO30 1BY York
    Geschäftsführer
    The Landings
    Beningbrough
    YO30 1BY York
    BritishCompany Director51886750002
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritishDirector79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritishDirector51697890003
    FARMER, Nicholas John
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector124228290001
    FINNIS, Pam
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector133719530001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishManaging Director111188390002
    GEE, Andrew Anthony Edward
    83a Sutherland Avenue
    TN16 3HG Biggin Hill
    Kent
    Geschäftsführer
    83a Sutherland Avenue
    TN16 3HG Biggin Hill
    Kent
    EnglandBritishDirector93592160001
    GOODALL, Christopher John
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishCompany Director84003280001
    HENDERSON, David Greig
    20 Lydney Park
    West Bridgford
    NG2 7TJ Nottingham
    Geschäftsführer
    20 Lydney Park
    West Bridgford
    NG2 7TJ Nottingham
    EnglandBritishCompany Director6112570002
    HILL, Randolph Paul
    40 Bridgetown Road
    CV37 7JA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    40 Bridgetown Road
    CV37 7JA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishCompany Director15223790003
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Geschäftsführer
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritishDirector144822040001
    LONG, Anne Marguerite Dorothy
    Flat 6 107 Metchley Lane
    Harborne
    B17 0HP Birmingham
    Geschäftsführer
    Flat 6 107 Metchley Lane
    Harborne
    B17 0HP Birmingham
    BritishSolicitor43180700001
    MARK, Larry Edward
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    Geschäftsführer
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    New ZealanderCompany Director5076900001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritishDirector110640170001
    MORETON, John Ernest
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    New ZealanderCompany Director80392940001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Geschäftsführer
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritishDirector26177180004
    POYNTON, Ellen
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    Geschäftsführer
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    United KingdomBritishDirector89071020004
    PRESTON, Mary
    1 Pall Mall Cottage
    Rivington Lane
    BL6 7RY Bolton
    Geschäftsführer
    1 Pall Mall Cottage
    Rivington Lane
    BL6 7RY Bolton
    United KingdomBritishDirector124068010001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Geschäftsführer
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    BritishCompany Director103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritishCompany Director174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Geschäftsführer
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritishChartered Accountant77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector147997950001
    SUFFIELD, Mervyn John, Dr
    The Cottage Winchester Road
    Waltham Chase
    SO32 2LG Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The Cottage Winchester Road
    Waltham Chase
    SO32 2LG Southampton
    Hampshire
    BritishCompany Director34214100001
    THORNE, Anthony David
    41 Bartholomew Place
    RG42 3DQ Warfield
    Berkshire
    Geschäftsführer
    41 Bartholomew Place
    RG42 3DQ Warfield
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director80445640001
    WEARING, John Howard
    56 Rosemary Hill Road
    B74 4HJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    56 Rosemary Hill Road
    B74 4HJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishSolicitor46626990001

    Hat TRINITY CARE HOMES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A supplemental debenture
    Erstellt am 29. Okt. 1999
    Geliefert am 03. Nov. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 1 Limited
    Transaktionen
    • 03. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 11. Apr. 1997
    Geliefert am 23. Apr. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums payable by the company to the chargee in the event of default (as defined) under the terms of a lease dated 4TH february 1997
    Kurze Angaben
    The initial deposit means the sum equivalent to twice the basic rent (as defined) and interest which means all interest credited to the deposit account. Deposit account means an interest bearing deposit account at such bank or institution as the landlord shall from time to time decide.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.1 PLC
    Transaktionen
    • 23. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 11. Apr. 1997
    Geliefert am 22. Apr. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the event of a default
    Kurze Angaben
    The company with full title guarantee charges the initial deposit,all interest,the deposit account being an interest bearing account specifically designated "deposit account" at such bank or institution as the chargee (landlord) shall from time to time decide in it's absolute discretion and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.1 PLC
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 03. Feb. 1997
    Geliefert am 06. Feb. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a chandlers ford christian nursing home winchester road chandlers ford eastleigh hampshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. I PLC
    Transaktionen
    • 06. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. Nov. 1996
    Geliefert am 14. Dez. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First fixed charge on l/hold premises at stoneyford nursing home,stoneyford rd,sutton in ashfield,nottinghamshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.I PLC
    Transaktionen
    • 14. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 28. Nov. 1996
    Geliefert am 10. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the event of default
    Kurze Angaben
    The deposit as defined on the reverse of the form 395.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 1 PLC
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juli 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat TRINITY CARE HOMES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Juni 2012Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    20. Aug. 2012Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Howard Smith
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    Praktiker
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0