CONNAUGHT PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCONNAUGHT PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 03184319
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CONNAUGHT PLC?

    • (4525) /
    • (7415) /

    Wo befindet sich CONNAUGHT PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kpmg Llp 15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CONNAUGHT PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CONNAUGHT HOLDINGS LIMITED29. Mai 199629. Mai 1996
    BONDCO 611 LIMITED11. Apr. 199611. Apr. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CONNAUGHT PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für CONNAUGHT PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    21 SeitenWU15

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    20 SeitenWU07

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    19 SeitenWU07

    Mitteilung über die Entfernung des Liquidators durch das Gericht

    10 SeitenWU14

    Ernennung eines Liquidators

    3 SeitenWU04

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:liquidators annual progress report to 24/02/2017
    17 SeitenLIQ MISC

    Insolvenzmeldung

    INSOLVENCY:liquidators annual progress report compulsory liquidation bdd 24/02/2016
    14 SeitenLIQ MISC

    Insolvenzmeldung

    INSOLVENCY:liquidators annual progress report compulsory liquidation bdd 24/02/2016
    14 SeitenLIQ MISC

    Insolvenzmeldung

    INSOLVENCY:liquidators annual progress report compulsory liquidation bdd 24/02/2015
    15 SeitenLIQ MISC

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Kpmg 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB zum Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL am 08. Apr. 2015

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Liquidators

    1 Seiten4.31

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    3 SeitenCOCOMP

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Feb. 2014

    25 Seiten2.24B

    Mitteilung über einen Gerichtsbeschluss zur Beendigung der Verwaltung

    1 Seiten2.33B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Feb. 2014

    25 Seiten2.24B

    Mitteilung über einen Gerichtsbeschluss zur Beendigung der Verwaltung

    25 Seiten2.33B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Dez. 2013

    24 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Dez. 2013

    21 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Juni 2013

    21 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Juni 2013

    21 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Juni 2013

    21 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Dez. 2012

    22 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Dez. 2012

    22 Seiten2.24B

    Wer sind die Geschäftsführer von CONNAUGHT PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CAVANAGH, Julia
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Sekretär
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    British140133020001
    HILL, Stephen Ronald
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    Geschäftsführer
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish115233060001
    ROSS, Timothy Stuart
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    Geschäftsführer
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    EnglandBritish33564830003
    CRITCHLOW, Geoffrey David
    24 Windsor Square
    EX8 1JY Exmouth
    Devon
    Sekretär
    24 Windsor Square
    EX8 1JY Exmouth
    Devon
    British47908530001
    PEAGAM, Garry John
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    Sekretär
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    British64426280002
    PIKE, David Kenneth
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    Sekretär
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    British99914770001
    WELLS, David Francis
    Ashley
    SN13 8AJ Near Box
    Ashley Farmhouse
    Wiltshire
    England
    Sekretär
    Ashley
    SN13 8AJ Near Box
    Ashley Farmhouse
    Wiltshire
    England
    British104366980002
    BONDLAW SECRETARIES LIMITED
    Darwin House
    Southernhay Gardens
    Exeter
    Devon
    Bevollmächtigter Sekretär
    Darwin House
    Southernhay Gardens
    Exeter
    Devon
    900005060001
    ALCOCK, Robert Harding
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Geschäftsführer
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United KingdomBritish9764400003
    BRANDON, John Robert
    28 Marsh Lane
    Mill Hill
    NW7 4QP London
    Geschäftsführer
    28 Marsh Lane
    Mill Hill
    NW7 4QP London
    United KingdomBritish99584240001
    DARKIN, Andrew
    Coombe Road
    Shaldon
    TQ14 0EX Teignmouth
    Broad Reach
    Devon
    Geschäftsführer
    Coombe Road
    Shaldon
    TQ14 0EX Teignmouth
    Broad Reach
    Devon
    United KingdomBritish137575700001
    DAVIES, Mark Dingad
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Geschäftsführer
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    EnglandBritish203044250004
    EVANS, Terence Mervin
    The Cottage Meare Green
    Stoke St Gregory
    TA3 6HY Taunton
    Somerset
    Geschäftsführer
    The Cottage Meare Green
    Stoke St Gregory
    TA3 6HY Taunton
    Somerset
    British47913740001
    HENRY, Robert Michael
    9 Hollydale Drive
    BR2 8QL Bromley
    Kent
    Geschäftsführer
    9 Hollydale Drive
    BR2 8QL Bromley
    Kent
    United KingdomBritish36661900001
    HENRY, Robert Michael
    9 Hollydale Drive
    BR2 8QL Bromley
    Kent
    Geschäftsführer
    9 Hollydale Drive
    BR2 8QL Bromley
    Kent
    United KingdomBritish36661900001
    MCLAUGHLIN, James, Mr.
    Snow Meadow Barn
    Middle Stoughton
    BS28 4PT Wedmore
    Somerset
    Geschäftsführer
    Snow Meadow Barn
    Middle Stoughton
    BS28 4PT Wedmore
    Somerset
    UkBritish107447050001
    MCNAUGHTON, Andrew Robert Paul
    Waddesdon Cottage
    1 Grinstead Lane
    CM22 7QY Little Hallingbury
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Waddesdon Cottage
    1 Grinstead Lane
    CM22 7QY Little Hallingbury
    Hertfordshire
    British53282280004
    PEAGAM, Garry John
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    Geschäftsführer
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    EnglandBritish64426280002
    PIKE, David Kenneth
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    Geschäftsführer
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    EnglandBritish99914770001
    PRICE, Caroline Fiona
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Geschäftsführer
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    EnglandBritish38883480011
    SMITH, Richard David
    Horrells Idestone
    Longdown
    EX6 7BL Exeter
    Devon
    Geschäftsführer
    Horrells Idestone
    Longdown
    EX6 7BL Exeter
    Devon
    British17374050001
    STANDING, Roger
    63 Springwood Road
    TN21 8JX Heathfield
    East Sussex
    Geschäftsführer
    63 Springwood Road
    TN21 8JX Heathfield
    East Sussex
    British47913670001
    TINCKNELL, Mark William
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Geschäftsführer
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    EnglandBritish4088810003
    WELLS, David Francis
    Rosewood House
    Bakers Corner
    SN13 9SY Neston
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Rosewood House
    Bakers Corner
    SN13 9SY Neston
    Wiltshire
    British104366980001
    WILLIAMS, Anthony John
    Foresters Lodge School Lane
    Bawdsey
    IP12 3AR Woodbridge
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Foresters Lodge School Lane
    Bawdsey
    IP12 3AR Woodbridge
    Suffolk
    British81797450001
    BONDLAW DIRECTORS LIMITED
    Darwin House
    Southernhay Gardens
    Exeter
    Devon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Darwin House
    Southernhay Gardens
    Exeter
    Devon
    900005050001

    Hat CONNAUGHT PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A mortgage of shares agreement
    Erstellt am 26. Nov. 2009
    Geliefert am 01. Dez. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First equitable mortgage all the shares.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 11. März 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Mortgage of shares agreement
    Erstellt am 14. Nov. 2009
    Geliefert am 25. Nov. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares including all related rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 11. März 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 14. Nov. 2009
    Geliefert am 24. Nov. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of a first equitable mortgage all shares see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wilmington Trust (London) Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 24. Nov. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 11. März 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 15. Sept. 2009
    Geliefert am 21. Sept. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £1,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Bank deposit of £1,000.00.
    Berechtigte Personen
    • Peter Colby Commercials Limited
    Transaktionen
    • 21. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 06. Aug. 2009
    Geliefert am 25. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the shares and interest in the shares including all related rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. März 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Security agreement
    Erstellt am 06. Aug. 2009
    Geliefert am 25. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Okt. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 11. März 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Shares pledge
    Erstellt am 06. Aug. 2009
    Geliefert am 26. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Pledges and assigns to the security trustee its whole right title interest and benefit in and to the charged assets the shares being 100 shares of £1 each in the share capital of the company the dividends see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes
    Transaktionen
    • 26. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 10. Juli 2009
    Geliefert am 23. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (Note Hedging Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Okt. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 11. März 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Share pledge
    Erstellt am 10. Juli 2009
    Geliefert am 28. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Its whole right, title interest and benefit in to the charged assets:the charged assets means the shares and all stocks being 100 ordinary shares of £1.00 each see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Note Hedging Security Trustee)
    Transaktionen
    • 28. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 10. Juli 2009
    Geliefert am 23. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first equitable mortgage all the shares owned by the chargor or held by any nominee on its behalf in the share capital of each mortgaged company, including any dividend. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Note Hedging Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. März 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Scottish shares pledge
    Erstellt am 10. Juli 2009
    Geliefert am 25. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Whole right title and interest in and to the charged assets being the 100 ordinary shares of £1 each in connaught property services (glasgow) limited and the related rights. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Note Hedging Security Trustee)
    Transaktionen
    • 25. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage of shares agreement
    Erstellt am 19. Okt. 2007
    Geliefert am 31. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the shares and all interest in the shares including all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transaktionen
    • 31. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Share plegde agreement
    Erstellt am 21. Aug. 2007
    Geliefert am 05. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares and all stocks,shares,warrants,securitites,rights,money or property,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 05. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    A security agreement
    Erstellt am 17. Aug. 2007
    Geliefert am 31. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Okt. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 11. März 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    A mortgage of shares agreement
    Erstellt am 17. Aug. 2007
    Geliefert am 31. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the shares owned by it (including all related rights). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. März 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 13. Dez. 2006
    Geliefert am 16. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Security Trustee for Itself and for Each of Thefinance Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 16. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 01. Sept. 2006
    Geliefert am 07. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,000.00 due or to become due from the company to
    Kurze Angaben
    Charge of £1,000.00 deposit account and other monies due under a lease. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Peter Colby Commercials Limited
    Transaktionen
    • 07. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 17. Mai 2004
    Geliefert am 20. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over cash deposit
    Erstellt am 21. Aug. 2002
    Geliefert am 24. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All such sums together with interest and other amounts accruing on such sums for the time being standing to the credit of or allocated to the blocked or designated account number 00899263 of the company with the chargee.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over cash deposit
    Erstellt am 09. Mai 2002
    Geliefert am 10. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All such sums together with all interest and other amounts accruing on such sums for the time being and from time to time standing to the credit of or allocated to the blocked or designated account number 00245061 of the company together with all the present and future right title and benefit of the company whatsoever in the deposit.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over cash deposit
    Erstellt am 28. März 2002
    Geliefert am 13. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Sums for the time being and from time to time standing to the credit of or allocated to the blocked or designated account number 00245061. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Dez. 2000
    Geliefert am 22. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Erstellt am 03. Nov. 2000
    Geliefert am 10. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of deposit
    Erstellt am 01. Juli 1999
    Geliefert am 08. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All deposits now and in the future credited to account desingation 21213201 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or part from such deposits or account.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 26. Juni 1996
    Geliefert am 01. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CONNAUGHT PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Sept. 2010Beginn der Verwaltung
    07. März 2014Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard John Hill
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard Heis
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    DatumTyp
    17. Sept. 2019Abschluss der Liquidation
    05. Feb. 2014Antragsdatum
    25. Feb. 2014Beginn der Liquidation
    04. März 2020Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praktiker
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Richard Heis
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Paul Nicholas Dumbell
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Praktiker
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0