CREDIT & MERCANTILE PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCREDIT & MERCANTILE PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 03186787
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CREDIT & MERCANTILE PLC?

    • Tätigkeit von Hypothekenbanken (64922) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich CREDIT & MERCANTILE PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o BDO
    2 City Place Beehive Ring Road
    London Gatwick Airport
    RH6 0PA Gatwick
    West Sussex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CREDIT & MERCANTILE PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für CREDIT & MERCANTILE PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    4 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2017

    21 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. Apr. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2016

    24 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 07. Mai 2016

    • Kapital: GBP 50,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2015

    19 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Apr. 2015

    Kapitalaufstellung am 16. Apr. 2015

    • Kapital: GBP 50,000
    SH01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift C/O Bdo 2 City Place Beehive Ring Road London Gatwick Airport Gatwick West Sussex RH6 0PA verlegt

    1 SeitenAD04

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom The Grange Market Square Westerham Kent TN16 1HB United Kingdom zum Charlewood House Blackberry Lane Lingfield Surrey RH7 6NG geändert

    1 SeitenAD02

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Susan Marilyn Winston am 06. Apr. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr. Roy George Winston am 06. Apr. 2015

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2014

    18 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Grange Market Square Westerham Kent TN16 1HB zum C/O Bdo 2 City Place Beehive Ring Road London Gatwick Airport Gatwick West Sussex RH6 0PA am 06. Apr. 2015

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mrs Susan Marilyn Winston als Direktor am 30. Juni 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Brennan als Geschäftsführer am 30. Juni 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 02. Mai 2014

    • Kapital: GBP 50,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    17 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Arthur Wolffsohn als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Roy George Winston als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Arthur Wolffsohn als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Änderung der Details des Direktors für Mr. Roy George Winston am 18. Nov. 2013

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr. Roy George Winston am 18. Nov. 2013

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von CREDIT & MERCANTILE PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WINSTON, Roy George
    Domaine De Roqueville
    62/62bis, Bloc A2, 20 Blvd Princesse Charlette
    Monaco
    Domaine De Roqueville
    Mc98000
    Monaco
    Sekretär
    Domaine De Roqueville
    62/62bis, Bloc A2, 20 Blvd Princesse Charlette
    Monaco
    Domaine De Roqueville
    Mc98000
    Monaco
    184059170001
    WINSTON, Roy George, Mr.
    c/o Bdo
    Beehive Ring Road
    London Gatwick Airport
    RH6 0PA Gatwick
    2 City Place
    West Sussex
    England
    Geschäftsführer
    c/o Bdo
    Beehive Ring Road
    London Gatwick Airport
    RH6 0PA Gatwick
    2 City Place
    West Sussex
    England
    MonacoBritish31467850018
    WINSTON, Susan Marilyn
    c/o Bdo
    Beehive Ring Road
    London Gatwick Airport
    RH6 0PA Gatwick
    2 City Place
    West Sussex
    England
    Geschäftsführer
    c/o Bdo
    Beehive Ring Road
    London Gatwick Airport
    RH6 0PA Gatwick
    2 City Place
    West Sussex
    England
    MonacoBritish192668540001
    NORMAN, John Thomas
    13 Pinewood Road
    Branksome Park
    BH13 6JP Poole
    Dorset
    Sekretär
    13 Pinewood Road
    Branksome Park
    BH13 6JP Poole
    Dorset
    British17047090001
    WINSTON, Roy George
    Charlewood House
    Blackberry Lane
    RH7 6NG Lingfield
    Surrey
    Sekretär
    Charlewood House
    Blackberry Lane
    RH7 6NG Lingfield
    Surrey
    British31467850002
    WINSTON, Susan Marilyn
    Charlewood House
    Blackberry Lane
    RH7 6NG Lingfield
    Surrey
    Sekretär
    Charlewood House
    Blackberry Lane
    RH7 6NG Lingfield
    Surrey
    British13454610001
    WINSTON, Susan Marilyn
    Charlewood House
    Blackberry Lane
    RH7 6NG Lingfield
    Surrey
    Sekretär
    Charlewood House
    Blackberry Lane
    RH7 6NG Lingfield
    Surrey
    British13454610001
    WOLFFSOHN, Arthur Mervyn Jackson
    Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    32
    Surrey
    England
    Sekretär
    Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    32
    Surrey
    England
    149725080001
    SAME-DAY COMPANY SERVICES LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Bevollmächtigter Sekretär
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000980001
    BRENNAN, Stephen
    31 The Old Yews
    New Barn
    DA3 7JS Longfield
    Kent
    Geschäftsführer
    31 The Old Yews
    New Barn
    DA3 7JS Longfield
    Kent
    United KingdomBritish206793910001
    MURPHY, Jeremiah Joseph
    Flat 1 67 Chatsworth Road
    NW2 4BG London
    Geschäftsführer
    Flat 1 67 Chatsworth Road
    NW2 4BG London
    Irish80808560001
    RANSHAW, Colin Stuart
    73 Berkeley Court
    Oatlands Drive
    KT13 9HY Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    73 Berkeley Court
    Oatlands Drive
    KT13 9HY Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish77945000001
    WINSTON, Susan Marilyn
    Charlewood House
    Blackberry Lane
    RH7 6NG Lingfield
    Surrey
    Geschäftsführer
    Charlewood House
    Blackberry Lane
    RH7 6NG Lingfield
    Surrey
    United KingdomBritish13454610001
    WOLFFSOHN, Arthur Mervyn Jackson
    32 Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    Surrey
    Geschäftsführer
    32 Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    Surrey
    EnglandBritish27451050001
    SAME-DAY COMPANY SERVICES LIMITED
    Bridge House
    181 Queen Victoria Street
    EC4V 4DZ London
    Geschäftsführer
    Bridge House
    181 Queen Victoria Street
    EC4V 4DZ London
    38974750001
    WILDMAN & BATTELL LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000970001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CREDIT & MERCANTILE PLC?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Roy George Winston
    Blackberry Lane
    RH7 6NG Lingfield
    Charlewood House
    England
    01. Sept. 2016
    Blackberry Lane
    RH7 6NG Lingfield
    Charlewood House
    England
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: Monaco
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat CREDIT & MERCANTILE PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of charge over deposit
    Erstellt am 14. Sept. 2010
    Geliefert am 21. Sept. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Under the terms of the charge with full title guarantee by way of fixed first charge its entire right, title and interest see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Sept. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Charge over deposit
    Erstellt am 15. Apr. 2009
    Geliefert am 18. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Its entire right, title and interest in and to the deposit. All rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Sub charge
    Erstellt am 24. Jan. 2007
    Geliefert am 27. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the company's right, title, interest and benefit, present and future of the principal charge.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 17. Aug. 2006
    Geliefert am 23. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-charge
    Erstellt am 07. Apr. 2006
    Geliefert am 18. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right, title, interest and benefit under and in respect of the principal charge being a charge of all f/h property k/a 2 stag cottages, pheasants hill, hambleden t/n BM307515.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-charge
    Erstellt am 22. März 2006
    Geliefert am 01. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The right title interest and benefit present and future as beneficiary under and in respect of the principal charge.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-charge
    Erstellt am 10. März 2006
    Geliefert am 15. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and benefit in respect of the principal charge being a charge of all that l/h property known as flat 1 42 upper brook street london t/n NGL759764.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-charge
    Erstellt am 10. Feb. 2006
    Geliefert am 16. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title interest and benefit in respect of the principal charge being a charge of all that f/h/l/h property k/a 18 adams row and garage, london.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-charge
    Erstellt am 09. Feb. 2006
    Geliefert am 16. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right and benefit in respect of the principal charge of the l/h property known as flats 4 and 5, 1 shepherd street and 1 white horse street london t/n's NGL810644 and NGL815657,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-charge
    Erstellt am 09. Feb. 2006
    Geliefert am 16. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right and benefit in respect of the principal charge of the l/h property known as flats 2 and 3, 1 shepherd street and 1 white horse street london t/n's NGL810644 and NGL815657,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-charge
    Erstellt am 09. Feb. 2006
    Geliefert am 16. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right and benefit in respect of the principal charge of the l/h property known as flat 1, 1 shepherd street and 1 white horse street london t/n's NGL810644 and NGL815657,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-charge
    Erstellt am 06. Feb. 2006
    Geliefert am 14. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right, title, interest and benefit as beneficiary under and respect of the principal charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-charge
    Erstellt am 26. Jan. 2006
    Geliefert am 03. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H trimpley house bewdley worcestershire t/no WR59126.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-charge
    Erstellt am 20. Jan. 2006
    Geliefert am 26. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and benefit present and future in respect of the principal charge being a charge of the l/h property known as flat 11 50 south audley street london t/n NGL600242.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 26. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-charge
    Erstellt am 09. Dez. 2005
    Geliefert am 15. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All the right, title, interest and benefit in respect of the principal charge being a charge of all that freehold land adjacent to preston house, preston, woodleigh, kingsbridge.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-charge
    Erstellt am 09. Dez. 2005
    Geliefert am 15. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All the right, title, interest and benefit in respect of the principal charge being a charge of all that freehold land k/a preston house, preston, woodleigh, kingsbridge t/no DN371720.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-charge
    Erstellt am 09. Dez. 2005
    Geliefert am 15. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All the right, title, interest and benefit in respect of the principal charge being a charge of all that freehold land at highthorn road and randerson drive, kilnhurst, rotherham t/nos SYK412506, SYK494552 and SYK486098.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-charge
    Erstellt am 08. Nov. 2005
    Geliefert am 15. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The principal charge being a charge of all that f/h property k/a 112 high street,cricklade,swindon.t/n WT211883.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-charge
    Erstellt am 08. Nov. 2005
    Geliefert am 15. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The principal charge being a charge of all that f/h property k/a 35 high street,malmesbury.t/n WT204006.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-charge
    Erstellt am 08. Nov. 2005
    Geliefert am 15. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The principal charge being a charge of all that f/h property k/a 6 oxford street, malmesbury.t/n WT216468.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-charge
    Erstellt am 08. Nov. 2005
    Geliefert am 15. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The principal charge being a charge of all that f/h property k/a 3 oxford street malmesbury t/no WT168415.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub charge
    Erstellt am 08. Nov. 2005
    Geliefert am 15. Nov. 2005
    Ausstehend
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Sub-charge
    Erstellt am 12. Okt. 2005
    Geliefert am 15. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title interest and benefit present and future as beneficiary in respect under and in respect of the principal charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-charge
    Erstellt am 14. Sept. 2005
    Geliefert am 17. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a woodberry down st marys road ascot berkshire.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-charge
    Erstellt am 02. Sept. 2005
    Geliefert am 09. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The right title interest and benefit under and in respect of the the principal charge being a charge of f/h property k/a marks tey hall london road colcheser t/no EX544960 and EX345426.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0