MAM SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMAM SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03188547
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MAM SERVICES LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich MAM SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MAM SERVICES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FORAY 921 LIMITED19. Apr. 199619. Apr. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MAM SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für MAM SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2018

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2017

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Steven John Holmes als Geschäftsführer am 22. Sept. 2017

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Stewart Frank Bradley Baker als Direktor am 21. Sept. 2017

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. Sept. 2016

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Apr. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 27. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 26. Sept. 2015

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    AR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Apr. 2015

    Kapitalaufstellung am 22. Apr. 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Beendigung der Bestellung von James William O'halleran als Geschäftsführer am 02. Apr. 2015

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Steven John Holmes als Direktor am 24. März 2015

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Carys Damon als Sekretär am 23. März 2015

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Steven John Holmes als Sekretär am 23. März 2015

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2014

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 13. Mai 2014

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Sept. 2013

    13 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Sept. 2012

    13 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 24. Sept. 2011

    13 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von MAM SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAMON, Carys
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    196167280001
    BAKER, Stewart Frank Bradley
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish230753770001
    ALBION, Susan
    7 Brownsfield Road
    WS13 6BT Lichfield
    Staffordshire
    Sekretär
    7 Brownsfield Road
    WS13 6BT Lichfield
    Staffordshire
    British80142740001
    HOLMES, Steven John
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    British80455940002
    HYLAND, Matthew William Edward
    29 Highbrow
    Harborne
    B17 9EW Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    29 Highbrow
    Harborne
    B17 9EW Birmingham
    West Midlands
    British43019310004
    OLDHAM, Annette
    Edwards Farm Road
    Fradley
    WS13 8NR Lichfield
    29
    Staffordshire
    Sekretär
    Edwards Farm Road
    Fradley
    WS13 8NR Lichfield
    29
    Staffordshire
    British135120610001
    PAGE, David
    Rye Croft House
    11 Outwoods Lane Anslow
    DE13 9UB Burton On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    Rye Croft House
    11 Outwoods Lane Anslow
    DE13 9UB Burton On Trent
    Staffordshire
    British31059170002
    BEER, Brian Leslie
    52 Meadow View
    Rolleston On Dove
    DE13 9AN Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    52 Meadow View
    Rolleston On Dove
    DE13 9AN Burton On Trent
    Staffordshire
    British61154670001
    BOARDLEY, Richard Owen
    13 Sandalwood Road
    LE11 3PR Loughborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    13 Sandalwood Road
    LE11 3PR Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish48134520001
    CHILDS, Mervyn Peter
    Riverdale
    Lower High Street
    DE13 9LU Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Riverdale
    Lower High Street
    DE13 9LU Burton On Trent
    Staffordshire
    British4619870002
    CHINN, Neil
    12 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    12 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish61154190002
    DAY, John Michael
    27 Newfield Lane
    S17 3DB Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    27 Newfield Lane
    S17 3DB Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish69255730001
    FISHER, Jacqueline
    926 Kingstanding Road
    B44 9NG Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    926 Kingstanding Road
    B44 9NG Birmingham
    West Midlands
    British44103090001
    HARRISON, Gerald Edward
    57 Furlong Lane
    Alrewas
    DE13 7EE Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    57 Furlong Lane
    Alrewas
    DE13 7EE Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish47602430001
    HOLMES, Steven John
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish195545010001
    HOYLE, Russell Blackburn
    5 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    5 Orchard Rise
    TW10 5BX Richmond
    Surrey
    EnglandBritish52822380002
    HYLAND, Matthew William Edward
    29 Highbrow
    Harborne
    B17 9EW Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    29 Highbrow
    Harborne
    B17 9EW Birmingham
    West Midlands
    British43019310004
    LANGLEY, Paul
    9 Besbury Close
    Dorridge
    B93 8NT Solihull
    Geschäftsführer
    9 Besbury Close
    Dorridge
    B93 8NT Solihull
    EnglandBritish99802010001
    MASSEY, Timothy John
    Chestnut Cottage Silver Lane
    Marchington
    ST14 8LL Uttoxeter
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Chestnut Cottage Silver Lane
    Marchington
    ST14 8LL Uttoxeter
    Staffordshire
    United KingdomBritish100259370001
    O'HALLERAN, James William
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    3 The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish103876820003
    PAGE, David
    Rye Croft House
    11 Outwoods Lane Anslow
    DE13 9UB Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Rye Croft House
    11 Outwoods Lane Anslow
    DE13 9UB Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish31059170002
    SIMON, Christopher Neil
    89 Ella Road
    West Bridgford
    NG2 5GZ Nottingham
    Geschäftsführer
    89 Ella Road
    West Bridgford
    NG2 5GZ Nottingham
    EnglandBritish95528490001
    SMITH, Keith Ian
    Wythtree
    Manor Park
    DE13 7JA Kings Bromley
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Wythtree
    Manor Park
    DE13 7JA Kings Bromley
    Staffordshire
    United KingdomBritish40284060002
    WITHERS, Roger Dean
    Ivy Cottage The Green
    Dinton
    HP17 8UP Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Ivy Cottage The Green
    Dinton
    HP17 8UP Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish29586130001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MAM SERVICES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Inspired Gaming (Uk) Limited
    The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton-On-Trent
    3
    Staffordshire
    England
    06. Apr. 2016
    The Maltings
    Wetmore Road
    DE14 1SE Burton-On-Trent
    3
    Staffordshire
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageThe Companies Act 1985 To 1989
    RegistrierungsortUk Register Of Private Limited Companies
    Registrierungsnummer03565640
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat MAM SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of accession and charge
    Erstellt am 08. Juli 2010
    Geliefert am 20. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of its rights title and interest from time to time in respect of any sums payable to it pursuant to the insurance policies, the hedging agreements and any structural intra-group loans see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ares Capital Europe Limited (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 20. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    An accession deed
    Erstellt am 02. Juni 2006
    Geliefert am 12. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Corporate Finance Bank Sas, London Branch (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 12. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 01. Feb. 2005
    Geliefert am 11. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Structured Finance Group Limited 'Security Agent'
    Transaktionen
    • 11. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Jan. 2005
    Geliefert am 11. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Duke Street Capital Iii Limited (The Security Trustee)on Trust for Itself and the Other Vendors
    Transaktionen
    • 11. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture between the company and leisure link group limited and others (as defined) (together known as the "security parties" and individually known as "security party") and duke street capital iii limited (the "security trustee")
    Erstellt am 21. Sept. 2001
    Geliefert am 05. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys, obligations and liabilities covenanted to be paid or discharged by the company to the security trustee in accordance with the vendor loan notes and all obligations and liabilities owing or incurred by the company and each other guaranteed obligor (as defined) to the vendors or any of them under or pursuant to the vendor loan notes and on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Maygay house showell road wolverhampton. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Duke Street Capital Iii Limited
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture between dmwsl 345 limited (the "parent") and leisure link group and certain other subsidiaries of the parent (as defined), including the company as a security party and nib capital bank N.V. ("nib") as security trustee on behalf of itself and the banks and financial institutions from time to time parties to the finance documents
    Erstellt am 21. Sept. 2001
    Geliefert am 03. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company under or pursuant to various documents, letters and agreements (as defined) and all other provisions under this debenture
    Kurze Angaben
    Including the leasehold property known as maygay house,showell rd,wolverhampton; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of amendment and restatement to a composite guarantee and debenture dated 3RD august 1998 (the "deed")
    Erstellt am 26. März 1999
    Geliefert am 10. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness and liabilities and obligations due owing or incurred pursuant to the revolving credit facility, the mezzanine loan facility and that part of the term loan facility not used to repay indebtedness due under the facilities agreement to the chargee by any group company whether actually or contingently, whether pursuant to the guarantee or otherwise
    Kurze Angaben
    L/H unit 6B freshfields industrial estate stevenson road kemp town brighton t/n ESX56825 l/h unit 1 spring meadow trading estate lamby way cardiff t/n WA567171 39 woodall road redburn industrial estate enfield t/n NGL500091 (for further details see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Trustee for the Security Beneficiaries)(the "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 10. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 03. Aug. 1998
    Geliefert am 20. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due pursuant to the revolving credit facility to the security beneficiaries by any group company on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H unit 6B freshfields industrial estate stevenson road kemp town brighton t/n ESX56825 l/h unit 1 spring meadow trading estate lamby way cardiff t/n WA567171 39 woodall road redburn industrial estate enfield t/n NGL500091 for further details of property charged refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0