MAM SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MAM SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03188547 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MAM SERVICES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich MAM SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MAM SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| FORAY 921 LIMITED | 19. Apr. 1996 | 19. Apr. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MAM SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MAM SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven John Holmes als Geschäftsführer am 22. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stewart Frank Bradley Baker als Direktor am 21. Sept. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. Sept. 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 26. Sept. 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | AR01 | |||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von James William O'halleran als Geschäftsführer am 02. Apr. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Steven John Holmes als Direktor am 24. März 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Carys Damon als Sekretär am 23. März 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven John Holmes als Sekretär am 23. März 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2014 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Sept. 2013 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Sept. 2012 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 24. Sept. 2011 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MAM SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMON, Carys | Sekretär | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | 196167280001 | |||||||
| BAKER, Stewart Frank Bradley | Geschäftsführer | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 230753770001 | |||||
| ALBION, Susan | Sekretär | 7 Brownsfield Road WS13 6BT Lichfield Staffordshire | British | 80142740001 | ||||||
| HOLMES, Steven John | Sekretär | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | British | 80455940002 | ||||||
| HYLAND, Matthew William Edward | Sekretär | 29 Highbrow Harborne B17 9EW Birmingham West Midlands | British | 43019310004 | ||||||
| OLDHAM, Annette | Sekretär | Edwards Farm Road Fradley WS13 8NR Lichfield 29 Staffordshire | British | 135120610001 | ||||||
| PAGE, David | Sekretär | Rye Croft House 11 Outwoods Lane Anslow DE13 9UB Burton On Trent Staffordshire | British | 31059170002 | ||||||
| BEER, Brian Leslie | Geschäftsführer | 52 Meadow View Rolleston On Dove DE13 9AN Burton On Trent Staffordshire | British | 61154670001 | ||||||
| BOARDLEY, Richard Owen | Geschäftsführer | 13 Sandalwood Road LE11 3PR Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | 48134520001 | |||||
| CHILDS, Mervyn Peter | Geschäftsführer | Riverdale Lower High Street DE13 9LU Burton On Trent Staffordshire | British | 4619870002 | ||||||
| CHINN, Neil | Geschäftsführer | 12 Newton Park Newton Solney DE15 0SX Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 61154190002 | |||||
| DAY, John Michael | Geschäftsführer | 27 Newfield Lane S17 3DB Sheffield South Yorkshire | England | British | 69255730001 | |||||
| FISHER, Jacqueline | Geschäftsführer | 926 Kingstanding Road B44 9NG Birmingham West Midlands | British | 44103090001 | ||||||
| HARRISON, Gerald Edward | Geschäftsführer | 57 Furlong Lane Alrewas DE13 7EE Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 47602430001 | |||||
| HOLMES, Steven John | Geschäftsführer | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 195545010001 | |||||
| HOYLE, Russell Blackburn | Geschäftsführer | 5 Orchard Rise TW10 5BX Richmond Surrey | England | British | 52822380002 | |||||
| HYLAND, Matthew William Edward | Geschäftsführer | 29 Highbrow Harborne B17 9EW Birmingham West Midlands | British | 43019310004 | ||||||
| LANGLEY, Paul | Geschäftsführer | 9 Besbury Close Dorridge B93 8NT Solihull | England | British | 99802010001 | |||||
| MASSEY, Timothy John | Geschäftsführer | Chestnut Cottage Silver Lane Marchington ST14 8LL Uttoxeter Staffordshire | United Kingdom | British | 100259370001 | |||||
| O'HALLERAN, James William | Geschäftsführer | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | England | British | 103876820003 | |||||
| PAGE, David | Geschäftsführer | Rye Croft House 11 Outwoods Lane Anslow DE13 9UB Burton On Trent Staffordshire | England | British | 31059170002 | |||||
| SIMON, Christopher Neil | Geschäftsführer | 89 Ella Road West Bridgford NG2 5GZ Nottingham | England | British | 95528490001 | |||||
| SMITH, Keith Ian | Geschäftsführer | Wythtree Manor Park DE13 7JA Kings Bromley Staffordshire | United Kingdom | British | 40284060002 | |||||
| WITHERS, Roger Dean | Geschäftsführer | Ivy Cottage The Green Dinton HP17 8UP Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 29586130001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MAM SERVICES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspired Gaming (Uk) Limited | 06. Apr. 2016 | The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton-On-Trent 3 Staffordshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat MAM SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession and charge | Erstellt am 08. Juli 2010 Geliefert am 20. Juli 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of its rights title and interest from time to time in respect of any sums payable to it pursuant to the insurance policies, the hedging agreements and any structural intra-group loans see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An accession deed | Erstellt am 02. Juni 2006 Geliefert am 12. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Feb. 2005 Geliefert am 11. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Jan. 2005 Geliefert am 11. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture between the company and leisure link group limited and others (as defined) (together known as the "security parties" and individually known as "security party") and duke street capital iii limited (the "security trustee") | Erstellt am 21. Sept. 2001 Geliefert am 05. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys, obligations and liabilities covenanted to be paid or discharged by the company to the security trustee in accordance with the vendor loan notes and all obligations and liabilities owing or incurred by the company and each other guaranteed obligor (as defined) to the vendors or any of them under or pursuant to the vendor loan notes and on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Maygay house showell road wolverhampton. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture between dmwsl 345 limited (the "parent") and leisure link group and certain other subsidiaries of the parent (as defined), including the company as a security party and nib capital bank N.V. ("nib") as security trustee on behalf of itself and the banks and financial institutions from time to time parties to the finance documents | Erstellt am 21. Sept. 2001 Geliefert am 03. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company under or pursuant to various documents, letters and agreements (as defined) and all other provisions under this debenture | |
Kurze Angaben Including the leasehold property known as maygay house,showell rd,wolverhampton; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment and restatement to a composite guarantee and debenture dated 3RD august 1998 (the "deed") | Erstellt am 26. März 1999 Geliefert am 10. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness and liabilities and obligations due owing or incurred pursuant to the revolving credit facility, the mezzanine loan facility and that part of the term loan facility not used to repay indebtedness due under the facilities agreement to the chargee by any group company whether actually or contingently, whether pursuant to the guarantee or otherwise | |
Kurze Angaben L/H unit 6B freshfields industrial estate stevenson road kemp town brighton t/n ESX56825 l/h unit 1 spring meadow trading estate lamby way cardiff t/n WA567171 39 woodall road redburn industrial estate enfield t/n NGL500091 (for further details see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 03. Aug. 1998 Geliefert am 20. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due pursuant to the revolving credit facility to the security beneficiaries by any group company on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H unit 6B freshfields industrial estate stevenson road kemp town brighton t/n ESX56825 l/h unit 1 spring meadow trading estate lamby way cardiff t/n WA567171 39 woodall road redburn industrial estate enfield t/n NGL500091 for further details of property charged refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0