LETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | LETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03190147 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich LETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Quadrant House Floor 6 4 Thomas More Square E1W 1YW London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ACRE 105 LIMITED | 29. März 1996 | 29. März 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2022 | 15 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. März 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Alan Pearlman am 18. Juli 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2021 | 15 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. März 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. März 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2020 | 14 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Gulam Mohamed Patel als Geschäftsführer am 30. Juni 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 16 Seiten | AA | ||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. März 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 17 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. März 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 18 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. März 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Howard Alan Pearlman als Direktor am 08. Aug. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 17 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von LETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDBERGER, Michael Robert | Sekretär | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | British | 77295560002 | ||||||
GOLDBERGER, Michael Robert | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | England | British | Company Director | 77295560002 | ||||
PEARLMAN, David Alan | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House Floor 6 | United Kingdom | British | Company Director | 35550120033 | ||||
PEARLMAN, Howard Alan | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House Floor 6 | United Kingdom | British | Property Management | 93460740002 | ||||
COLVIN, Patrick | Sekretär | Great Oaks Hutton CM13 1AZ Brentwood 19 Essex | British | 5954030001 | ||||||
CRICKMORE, Nicola Jane | Sekretär | Brelston Court Barn HR9 6HF Marstow Herefordshire | British | Chartered Accountant | 115328860001 | |||||
HARRIS, Jason Mark | Sekretär | 3 Adelaide Close HA7 3EL Stanmore Middlesex | British | 42831090001 | ||||||
MONJACK, Philip | Sekretär | Whytes Cottage 14 The Warren WD7 7DX Radlett Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 48844070001 | |||||
MONJACK, Richard Wayne | Sekretär | 14 Richards Close Bushey WD2 3JB Watford Hertfordshire | British | Estate Agent | 27762620001 | |||||
LAWSON (LONDON) LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Acre House 11-15 William Road NW1 3ER London | 900000960001 | |||||||
CARLTON PORTER, Robert William | Geschäftsführer | 4 Laggan House College Road BA1 5RY Bath Avon | United Kingdom | British | Director | 67566540006 | ||||
CLAYDON, Katherine Maria | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 74 Hecham Close E17 5QT Walthamstow London | British | 900012160001 | ||||||
COLVIN, Patrick | Geschäftsführer | Great Oaks Hutton CM13 1AZ Brentwood 19 Essex | England | British | Company Director | 5954030001 | ||||
CRICKMORE, Nicola Jane | Geschäftsführer | Brelston Court Barn HR9 6HF Marstow Herefordshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 115328860001 | ||||
GADSDEN, Eric John Spencer | Geschäftsführer | Hawridge Place Hawridge HP5 2UG Chesham Buckinghamshire | England | British | Builder & Property Developer | 13515270003 | ||||
GOLDBERG, Jonathan David | Geschäftsführer | Queenwood 29 Adelaide Close HA7 3EN Stanmore Middlesex | England | British | Company Director | 33727110001 | ||||
HARRIS, Howard | Geschäftsführer | 1 Oaklands Road Totteridge N20 8BD London | British | Company Director | 8500550001 | |||||
HARRIS, Jason Mark | Geschäftsführer | 3 Adelaide Close HA7 3EL Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | Company Director | 42831090001 | ||||
LEWIN, Peter Harry | Geschäftsführer | 1 Wolsey Road Moor Park HA6 2HN Northwood Middlesex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 2652710001 | ||||
MONJACK, Philip | Geschäftsführer | Whytes Cottage 14 The Warren WD7 7DX Radlett Hertfordshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 48844070001 | ||||
MONJACK, Richard Wayne | Geschäftsführer | 14 Richards Close Bushey WD2 3JB Watford Hertfordshire | British | Estate Agent | 27762620001 | |||||
PATEL, Gulam Mohamed | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House Floor 6 | British | Chartered Accountant | 85027050001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First London Group Properties Limited | 06. Apr. 2016 | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat LETCHWORTH GARDEN PROPERTIES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 08. Juni 2012 Geliefert am 19. Juni 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 14 and 16 station road letchworth t/no HD330233 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of rectification to debenture dated 9 may 2007 and | Erstellt am 03. Apr. 2008 Geliefert am 22. Apr. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 09. Mai 2007 Geliefert am 19. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 14 and 16 station road letchworth hertfordshire t/no: HD330233. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 09. Mai 2007 Geliefert am 19. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 13. Apr. 2000 Geliefert am 20. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a 14 and 16 station road,letchworth,hertfordshire.t/no.HD330233.all fixtures and fittings whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached thereto and together with the goodwill of any trade or business carried on now or hereafter at the property by the company.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 29. Aug. 1997 Geliefert am 04. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the terms of the charge | |
Kurze Angaben L/H land and premises k/a 14 and 16 station road letchworth t/n HD330233 and all fixtures fittings plant machinery apparatus goods and materials, all right title and interest in all rental income in respect of the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 29. Aug. 1997 Geliefert am 04. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First floating charge undertaking and assets present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0