BEAUMONT HIRE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BEAUMONT HIRE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03198336 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BEAUMONT HIRE LIMITED?
- (7134) /
Wo befindet sich BEAUMONT HIRE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Woodlands Grange Woodlands Lane Bradley Stoke BS32 4JY Bristol |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BEAUMONT HIRE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BEAUMONT TEMPORARY HEATING HIRE LIMITED | 04. Juni 1996 | 04. Juni 1996 |
| MALTDEAL LIMITED | 14. Mai 1996 | 14. Mai 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BEAUMONT HIRE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BEAUMONT HIRE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2011 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Watkins als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Philip Baden Watkins am 20. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Banks als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2010 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Watkins als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Tonia Watkins am 12. März 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Kevin Gordon Banks am 12. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mark Edward Hills am 12. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Philip Baden Watkins am 12. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Roderick Stanley Williams am 12. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | MG01 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2008 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2007 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2006 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BEAUMONT HIRE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATKINS, Tonia | Sekretär | Church Road GL15 5EL Lydney Ward Industrial Estate Gloucestershire England | British | 65091270001 | ||||||
| HILLS, Mark Edward | Geschäftsführer | Church Road GL15 5EL Lydney Ward Industrial Estate Gloucestershire England | United Kingdom | British | 73804920002 | |||||
| WILLIAMS, Roderick Stanley | Geschäftsführer | Church Road GL15 5EL Lydney Ward Industrial Estate Gloucestershire England | United Kingdom | British | 43026110001 | |||||
| MATON, Sarah Cecilia | Sekretär | Busketts House Busketts Way Ashurst SO40 7AE Southampton | British | 48089930001 | ||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| BANKS, Kevin Gordon | Geschäftsführer | Church Road GL15 5EL Lydney Ward Industrial Estate Gloucestershire England | England | British | 119208710001 | |||||
| MATON, Maurice Edward George | Geschäftsführer | Busketts House Busketts Way SO40 7AE Ashurst Southampton | British | 18807570003 | ||||||
| MATON, Sarah Cecilia | Geschäftsführer | Busketts House Busketts Way Ashurst SO40 7AE Southampton | British | 48089930001 | ||||||
| WATKINS, Philip Baden | Geschäftsführer | Church Road GL15 5EL Lydney Ward Industrial Estate Gloucestershire England | England | British | 39149070001 | |||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Hat BEAUMONT HIRE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 29. Jan. 2010 Geliefert am 03. Feb. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 25. Mai 2003 Geliefert am 13. Juni 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. März 2003 Geliefert am 19. März 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 13. Mai 2002 Geliefert am 28. Mai 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. März 2001 Geliefert am 20. März 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0