BIBBY GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BIBBY GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03198843 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BIBBY GROUP LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich BIBBY GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o BIBBY TRANSMISSIONS Cannon Way WF13 1EH Dewsbury West Yorks |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BIBBY GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TOYBREAK LIMITED | 15. Mai 1996 | 15. Mai 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BIBBY GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BIBBY GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Change of details for The Hay Hall Group Limited as a person with significant control on 10. März 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Mai 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 29. Dez. 2017
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Carl Richard Christenson am 10. Nov. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Graham Varga als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard Ian Laws als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Penelope Turvey als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BIBBY GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAWS, Richard Ian | Sekretär | c/o Bibby Transmissions Cannon Way WF13 1EH Dewsbury West Yorks | 182623450001 | |||||||
| CHRISTENSON, Carl Richard | Geschäftsführer | c/o Altra Industrial Motion Granite Street Braintree 300 Ma02184 United States | United States | American | 110880800002 | |||||
| STORCH, Christian | Geschäftsführer | 12 Preston Square Quincy Massachusetts Ma 02171 United States | United States | German | 126884910001 | |||||
| BALDREY, Philip Nigel | Sekretär | 34 Saint Bernards Road B92 7BB Solihull West Midlands | British | 44039650003 | ||||||
| HALE, Vivien Joan | Sekretär | Keeley 12 Gables Meadow Holmer Green HP15 6RT High Wycombe Buckinghamshire | British | 56115110001 | ||||||
| HORTON, Nathan Jon | Sekretär | 14 North Street Claphamn SW4 0JX London | British | 48030290001 | ||||||
| NEAL, Peter Richard | Sekretär | Coppers Cox Hill Boxford CO10 5HR Sudbury Suffolk | British | 11209680002 | ||||||
| TURVEY, Penelope Ann | Sekretär | 182 High Street PE19 6SD Yelling Cambs | British | 103094630002 | ||||||
| VARGA, Graham | Sekretär | c/o Bibby Transmissions Cannon Way WF13 1EH Dewsbury West Yorks | British | 168160520001 | ||||||
| HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 67382580002 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BALDREY, Philip Nigel | Geschäftsführer | 34 Saint Bernards Road B92 7BB Solihull West Midlands | England | British | 44039650003 | |||||
| BEDDOW, Simon David Jonathan | Geschäftsführer | 91 Elms Crescent SW4 8QF Clapham London | British | 58357770001 | ||||||
| BURDETT, Roger Leonard | Geschäftsführer | 2 Pennyfields Boulevard NG10 3QJ Long Eaton Nottinghamshire | British | 53792200005 | ||||||
| BURDETT, Roger | Geschäftsführer | Yew Tree Cottage Mill Lane Lapworth B94 6HT Solihull West Midlands | British | 53792200004 | ||||||
| GUMIENNY, Marek Stefan | Geschäftsführer | 13 Lambolle Road Belsize Park NW3 4HS London | British | 66370740001 | ||||||
| HALE, Vivien Joan | Geschäftsführer | Keeley 12 Gables Meadow Holmer Green HP15 6RT High Wycombe Buckinghamshire | England | British | 56115110001 | |||||
| HORTON, Nathan Jon | Geschäftsführer | 14 North Street Claphamn SW4 0JX London | British | 48030290001 | ||||||
| MCCORKELL, Henry Nigel Pakenham | Geschäftsführer | The Hatch Gaunts Common BH21 4JB Wimborne Dorset | England | English | 13447260001 | |||||
| RODGER, David Anthony Hugh | Geschäftsführer | Oaktrees Pinley Green CV35 8LU Claverdon Warwickshire | British | 89739630001 | ||||||
| WALL, David Alan | Geschäftsführer | 23 Beech Tree Farm Lane 02066 Scituate Ma 02066 Usa | American | 110839410001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BIBBY GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altra Industrial Motion Uk Limited | 15. Mai 2017 | Cannon Way WF13 1EH Dewsbury Bibby Transmissions Ltd West Yorkshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat BIBBY GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 08. März 2007 Geliefert am 10. März 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed between the company and the governor and company of the bank of scotland (as agent and trustee for itself and other secured parties) | Erstellt am 26. Juli 2001 Geliefert am 02. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under or in connection with the financing documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed between the company and mithras investment trust PLC | Erstellt am 26. Juli 2001 Geliefert am 02. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under or in connection with the financing documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Juli 2000 Geliefert am 25. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any of the financing documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Juli 2000 Geliefert am 25. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any of the financing documents (as defined) | |
Kurze Angaben Land lying to south of mill street west,dewsbury; wyk 165223 and wyk 72667. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 28. Juni 1996 Geliefert am 10. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and any of the other companies named therein (the group companies) to the chargee as agent and trustee for the beneficiaries (as defined) and/or any of the beneficiaries under or in connection with the facilities agreement and/or any other senior finance document | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0