PIAS COOPERATIVE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PIAS COOPERATIVE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03201180 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PIAS COOPERATIVE LIMITED?
- Künstlerische Tätigkeit (90030) / Kunst, Unterhaltung und Erholung
Wo befindet sich PIAS COOPERATIVE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Bevington Path SE1 3PW London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PIAS COOPERATIVE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MIKE RECORDINGS UK LIMITED | 26. Mai 2021 | 26. Mai 2021 |
| PIAS COOPERATIVE LIMITED | 25. März 2014 | 25. März 2014 |
| V2 RECORDS INTERNATIONAL LIMITED | 27. März 2000 | 27. März 2000 |
| VEE TOO LIMITED | 20. Mai 1996 | 20. Mai 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PIAS COOPERATIVE LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für PIAS COOPERATIVE LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 01. Aug. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 15. Aug. 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 01. Aug. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für PIAS COOPERATIVE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2024 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Aug. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Pias Recordings Uk Limited as a person with significant control on 15. Aug. 2025 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Universal Music Group N.V. as a person with significant control on 15. Aug. 2025 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Notification of Universal Music Group N.V. as a person with significant control on 28. Okt. 2024 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Withdrawal of a person with significant control statement on 25. Nov. 2024 | 2 Seiten | PSC09 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michel Joseph Lambot als Geschäftsführer am 28. Okt. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Aug. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Aug. 2023 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed mike recordings uk LIMITED\certificate issued on 26/09/23 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Notification of a person with significant control statement | 2 Seiten | PSC08 | ||||||||||
Cessation of Michel Joseph Lambot as a person with significant control on 02. Jan. 2023 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Cessation of Kenneth Bruno Gates as a person with significant control on 02. Jan. 2023 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 20 Sandown Road Esher Surrey KT10 9TU England zum 1 Bevington Path London SE1 3PW am 25. Sept. 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for Mr Kenneth Bruno Gates as a person with significant control on 01. Nov. 2022 | 2 Seiten | PSC04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Aug. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michel Joseph Lambot am 31. Dez. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Aug. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Notification of Kenneth Bruno Gates as a person with significant control on 18. Mai 2021 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Notification of Michel Joseph Lambot as a person with significant control on 18. Mai 2021 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PIAS COOPERATIVE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARTLEY, Nicholas Bruce | Sekretär | Bevington Path SE1 3PW London 1 England | 179081810001 | |||||||
| GATES, Kenneth Bruno | Geschäftsführer | Bevington Path SE1 3PW London 1 England | Belgium | British | 68764250003 | |||||
| HARTLEY, Nicholas Bruce | Geschäftsführer | Bevington Path SE1 3PW London 1 England | England | British | 49480880002 | |||||
| ABIOYE, Abolanle | Sekretär | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | British | 88802330001 | ||||||
| GLEDHILL, Mary Elizabeth | Sekretär | Crown Cottage 11 Crown Hill Ropsley NG33 4BH Grantham Lincolnshire | British | 60726470001 | ||||||
| GRAM, Peter Gerardus | Sekretär | 9 Lambyn Croft Langshott RH6 9XU Horley Surrey | British | 67245530001 | ||||||
| LEGGE, Diana Patricia | Sekretär | 24a Enderby Street SE10 9PF London | British | 66675910001 | ||||||
| WALE, Charles Patrick John | Sekretär | 4a Shandon Road SW4 9HP London | British | 113737250001 | ||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
| BROWN, Andrew | Geschäftsführer | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | England | British | 163199590001 | |||||
| BURROUGHS, Ian Steven | Geschäftsführer | 26 Mount Close RH10 7EF Crawley West Sussex | United Kingdom | British | 105323210001 | |||||
| CONSTANT, Richard Michael | Geschäftsführer | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | United Kingdom | British | 43836310003 | |||||
| DIXON, Craig Stephen | Geschäftsführer | Florian House Leatherhead Road KT22 0ET Oxshott Surrey | England | British | 105534460001 | |||||
| DOHERTY, Alex John | Geschäftsführer | Avonmore Road Kensington Village W14 8TS London Beaumont House United Kingdom | United Kingdom | British | 177013620001 | |||||
| HARLOW, Antony David | Geschäftsführer | 71 Heathfield Road Wandsworth SW18 2PH London | British | 84908690001 | ||||||
| LAMBOT, Michel Joseph | Geschäftsführer | Bevington Path SE1 3PW London 1 England | Belgium | Belgian | 72569410011 | |||||
| LEGGE, Diana Patricia | Geschäftsführer | 24a Enderby Street SE10 9PF London | British | 66675910001 | ||||||
| MIDDLETON, Stuart John | Geschäftsführer | 51 Cross Oak Road HP4 3EH Berkhamsted Hertfordshire | British | 51224420001 | ||||||
| MUIR, Boyd Johnston | Geschäftsführer | Colorado Avenue Santa Monica 2220 Ca 90404 Usa | United States | British | 172824510001 | |||||
| MURPHY, Stephen Thomas Matthew | Geschäftsführer | 23 The Crescent SW13 0NN London | British | 70496800002 | ||||||
| NAVIN, Stephen William Harding | Geschäftsführer | 24 Bloemfontein Avenue W12 7BL London | United Kingdom | Irish | 110473350001 | |||||
| PEARCE, Jeremy William | Geschäftsführer | 42 Ferry Road Barnes SW13 9PW London | England | British | 22524320001 | |||||
| POLDING, Richard | Geschäftsführer | 154a Shirland Road W9 2BT London | British | 66390750001 | ||||||
| PRICE, Prescott Edwin | Geschäftsführer | 8 Waldron Mews SW3 5BT London | United Kingdom | British | 334617670001 | |||||
| RACKHAM, Jason David | Geschäftsführer | Bevington Path SE1 3PW London 1 England | United Kingdom | British | 173608040001 | |||||
| WILLIAMS, Simon Daniel | Geschäftsführer | 16d Coolhurst Road Crouch End N8 8EL London | England | British | 57255410001 | |||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PIAS COOPERATIVE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pias Recordings Uk Limited | 15. Aug. 2025 | Bevington Path BR5 1AU London 1 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Universal Music Group N.V. | 28. Okt. 2024 | 1217 Ew Hilversum ‘S-Gravelandseweg 80 Netherlands | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Michel Joseph Lambot | 18. Mai 2021 | Bevington Path SE1 3PW London 1 England | Ja | ||||||||||
Nationalität: Belgian Staatsangehörigkeit: Belgium | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Kenneth Bruno Gates | 18. Mai 2021 | Bevington Path SE1 3PW London 1 England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Belgium | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Pias Recordings Ltd | 06. Apr. 2016 | Bevington Path SE1 3PW London 1 Bevington Path England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für PIAS COOPERATIVE LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 02. Jan. 2023 | 28. Okt. 2024 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0