RIBBON HOTELS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | RIBBON HOTELS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03203484 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RIBBON HOTELS LIMITED?
- Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe
Wo befindet sich RIBBON HOTELS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RIBBON HOTELS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LRG HOTELS LIMITED | 26. Mai 2005 | 26. Mai 2005 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS LIMITED | 16. Apr. 2003 | 16. Apr. 2003 |
| SIX CONTINENTS HOTELS LIMITED | 16. Juli 2002 | 16. Juli 2002 |
| POSTHOUSE HOTELS LIMITED | 06. Nov. 1996 | 06. Nov. 1996 |
| POST HOUSES LIMITED | 19. Juli 1996 | 19. Juli 1996 |
| 865TH SHELF TRADING COMPANY LIMITED | 24. Mai 1996 | 24. Mai 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RIBBON HOTELS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für RIBBON HOTELS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 17 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Nov. 2018 | 16 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Justin Bruce Robinson als Geschäftsführer am 14. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 032034840018 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 10 Queen Street Place London EC4R 1AG verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 10 Queen Street Place London EC4R 1AG geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom zum Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR am 22. Dez. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Haysmacintyre Company Secretaries Limited am 18. Dez. 2017 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Patrick Thomas Mabry am 18. Dez. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Michael Teasdale am 18. Dez. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Justin Bruce Robinson am 18. Dez. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom zum 10 Queen Street Place London EC4R 1AG am 18. Dez. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 032034840016 | 5 Seiten | MR05 | ||||||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 032034840018 | 5 Seiten | MR05 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 03. Okt. 2017
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 30 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Sept. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 032034840017 | 5 Seiten | MR05 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RIBBON HOTELS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| MABRY, Patrick Thomas | Geschäftsführer | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | Luxembourg | German | 204005420001 | |||||||||
| TEASDALE, Simon Michael | Geschäftsführer | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | United Kingdom | British | 204008350001 | |||||||||
| COMBEER, Jean Brenda | Sekretär | Robin Hill 3 St Johns Avenue KT22 7HT Leatherhead Surrey | British | 50345500001 | ||||||||||
| ENGMANN, Catherine | Sekretär | 18 Rays Avenue SL4 5HG Windsor Berkshire | British | 92722710002 | ||||||||||
| LOYNES, Paul | Sekretär | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | 203652080001 | |||||||||||
| MASON, Timothy Charles | Sekretär | 231 Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | British | 12314170002 | ||||||||||
| TAUTZ, Helen Jane | Sekretär | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | British | 37564540001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Alison | Sekretär | 27 Valley Road CM11 2BS Billericay Essex | British | 78744290002 | ||||||||||
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED | Sekretär | Ten Bishops Square E1 6EG London Eighth Floor United Kingdom |
| 125623230001 | ||||||||||
| SISEC LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001770001 | |||||||||||
| ALIBONE, Lee Russell | Geschäftsführer | Darnley Lodge 68 Marsh Road HA5 5NQ Pinner Middlesex | British | 53633890001 | ||||||||||
| BAKER, Skardon Francis | Geschäftsführer | St. George Street W1S 1FS London 25 | United Kingdom | American | 196342720001 | |||||||||
| CARTWRIGHT, Stacey Lee | Geschäftsführer | 46 Chiddingstone Road SW6 3TG London | British | 37682070002 | ||||||||||
| CAU, Antoine Edmond Andre | Geschäftsführer | 10a Durward House 31 Kensington Court S8 5BH London | French | 59395250002 | ||||||||||
| COPELAND, Patrick Joseph | Geschäftsführer | 120 Hamilton Terrace NW8 9UT London | United Kingdom | British | 40574670003 | |||||||||
| CROSTON, Francis John | Geschäftsführer | 5 The Laurels Queenborough Lane CM77 7QD Braintree Essex | United Kingdom | British | 65219360003 | |||||||||
| DEMPSEY, Patrick Joseph Anthony | Geschäftsführer | Cuckoo Meadow Little Shardeloes HP7 0EF Old Amersham Buckinghamshire | England | British | 100598030001 | |||||||||
| EKAS, Petra Cecilia Maria | Geschäftsführer | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 169731050002 | |||||||||
| FISH, Andrew John | Geschäftsführer | Cherry Tree Cottage Manor Close KT24 6SA East Horsley Surrey | England | British | 77133450001 | |||||||||
| GRATTON, David Martin | Geschäftsführer | Rosemead 9 Chiltern Hills Road HP9 1PJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | 71901350002 | ||||||||||
| KOLEV, Ivaylo | Geschäftsführer | St. George Street W1S 1FS London 25 | Uk | Bulgarian | 193389430001 | |||||||||
| LOYNES, Paul | Geschäftsführer | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 241370450001 | |||||||||
| MACKENZIE, Lisa Marie | Geschäftsführer | 70 Vassall Road Kennington SW9 6HY London | British | 78059700001 | ||||||||||
| MARTIN, Andrew David | Geschäftsführer | 5 Dalkeith Road AL5 5PP Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | 52743800001 | |||||||||
| MCCARTHY, John Patrick | Geschäftsführer | Regents Park Road NW1 8XL London 120 | United States | 112396050001 | ||||||||||
| MCEWAN, Allan Scott | Geschäftsführer | 29 Kings Road SL4 2AD Windsor Berkshire | United Kingdom | British | 75569660002 | |||||||||
| MITCHELL, Paul Raymond | Geschäftsführer | Waltons Farm Hollygreen Lane HP27 9PL Bledlow Bucks England | England | British | 148147140001 | |||||||||
| MORLEY, Ronald Martin | Geschäftsführer | 8 Pinewood Close SL0 0QT Iver Heath Buckinghamshire | Uk | British | 517180003 | |||||||||
| MORTIMER, David Grant | Geschäftsführer | 8 Manor Park Avenue SP27 9AU Princes Risborough Buckinghamshire | British | 47770480001 | ||||||||||
| NEWMAN, Mark | Geschäftsführer | Flat 7 44 Sloane Street SW1X 9LU London | United Kingdom | Canadian | 62529820001 | |||||||||
| PARROTT, Graham Joseph | Geschäftsführer | Flat 1 27 Redington Road Hampstead NW3 7QY London | British | 6741720003 | ||||||||||
| POSTER, Stephen Michael | Geschäftsführer | 46 Boileau Road W5 3AH London | British | 67532380001 | ||||||||||
| PRINCE, Ryan David | Geschäftsführer | 7a Howick Place SW1P 1DZ London 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 85682450077 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei RIBBON HOTELS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nas Cobalt No.2 Limited | 06. Apr. 2016 | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat RIBBON HOTELS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 08. Dez. 2015 Geliefert am 11. Dez. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Holiday inn glasgow airport, caledonian way west, abbotsinch, paisley t/no REN71989. Enthält eine Negativzusicherung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 03. Dez. 2015 Geliefert am 09. Dez. 2015 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 01. Dez. 2015 Geliefert am 02. Dez. 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung L/H holiday inn basildon cranes farm road basildon t/no.EX303185 and EX437596 for more details please refer to the instrument. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 31. Mai 2013 Geliefert am 11. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung All and whole subjects k/a holiday inn glasgow airport caledonia way west abbotsinch paisley t/n REN71980. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 22. Mai 2013 Geliefert am 04. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 22. Mai 2013 Geliefert am 03. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung F/H the bybrook tavern (public house) canterbury road ashford t/no K278847, l/h holiday inn cranes farm road basildon t/no’s EX303185 and EX437596, l/h basingstoke crest hotel grove road basingstoke t/no HP409820 (ig lease), for details of further properties charged please refer to the form MR01. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 27TH june 2005 and | Erstellt am 27. Juni 2005 Geliefert am 11. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag A standard security which was presented for registration in scotland on 27TH june 2005 and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the tenant's interest in the lease between corporation of the city of glasgow and royal hibernian hotel limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 27TH june 2005 and | Erstellt am 20. Juni 2005 Geliefert am 11. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by an obligor to the senior finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the tenant's interest in the lease between the corporation of the city of glasgow and airport services limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 20. Juni 2005 Geliefert am 28. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H crowne plaza birmingham nec at national exhibition centre birmingham west midlands t/n WM722535 f/h crowne plaza london - heathrow at land and buildings on the west side of stockley road and the north side of cherry lane west drayton t/n NGL160680 f/h holiday inn brentwood at brook street brentwood t/n EX323558 * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Juni 2005 Geliefert am 22. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second supplemantal trust deed | Erstellt am 02. Aug. 1996 Erworben am 05. Sept. 1996 Geliefert am 19. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing £200,000,000 10 per cent. First mortgage debenture stock 2018 of granada group PLC, all further first mortgage debenture stock (together the "stock") and all other amounts payable by granada group PLC | |
Kurze Angaben The various properties as listed on the form 400 inclusive of the kensington close, hotal, london and the excelsior, heathrow.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second supplemental trust deed dated 2 august 1996 but having effect on 5 september 1996 | Erstellt am 02. Aug. 1996 Geliefert am 19. Sept. 1996 Datum des Sicherungsinstruments 02. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | ||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Jan. 1992 Erworben am 05. Sept. 1996 Geliefert am 13. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,800,000 | |
Kurze Angaben All that property at st. Margarets roundabout, southampton road, titchfield, fareham, hampshire together with all hotel buildings thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Okt. 1989 Erworben am 05. Sept. 1996 Geliefert am 13. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,400,000 | |
Kurze Angaben All that piece of land at aylesbury in the couity of buckingham having frontage to the london to birmingham trunk road (A41) (including southern boundary hedge) together with hotel buildings thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. März 1989 Erworben am 05. Sept. 1996 Geliefert am 13. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,700,000 | |
Kurze Angaben All that land situate on the south side od castle street east of commercial road and to the north of railway dock in the city of kingston upon hull together with buildings thereon and k/a the post house hotel t/n HS148908. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Okt. 1988 Erworben am 05. Sept. 1996 Geliefert am 13. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,580,000 | |
Kurze Angaben All that land and buldings on the west side of the guildford and godalming by-pass guildford in the county of surrey together with all buildings thereon k/a the post house hotel guildford t/n SY546878. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Okt. 1988 Erworben am 05. Sept. 1996 Geliefert am 13. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,700,000 | |
Kurze Angaben All land and buildings fronting lonon road, maidstone,kenttogether with all buildings k/a the post house hotel maidstone t/n K99811. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Juni 1985 Erworben am 05. Sept. 1996 Geliefert am 13. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £838,800 | |
Kurze Angaben The L.h parcels of land situate at impington in the county of cambridge together with hotel buildings thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat RIBBON HOTELS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0