I.D.S. LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameI.D.S. LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03204123
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von I.D.S. LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich I.D.S. LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    8 Fusion Court
    Aberford Road
    LS25 2GH Garforth
    Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von I.D.S. LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für I.D.S. LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    10 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Nov. 2022

    10 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Clark Business Recovery Limited 26 York Place Leeds West Yorkshire LS1 2EY zum 8 Fusion Court Aberford Road Garforth Leeds LS25 2GH am 06. Okt. 2022

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Nov. 2021

    10 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Old Orchard Scarsdale Ridge Bardsey Leeds West Yorkshire LS17 9BP England zum C/O Clark Business Recovery Limited 26 York Place Leeds West Yorkshire LS1 2EY am 12. Dez. 2020

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    9 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 18. Nov. 2020

    LRESSP

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2019

    4 SeitenAA

    Change of details for Mr John Rowland Burkitt as a person with significant control on 13. Aug. 2020

    2 SeitenPSC04

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2018

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2017

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2016

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2017 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2015

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 13. Mai 2016

    • Kapital: GBP 200
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr John Rowland Burkitt am 09. Okt. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Howard Roberts am 09. Okt. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Peter Howard Roberts am 09. Okt. 2015

    1 SeitenCH03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Atlas House Quarry Terrace Horsforth West Yorkshire LS18 4EH zum Old Orchard Scarsdale Ridge Bardsey Leeds West Yorkshire LS17 9BP am 09. Okt. 2015

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2014

    4 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von I.D.S. LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROBERTS, Peter Howard
    St. Dunstans Close
    Monks Risborough
    HP27 9BN Princes Risborough
    49
    Buckinghamshire
    England
    Sekretär
    St. Dunstans Close
    Monks Risborough
    HP27 9BN Princes Risborough
    49
    Buckinghamshire
    England
    British30440280001
    BURKITT, John Rowland
    Scarsdale Ridge
    Bardsey
    LS17 9BP Leeds
    Old Orchard
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    Scarsdale Ridge
    Bardsey
    LS17 9BP Leeds
    Old Orchard
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish2936820003
    ROBERTS, Peter Howard
    St. Dunstans Close
    Monks Risborough
    HP27 9BN Princes Risborough
    49
    Buckinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    St. Dunstans Close
    Monks Risborough
    HP27 9BN Princes Risborough
    49
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish30440280002
    HAMILTON ROBERTS, Rosalind
    420 Otley Road
    Adel
    LS16 8AD Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    420 Otley Road
    Adel
    LS16 8AD Leeds
    West Yorkshire
    British42593870001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei I.D.S. LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Peter Howard Roberts
    St. Dunstans Close
    Monks Risborough
    HP27 9BN Princes Risborough
    49
    England
    06. Apr. 2016
    St. Dunstans Close
    Monks Risborough
    HP27 9BN Princes Risborough
    49
    England
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    Mr John Rowland Burkitt
    Aberford Road
    LS25 2GH Garforth
    8 Fusion Court
    Leeds
    06. Apr. 2016
    Aberford Road
    LS25 2GH Garforth
    8 Fusion Court
    Leeds
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat I.D.S. LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Juni 2007
    Geliefert am 05. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the south side of sunbridge road aldermanbury and millergate bradford t/no wyk 160839. assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 22. Juni 2005
    Geliefert am 30. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 24. Feb. 2004
    Geliefert am 25. Feb. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the south side of sunbridge road & millergate aldermanbury bradford west yorkshire t/n WYK160839. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 30. Jan. 2004
    Geliefert am 10. Feb. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)

    Hat I.D.S. LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    18. Aug. 2023Soll aufgelöst werden am
    18. Nov. 2020Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Philip Clark
    26 York Place
    LS1 2EY Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    26 York Place
    LS1 2EY Leeds
    West Yorkshire
    David Nicholas Clark
    26 York Place
    LS1 2EY Leeds
    Praktiker
    26 York Place
    LS1 2EY Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0