I.D.S. LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | I.D.S. LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03204123 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von I.D.S. LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich I.D.S. LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8 Fusion Court Aberford Road LS25 2GH Garforth Leeds |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von I.D.S. LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für I.D.S. LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 10 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Nov. 2022 | 10 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Clark Business Recovery Limited 26 York Place Leeds West Yorkshire LS1 2EY zum 8 Fusion Court Aberford Road Garforth Leeds LS25 2GH am 06. Okt. 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Nov. 2021 | 10 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Old Orchard Scarsdale Ridge Bardsey Leeds West Yorkshire LS17 9BP England zum C/O Clark Business Recovery Limited 26 York Place Leeds West Yorkshire LS1 2EY am 12. Dez. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 9 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for Mr John Rowland Burkitt as a person with significant control on 13. Aug. 2020 | 2 Seiten | PSC04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr John Rowland Burkitt am 09. Okt. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Howard Roberts am 09. Okt. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Peter Howard Roberts am 09. Okt. 2015 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Atlas House Quarry Terrace Horsforth West Yorkshire LS18 4EH zum Old Orchard Scarsdale Ridge Bardsey Leeds West Yorkshire LS17 9BP am 09. Okt. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von I.D.S. LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTS, Peter Howard | Sekretär | St. Dunstans Close Monks Risborough HP27 9BN Princes Risborough 49 Buckinghamshire England | British | 30440280001 | ||||||
| BURKITT, John Rowland | Geschäftsführer | Scarsdale Ridge Bardsey LS17 9BP Leeds Old Orchard West Yorkshire England | England | British | 2936820003 | |||||
| ROBERTS, Peter Howard | Geschäftsführer | St. Dunstans Close Monks Risborough HP27 9BN Princes Risborough 49 Buckinghamshire England | England | British | 30440280002 | |||||
| HAMILTON ROBERTS, Rosalind | Sekretär | 420 Otley Road Adel LS16 8AD Leeds West Yorkshire | British | 42593870001 | ||||||
| YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||
| YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000870001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei I.D.S. LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Peter Howard Roberts | 06. Apr. 2016 | St. Dunstans Close Monks Risborough HP27 9BN Princes Risborough 49 England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr John Rowland Burkitt | 06. Apr. 2016 | Aberford Road LS25 2GH Garforth 8 Fusion Court Leeds | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat I.D.S. LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 27. Juni 2007 Geliefert am 05. Juli 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the south side of sunbridge road aldermanbury and millergate bradford t/no wyk 160839. assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Juni 2005 Geliefert am 30. Juni 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 24. Feb. 2004 Geliefert am 25. Feb. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land on the south side of sunbridge road & millergate aldermanbury bradford west yorkshire t/n WYK160839. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Jan. 2004 Geliefert am 10. Feb. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat I.D.S. LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0