GRESTY ROAD SUPPLIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GRESTY ROAD SUPPLIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03204642 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GRESTY ROAD SUPPLIES LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich GRESTY ROAD SUPPLIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unipart House Cowley OX4 2PG Oxford Oxfordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GRESTY ROAD SUPPLIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| NATIONAL RAILWAY SUPPLIES LIMITED | 22. Mai 1996 | 22. Mai 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GRESTY ROAD SUPPLIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GRESTY ROAD SUPPLIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Darren Peter Leigh als Direktor am 01. Mai 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Chitty als Geschäftsführer am 30. Apr. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Christopher James Weldon als Direktor am 01. Feb. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony John Mourgue als Geschäftsführer am 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jonathan Chitty am 18. Juni 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Jonathan Chitty als Direktor am 01. Juli 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Mark Dessain als Geschäftsführer am 01. Juli 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 22. Dez. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GRESTY ROAD SUPPLIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'BRIEN, Robert Paul David | Sekretär | Unipart House Cowley OX4 2PG Oxford Oxfordshire | 198376900001 | |||||||
| JOHNSTONE, Thomas George | Geschäftsführer | Abbey Farm Cutthorpe Road Cutthorpe S42 7AD Chesterfield Derbyshire | England | British | 68756380002 | |||||
| LEIGH, Darren Peter | Geschäftsführer | Unipart House Cowley OX4 2PG Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 269530910001 | |||||
| WELDON, Christopher James | Geschäftsführer | Garsington Road Cowley OX4 2PG Oxford Unipart House England | England | British | 179274330001 | |||||
| BACHE, Andrew Foster | Sekretär | 249 Manor Way Wistaston CW2 6PH Crewe Cheshire | British | 50757980001 | ||||||
| HEWETT, Peter Graham | Sekretär | White Cottage Church Road Milford GU8 5JB Godalming Surrey | British | 38256370001 | ||||||
| RIMMER, Michael Douglas | Sekretär | 32 Watling Lane Dorchester On Thames OX10 7JG Wallingford Oxfordshire | British | 48355360001 | ||||||
| BACHE, Andrew Foster | Geschäftsführer | 249 Manor Way Wistaston CW2 6PH Crewe Cheshire | British | 50757980001 | ||||||
| CHITTY, Jonathan | Geschäftsführer | Unipart House Cowley OX4 2PG Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 124647410003 | |||||
| DAVIES, Christopher David | Geschäftsführer | 31 Gwenbrook Avenue Beeston NG9 4BA Nottingham Nottinghamshire | England | British | 120247120001 | |||||
| DESSAIN, Paul Mark | Geschäftsführer | 10 High Street Bodicote OX15 4BX Banbury Oxfordshire | United Kingdom | British | 17182840001 | |||||
| HEWETT, Peter Graham | Geschäftsführer | White Cottage Church Road Milford GU8 5JB Godalming Surrey | United Kingdom | British | 38256370001 | |||||
| JACKSON, Graham Martin | Geschäftsführer | Rosemary Cottage Mill Lane Blakenhall CW5 7NP Nantwich Cheshire | England | British | 81735240002 | |||||
| MARCHANT, George Ernest | Geschäftsführer | 21 Barton Knowle DE56 0DE Belper Derbyshire | British | 38257930001 | ||||||
| MOURGUE, Anthony John | Geschäftsführer | Brompton Gates 170 Burley Road BH23 8DE Bransgore Dorset | England | British | 17182830005 | |||||
| ROCHE, Anthony Douglas | Geschäftsführer | 92 High Street Odell MK43 7AS Bedford Bedfordshire | British | 47933180001 | ||||||
| TREWIN, Peter Charles | Geschäftsführer | 37 Surrenden Crescent BN1 6WE Brighton Sussex | England | British | 36742440001 | |||||
| WEBB, Clifford | Geschäftsführer | 119 Congleton Road CW11 1DW Sandbach Cheshire | British | 50758000001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GRESTY ROAD SUPPLIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gresty Road 2005 Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Cowley OX4 2PG Oxford Unipart House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat GRESTY ROAD SUPPLIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 20. Dez. 2004 Geliefert am 04. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of each chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property k/a leeman road, york Y02 4XD t/n NYK189080 and f/h property k/a land and buildings on the east side of gresty road, crewe, t/n CH409204, l/h land k/a land and buildings on the east side of gresty road, crewe, t/n CH409203; fixed charge, all estates or interests in any f/h or l/h property, all buildings, fixtures, fittings, fixed plant and machinery, investments, credit balances, book debts, insurances, other contracts, intellectual property, floating charge all its assets;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rail mortgage | Erstellt am 30. Dez. 2003 Geliefert am 12. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage the freehold property at leeman road york t/n NYK189080 and the freehold property known as land and buildings on the east side of gresty road crewe t/n CH409204 and all buildings fixtures fittings the benefit of any covenants. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge and guarantee | Erstellt am 30. Dez. 2003 Geliefert am 07. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any rail creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Floating charge all assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of variation to an equitable charge | Erstellt am 22. März 2002 Geliefert am 11. Apr. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h land and buildings k/a the service centre at nrs crewe gresty road crewe cheshire t/n CH409204, the service centre site at nrs york leeman road york t/n NYK189080. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Equitable charge | Erstellt am 10. Feb. 1997 Geliefert am 13. Feb. 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under schedule 6 of a share sale and purchase agreement dated 31 january 1997 | |
Kurze Angaben The f/h land and buildings k/a service centre site at nrs crewe gresty road crewe cheshire and service centre site at nrs york leeman road york. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 31. Jan. 1997 Geliefert am 13. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the agreement or otherwise | |
Kurze Angaben Fixed charge all specified debts;and floating charge the floating assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Jan. 1997 Geliefert am 06. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company (as therein defined) to the security beneficiaries (as therein defined) on any account whatsoever and pursuant to the guarantee (as therein defined) or otherwise | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0