SUON CAMBRIDGE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSUON CAMBRIDGE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03205333
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SUON CAMBRIDGE LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich SUON CAMBRIDGE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Capstone House Prospect Park
    Dunston Way, Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SUON CAMBRIDGE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FLORALPINE LIMITED30. Mai 199630. Mai 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SUON CAMBRIDGE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für SUON CAMBRIDGE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Mai 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2019

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Mai 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2018

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Mai 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2017

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Mai 2017 mit Aktualisierungen

    7 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital31. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 31. Mai 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2015

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 01. Juni 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2014

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 02. Juni 2014

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2013

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2009

    6 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von SUON CAMBRIDGE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HUNT, Angela Suzanne
    Prospect Park
    Dunston Way, Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Capstone House
    Sekretär
    Prospect Park
    Dunston Way, Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Capstone House
    British53510230005
    RUMSEY, Nicholas Scott
    Prospect Park
    Dunston Way, Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Capstone House
    Geschäftsführer
    Prospect Park
    Dunston Way, Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Capstone House
    United KingdomBritish49193110002
    WILSON, John Lindley
    Prospect Park
    Dunston Way, Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Capstone House
    Geschäftsführer
    Prospect Park
    Dunston Way, Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Capstone House
    United KingdomBritish8431650002
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Bevollmächtigter Sekretär
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    WILSON, John Lindley
    Birley Farm
    Cutthorpe
    S42 7AY Chesterfield
    Derbyshire
    Sekretär
    Birley Farm
    Cutthorpe
    S42 7AY Chesterfield
    Derbyshire
    British8431650001
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SUON CAMBRIDGE LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr John Lindley Wilson
    Prospect Park
    Dunston Way, Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Capstone House
    06. Apr. 2016
    Prospect Park
    Dunston Way, Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Capstone House
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.
    Mr Nicholas Rumsey
    Prospect Park
    Dunston Way, Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Capstone House
    06. Apr. 2016
    Prospect Park
    Dunston Way, Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Capstone House
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat SUON CAMBRIDGE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge
    Erstellt am 28. Aug. 2001
    Geliefert am 01. Sept. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All or any of the actual or contingent laibilities of the borrower or general partner owed or expressed to be owed to the agent and/or the beneficiaries under the finance documents on the date of the charge or any time thereafter including all or any of the actual or contingent liabilities of the chargor to the agent arising under the charge on the date of the charge or any time thereafter (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage its interest in the property being all that l/h land and property k/a 1-5 trinity street, myrtle road, ipswich t/n SK47714, by way of fixed charge its interest in all fittings, plant, equipment, machinery, tools, vehicles, furniture and other tangible movable property situate on or at the property on the date of the charge or at any time thereafter, all rental income... See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Agent")
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Charge
    Erstellt am 29. Juni 2001
    Geliefert am 17. Juli 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All or any of the present or future or contingent liabilities of the borrower or general partner (both as defined) owed or expressed to be owed to the agent and/or the beneficiaries (as defined) under the finance documents (as defined) and all or any of the present or future actual or contingent liabilities of the company to the agent arising under the debenture
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings to the west of ely road landbeach cambridgeshire - CB163588 and all existing and future fittings plant equipment machinery tools etc and all rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The Agent)
    Transaktionen
    • 17. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage deed
    Erstellt am 13. Nov. 2000
    Geliefert am 22. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings to the west of ely road landbeach t/no: CB163588. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Erstellt am 24. Mai 2000
    Geliefert am 26. Mai 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement.account number 7146513.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage deed
    Erstellt am 08. Nov. 1999
    Geliefert am 20. Nov. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plots 7000 & 8000 cambridge research park ely road cambridge t/no: CB209861. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage deed
    Erstellt am 29. Jan. 1999
    Geliefert am 16. Feb. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that part of the land at cambridge research park new road landbeach cambridge part t/no.CB209861. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Nov. 1997
    Geliefert am 28. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under two facility letters dated 7TH june 1996 and 11TH november 1997 and securing £2,383,612.93 and £1,150,000 respectively
    Kurze Angaben
    Property k/a part of cambridge research park, ely road, waterbeach cambridgeshire (rear site) together with all buildings and fixtures on the property and the proceeds of sale.
    Berechtigte Personen
    • Harmsworth Pension Fund Trustees Limited
    Transaktionen
    • 28. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juni 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Juni 1996
    Geliefert am 11. Juni 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the debenture
    Kurze Angaben
    F/H absolute estate in landbeach marina park ely road waterbeach cambridgeshire t/no. CB186239 and all other interest in property together with debts goodwill uncalled capital and intellectual property rights and all other assets present and future by way of floating charge.
    Berechtigte Personen
    • Precis (1426) Limited
    Transaktionen
    • 11. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Dez. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0