SUON CAMBRIDGE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SUON CAMBRIDGE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03205333 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SUON CAMBRIDGE LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich SUON CAMBRIDGE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Capstone House Prospect Park Dunston Way, Dunston Road S41 9RD Chesterfield |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SUON CAMBRIDGE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| FLORALPINE LIMITED | 30. Mai 1996 | 30. Mai 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SUON CAMBRIDGE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SUON CAMBRIDGE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2019 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2018 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. März 2017 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 7 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2014 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2013 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SUON CAMBRIDGE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNT, Angela Suzanne | Sekretär | Prospect Park Dunston Way, Dunston Road S41 9RD Chesterfield Capstone House | British | 53510230005 | ||||||
| RUMSEY, Nicholas Scott | Geschäftsführer | Prospect Park Dunston Way, Dunston Road S41 9RD Chesterfield Capstone House | United Kingdom | British | 49193110002 | |||||
| WILSON, John Lindley | Geschäftsführer | Prospect Park Dunston Way, Dunston Road S41 9RD Chesterfield Capstone House | United Kingdom | British | 8431650002 | |||||
| DWYER, Daniel John | Bevollmächtigter Sekretär | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
| WILSON, John Lindley | Sekretär | Birley Farm Cutthorpe S42 7AY Chesterfield Derbyshire | British | 8431650001 | ||||||
| DOYLE, Betty June | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 8 The Bartons Elstree Hill North WD6 3EN Elstree Herts | British | 900003960001 | ||||||
| DWYER, Daniel John | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SUON CAMBRIDGE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr John Lindley Wilson | 06. Apr. 2016 | Prospect Park Dunston Way, Dunston Road S41 9RD Chesterfield Capstone House | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Nicholas Rumsey | 06. Apr. 2016 | Prospect Park Dunston Way, Dunston Road S41 9RD Chesterfield Capstone House | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat SUON CAMBRIDGE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge | Erstellt am 28. Aug. 2001 Geliefert am 01. Sept. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All or any of the actual or contingent laibilities of the borrower or general partner owed or expressed to be owed to the agent and/or the beneficiaries under the finance documents on the date of the charge or any time thereafter including all or any of the actual or contingent liabilities of the chargor to the agent arising under the charge on the date of the charge or any time thereafter (all terms as defined) | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage its interest in the property being all that l/h land and property k/a 1-5 trinity street, myrtle road, ipswich t/n SK47714, by way of fixed charge its interest in all fittings, plant, equipment, machinery, tools, vehicles, furniture and other tangible movable property situate on or at the property on the date of the charge or at any time thereafter, all rental income... See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 29. Juni 2001 Geliefert am 17. Juli 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All or any of the present or future or contingent liabilities of the borrower or general partner (both as defined) owed or expressed to be owed to the agent and/or the beneficiaries (as defined) under the finance documents (as defined) and all or any of the present or future actual or contingent liabilities of the company to the agent arising under the debenture | |
Kurze Angaben F/H property k/a land and buildings to the west of ely road landbeach cambridgeshire - CB163588 and all existing and future fittings plant equipment machinery tools etc and all rental income. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 13. Nov. 2000 Geliefert am 22. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land and buildings to the west of ely road landbeach t/no: CB163588. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit agreement to secure own liabilities | Erstellt am 24. Mai 2000 Geliefert am 26. Mai 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement.account number 7146513. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 08. Nov. 1999 Geliefert am 20. Nov. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Plots 7000 & 8000 cambridge research park ely road cambridge t/no: CB209861. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 29. Jan. 1999 Geliefert am 16. Feb. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that part of the land at cambridge research park new road landbeach cambridge part t/no.CB209861. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Nov. 1997 Geliefert am 28. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under two facility letters dated 7TH june 1996 and 11TH november 1997 and securing £2,383,612.93 and £1,150,000 respectively | |
Kurze Angaben Property k/a part of cambridge research park, ely road, waterbeach cambridgeshire (rear site) together with all buildings and fixtures on the property and the proceeds of sale. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Juni 1996 Geliefert am 11. Juni 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the debenture | |
Kurze Angaben F/H absolute estate in landbeach marina park ely road waterbeach cambridgeshire t/no. CB186239 and all other interest in property together with debts goodwill uncalled capital and intellectual property rights and all other assets present and future by way of floating charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0